Actos BORME de Instituto Socio Sanitario Sl
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 30, S 8, H PO 64762, I/A 35(14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 30, S 8, H PO64762, I/A 34 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 30, S 8, H PO64762, I/A 33 (26.07.22).
18 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: GERIATROS SA.Datos registrales. T 4276, L 4276, F 29, S 8, H PO 64762, I/A 32 ( 7.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 29, S 8, H PO 64762, I/A 31(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 27, S 8, H PO 64762, I/A 30(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 27, S 8, H PO 64762, I/A 29(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 26, S 8, H PO 64762, I/A 28 (13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 26, S 8, H PO 64762, I/A 27 ( 7.10.21).
17 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 26, S 8, H PO 64762, I/A 26 ( 8.06.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 26, S 8, H PO 64762, I/A 25(27.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 25, S 8, H PO64762, I/A 24 (26.04.21).
18 de Febrero de 2021Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CENTROS DE DIA SERVIGER SL. SERVIDOS CATERING SL. SERVIGERALMERIA SL. SERVIGER XX1 CENTROS DE DIA SL. SERVIGER XXI VALDEMORO SL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 25, S8, H PO 64762, I/A 23 (10.02.21).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 24, S 8, H PO64762, I/A 22 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 24, S 8, H PO 64762, I/A 21 (18.06.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 24, S 8, H PO 64762, I/A 20 ( 3.04.20).
06 de Febrero de 2020Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 24, S 8, H PO 64762, I/A 19 (31.01.20).
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 24, S 8, H PO 64762, I/A 18 (15.10.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 23, S 8, H PO 64762, I/A 17(16.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 23, S 8, H PO 64762, I/A 16 ( 7.05.19).
09 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 23, S 8, H PO 64762, I/A 15 ( 2.05.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MELON CASTRO MARIA JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 22, S 8, H PO 64762, I/A 13(28.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 23, S 8, H PO 64762, I/A 14 (28.03.19).
01 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 22, S 8, H PO 64762,I/A 12 (22.03.19).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 16, S 8, H PO 64762, I/A 10(18.03.19).
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 19, S 8, H PO 64762, I/A 11(20.03.19).
26 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 15, S 8, H PO 64762, I/A 7
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 15, S 8, H PO 64762, I/A8 (15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;PRIETO DEL RIOSANDRA;GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU;ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 16, S 8, H PO64762, I/A 9 (18.03.19).
22 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 11, S 8, H PO 64762, I/A 4 (13.03.19).
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 14, S 8, H PO 64762, I/A 5 (14.03.19).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 14, S 8, H PO 64762, I/A 6(14.03.19).
20 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: HERNAIZ DEL CAMPO FELIX. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 11, S 8, H PO 64762, I/A 3 (12.03.19).
15 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 BAJOS (VIGO). Datos registrales. T 4270, L 4270, F 1, S 8, H PO 64762,I/A 1 ( 7.02.19).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 3 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales. T4270, L 4270, F 11, S 8, H PO 64762, I/A 2 ( 7.02.19).
29 de Enero de 2019Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GERIATROS SA. Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GONZALEZ MAESTROCARLOS. Vicesecret.: ROMERO RODRIGUEZ ADELA. Consejero: GERO CAPITALIA SL;GARCIA ESPERILLADANIEL;GERONTORIOJA GLOBAL SL;SADORI GLOBAL SL. Presidente: GERO CAPITALIA SL. Vicepresid.: GARCIA ESPERILLADANIEL. Revocaciones. Aud.C.Con.: IN AUDIT GRUPO AUDITOR CONSULTOR SLP. Nombramientos. Adm. Unico:FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 1107 , F 186, S 8, H VA 15892, I/A 12(22.01.19).
31 de Enero de 2017Nombramientos. Aud.C.Con.: IN AUDIT GRUPO AUDITOR CONSULTOR SLP. Datos registrales. T 1107 , F 186, S 8, H VA 15892,I/A 11 (24.01.17).
21 de Marzo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 832,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.032,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.728,00 Euros.Resultante Suscrito: 5.760,00 Euros. Datos registrales. T 1107 , F 110, S 8, H VA 15892, I/A 10 (14.03.16).
24 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Auditor: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1107 , F 110, S 8, H VA 15892, I/A 8 (17.12.15).
Ceses/Dimisiones. Aud.C.Con.: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1107 , F 110, S 8, H VA 15892, I/A 9 (17.12.15).
22 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTEGA MESA DIEGO;ROMERO RODRIGUEZ ADELA;GARCIA ESPERILLA DANIEL;HERNAIZDEL CAMPO FELIX;GIMENO LLERENA GABRIEL. Presidente: ORTEGA MESA DIEGO. Vicepresid.: ROMERO RODRIGUEZ ADELA.Nombramientos. Consejero: GERO CAPITALIA SL;GARCIA ESPERILLA DANIEL;GERONTORIOJA GLOBAL SL;SADORI GLOBALSL. Presidente: GERO CAPITALIA SL. Vicepresid.: GARCIA ESPERILLA DANIEL. Vicesecret.: ROMERO RODRIGUEZ ADELA.Reelecciones. SecreNoConsj: GONZALEZ MAESTRO CARLOS. Cambio de domicilio social. C/ ALFONSO X 2 BAJO B(ARROYO DE LA ENCOMIENDA). Datos registrales. T 1107 , F 110, S 8, H VA 15892, I/A 7 (15.04.15).
22 de Agosto de 2013Nombramientos. Auditor: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1107 , F 109, S 8, H VA 15892, I/A 5 (14.08.13).
Nombramientos. Aud.C.Con.: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1107 , F 110, S 8, H VA 15892, I/A 6 (14.08.13).
06 de Febrero de 2013P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PRIETO ESTEBAN CRISTINA. Nombramientos.SecreNoConsj: GONZALEZ MAESTRO CARLOS. Consejero: ORTEGA MESA DIEGO;ROMERO RODRIGUEZ ADELA;GARCIAESPERILLA DANIEL;HERNAIZ DEL CAMPO FELIX;GIMENO LLERENA GABRIEL. Presidente: ORTEGA MESA DIEGO. Vicepresid.:ROMERO RODRIGUEZ ADELA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social. C/ MONASTERIO SAN PEDRO DE ALCANTARA 117 (VALLADOLID).Cambio de objeto social. La promoci贸n, construcci贸n, explotaci贸n y gesti贸n, as铆 como el asesoramiento a terceros y el equipamientode residencias para personas de la tercera edad y/o con minusval铆as o incapacidades, asistidas, no asistidas y mixtas,tanto paraestancias permanente como temporales, as铆 como de residencias de. Datos registrales. T 1107 , F 109, S 8, H VA 15892, I/A 3(30.01.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTEGA MESA DIEGO;HERNAIZ DEL CAMPO FELIX. Datos registrales. T 1107 , F 109, S 8, H VA15892, I/A 4 (30.01.13).
04 de Julio de 2011Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PRIETO ESTEBAN CRISTINA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MESADIEGO. Nombramientos. Adm. Unico: PRIETO ESTEBAN CRISTINA. Ampliacion del objeto social. La realizaci贸n de todo tipo detrabajos y actividades relacionadas con la construcci贸n, obras, reparaciones y rehabilitaci贸n de edificaciones de todas clases. Cambiode domicilio social. C/ GENERAL RUIZ 2 1潞 DR (VALLADOLID). Datos registrales. T 1107 , F 108, S 8, H VA 15892, I/A 2(22.06.11).