Buscador CIF Logo

Actos BORME Integra Ascensores Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Integra Ascensores Sl

Actos BORME Integra Ascensores Sl - B83336891

Tenemos registrados 30 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Integra Ascensores Sl con CIF B83336891

馃敊 Perfil de Integra Ascensores Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Integra Ascensores Sl

27 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: GARCIA JAUREGUI LOREA;LUCAS HERNANDEZ AMALIA;MELERO MORENO DAVID;LOPEZGUTIERREZ DIEGO MANUEL;CANO ABELLA TAMARA. Datos registrales. T 43374 , F 91, S 8, H M 307828, I/A 32 (20.11.23).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ PEREZ CARMEN. Datos registrales. T 43374 , F 91, S 8, H M 307828, I/A 33 (20.11.23).

10 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: MARTIN FRUTOS JOSE MARIA;SIMON FRANCO JUAN PABLO;MARQUES PENEDO JOAO-MIGUEL;MARQUES PENEDO JOAO-MIGUEL;ALJAN MU脩OZ ANTONIO;MARTINEZ PEREDA PABLO;PEREZ GARCIARAQUEL;AZTARAIN RODRIGUEZ IGNACIO JOSE;DIAZ CARO ROSALIA;MARTINEZ VALLEJO CONSUELOApo.Sol.: LOPEZPICON MARTA. Apo.Manc.: GONZALEZ POLANCO ALVARO. Datos registrales. T 43374 , F 90, S 8, H M 307828, I/A 31 ( 3.03.23).

09 de Febrero de 2023
Otros conceptos: COMUNICACION FALTA EMISION INFORME AUDITOR OBLIGATORIO. Datos registrales. T 43374 , F 90, S 8,H M 307828, I/A 30M ( 2.02.23).

17 de Enero de 2023
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 43374 , F 90, S 8, H M 307828, I/A 30 (10.01.23).

23 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: PEREZ BOHORQUEZ CARMEN MARIA. Datos registrales. T 43374 , F 86, S 8, H M 307828, I/A 24(16.11.22).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DIEGO PEDRO. Datos registrales. T 43374 , F 87, S 8, H M 307828, I/A 25 (16.11.22).

Nombramientos. Apoderado: MONTEAGUDO ALMAGRO JAVIER. Datos registrales. T 43374 , F 87, S 8, H M 307828, I/A 26(16.11.22).

Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ FERNANDEZ GONZALO. Datos registrales. T 43374 , F 88, S 8, H M 307828, I/A 27(16.11.22).

Nombramientos. Apoderado: CARDAMA CID ANTONIO. Datos registrales. T 43374 , F 89, S 8, H M 307828, I/A 28 (16.11.22).

Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ SANTIAGO AINARA. Datos registrales. T 43374 , F 90, S 8, H M 307828, I/A 29(16.11.22).

06 de Julio de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ PEREDA PABLO. Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ TENA JAVIER. Datos registrales.T 43374 , F 85, S 8, H M 307828, I/A 23 (29.06.22).

15 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: DEL VAL TRILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 43374 , F 85, S 8, H M 307828, I/A 22 ( 8.06.22).

09 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ POLANCO ALVARO;AZTARAIN RODRIGUEZ IGNACIO JOSE;MARTINEZ VALLEJOMARIA CONSUELO;DIAZ CARO ROSALIA;MARTINEZ PEREDA PABLO;ALJAN MU脩OZ ANTONIO;PEREZ GARCIA RAQUEL.Datos registrales. T 37917 , F 35, S 8, H M 307828, I/A 21 ( 2.03.22).

02 de Diciembre de 2021
Cambio de domicilio social. C/ TOMAS REDONDO 2 - NAVE 4-10 (MADRID). Datos registrales. T 37917 , F 34, S 8, H M 307828,I/A 20 (25.11.21).

17 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ NOHALES ANTONIO. Datos registrales. T 37917 , F 33, S 8, H M 307828, I/A 19 (10.09.21).

24 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: BILBAO ANTON FRANCISCO;PEREZ GARCIA RAQUEL;AZTARAIN RODRIGUEZ JOSEIGNACIO;AZTARAIN RODRIGUEZ JOSE IGNACIO;MARTINEZ VALLEJO MARIA CONSUELO;DIAZ CARO ROSALIA;MARTINEZPEREDA PABLO;ALJAN MU脩OZ ANTONIO;PEREZ GARCIA RAQUEL. Apoderado: BILBAO ANTON FRANCISCO. Datosregistrales. T 37917 , F 32, S 8, H M 307828, I/A 18 (16.03.21).

09 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: AVILA MU脩OZ JOSE MARIA;LOPEZ PICON MARTA. Datos registrales. T 37917 , F 30, S 8, H M307828, I/A 15 ( 2.02.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ PEREZ VICTOR MANUEL;GONZALEZ PAZ MERCEDES. Datos registrales. T 37917 , F 31,S 8, H M 307828, I/A 16 ( 2.02.21).

Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/11. Datos registrales. T 37917 , F 32, S 8, H M 307828, I/A 17 (2.02.21).

19 de Agosto de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: MARQUES PENEDO JOAO-MIGUEL;ALJAN MU脩OZ ANTONIO;MARTIN FRUTOS JOSE MARIA;ALJANMU脩OZ ANTONIO;MARTINEZ VALLEJO CONSUELO;PEREZ GARCIA RAQUEL;AZTARAIN RODRIGUEZ JOSEIGNACIO;AZTARAIN RODRIGUEZ JOSE IGNACIO. Nombramientos. Apoderado: MARQUES PENEDO JOAO-MIGUEL;ALJANMU脩OZ ANTONIO;MARTINEZ PEREDA PABLO;PEREZ GARCIA RAQUEL;AZTARAIN RODRIGUEZ IGNACIO JOSE;DIAZ CAROROSALIA;MARTINEZ VALLEJO CONSUELO. Datos registrales. T 37917 , F 29, S 8, H M 307828, I/A 14 (12.08.20).

05 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: MARQUES PENEDO JOAO-MIGUEL. Datos registrales. T 37917 , F 29, S 8, H M 307828, I/A 13(27.02.20).

30 de Agosto de 2019
Modificaciones estatutarias. Nueva redacci贸n de los Estatutos sociales. Cambio de domicilio social. AVDA DE BETANZOS 72,LOCAL 3 (MADRID). Cambio de objeto social. a) La instalaci贸n, montaje, reparaci贸n, conservaci贸n, mantenimiento y venta demotores, ascensores, elevadores, montacargas, plataformas, escaleras y andenes m贸viles, mangas de evacuaci贸n vertical,telef茅ricos,puertas autom谩ticas ypuertas de garaje, y/o elementos de accesibilidad, ayudas t茅cnicas .. Datos registrales. T 37917 , F26, S 8, H M 307828, I/A 12 (23.08.19).

01 de Julio de 2019
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/11. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 7陋, el cambiode cierre de ejercicio, siendo la nueva fecha de cierre de ejercicio la de 30 de noviembre. Datos registrales. T 17842 , F 59, S 8, H M307828, I/A 7 (20.07.18).

27 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORIVE ANDA JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: CONSERVACION DE APARATOSELEVADORES EXPRESS SL. Representan: BARQUIN ARMERO FRANCISCO JAVIER. Modificaciones estatutarias.MODIFICACION DEL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 17842 , F 59, S 8, H M 307828, I/A 7(20.07.18).

Nombramientos. Apoderado: MARTIN FRUTOS JOSE MARIA. Datos registrales. T 17842 , F 60, S 8, H M 307828, I/A 8(20.07.18).

Nombramientos. Apoderado: SIMON FRANCO JUAN PABLO. Datos registrales. T 17842 , F 61, S 8, H M 307828, I/A 9 (20.07.18).

Nombramientos. Apo.Manc.: MARQUES PENEDO JOAO-MIGUEL;ALJAN MU脩OZ ANTONIO;MARTIN FRUTOS JOSEMARIA;ALJAN MU脩OZ ANTONIO;MARTINEZ VALLEJO CONSUELO;PEREZ GARCIA RAQUEL;AZTARAIN RODRIGUEZ JOSEIGNACIO;AZTARAIN RODRIGUEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 17842 , F 62, S 8, H M 307828, I/A 10 (20.07.18).

Nombramientos. Apoderado: LUCAS HERNANDEZ AMALIA;MELERO MORENO DAVID;CANO ABELLA TAMARA;GARCIAJAUREGUI LOREA FATIMA. Datos registrales. T 17842 , F 62, S 8, H M 307828, I/A 11 (20.07.18).

29 de Junio de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 288.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.020,00 Euros. Datos registrales. T 17842 , F58, S 8, H M 307828, I/A 6 (21.06.18).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n