Buscador CIF Logo

Actos BORME Integracion Agencias De Viajes Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Integracion Agencias De Viajes Sa

Actos BORME Integracion Agencias De Viajes Sa - A84523505

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Integracion Agencias De Viajes Sa con CIF A84523505

馃敊 Perfil de Integracion Agencias De Viajes Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Integracion Agencias De Viajes Sa

19 de Julio de 2023
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: VIAJES ARIZONA SA. CENTRAL DE VIAJES SL. Datos registrales. T 37367 , F206, S 8, H M 393290, I/A 36 (12.07.23).

29 de Mayo de 2023
Nombramientos. Aud.C.Con.: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 37367 , F 205, S 8, H M 393290, I/A 35

24 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: DE GUZMAN SAMPER DAVID. Datos registrales. T 37367 , F 204, S 8, H M 393290, I/A 33(17.06.22).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ HERRANZ MARIA-LOURDES. Datos registrales. T 37367 , F 205, S 8, H M 393290, I/A 34(17.06.22).

17 de Junio de 2021
Reelecciones. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 37367 , F 204, S 8, H M 393290, I/A 32 (10.06.21).

26 de Enero de 2021
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: VIAJES VILLA DE MADRID SL. Nombramientos. Consejero: MU脩OZ MU脩OZ ANGEL.Con.Delegado: MU脩OZ MU脩OZ ANGEL. Reelecciones. Secretario: DE GUZMAN SAMPER DAVID M. Presidente: VIAJES VILLADE MADRID SL. Datos registrales. T 37367 , F 204, S 8, H M 393290, I/A 31 (19.01.21).

12 de Marzo de 2020
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 214.320,00 Euros. Desembolsado: 214.320,00 Euros. Resultante Suscrito: 939.842,55 Euros.Resultante Desembolsado: 939.842,55 Euros. Otros conceptos: REDENOMINADADAS LAS ACCIONES DE LA COMPA脩IA. Datosregistrales. T 37367 , F 202, S 8, H M 393290, I/A 30 ( 5.03.20).

02 de Marzo de 2020
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MELI VIAJES SL. VIAJES SANDRA'S SA. VILA Y PEREIRA SL. Datos registrales.T 29362 , F 196, S 8, H M 393290, I/A 29 (24.02.20).

25 de Noviembre de 2019
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: APLICACIONES SOFTWARE DE GESTION SL. Datos registrales. T 29362 , F 192,S 8, H M 393290, I/A 28 (18.11.19).

10 de Julio de 2019
Reelecciones. Consejero: VIAJES VILLA DE MADRID SA;INCENTIVOS GESTION & OCIO SL;VIAJES JUVENTOUR SA;TOPTOURS SA;VERDE Y VIOLETA SL. Presidente: VIAJES VILLA DE MADRID SA. Con.Delegado: VIAJES VILLA DE MADRID SA.Representan: MU脩OZ FERNANDEZ TRINIDAD;VELASCO MORENO MARIA LUZ;MU脩OZ FERNANDEZ JOSEFA;GARCIA LOZANOJOSE LUIS;FRUTOS RUIZ NATALIA ELENA. Datos registrales. T 29362 , F 191, S 8, H M 393290, I/A 27 ( 3.07.19).

10 de Abril de 2018
Nombramientos. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 29362 , F 191, S 8, H M 393290, I/A 26 ( 2.04.18).

30 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: MU脩OZ FERNANDEZ TRINIDAD;PRIETO OTERO JOSE LUIS;GARCIA LOZANO JOSE LUIS.Apoderado: GARCIA LOZANO JOSE LUIS;VELASCO MORENO MARIA LUZ;FRUTOS RUIZ NATALIA ELENA;GARCIA LOZANOJOSE LUIS;PRIETO OTERO JOSE LUIS;BARBERO MAQUEDA JOSE LUIS;MU脩OZ FERNANDEZ TRINIDAD;OLIVA DE LA SERNARAMON DAMASO;MU脩OZ FERNANDEZ TRINIDAD. Datos registrales. T 29362 , F 190, S 8, H M 393290, I/A 25 (20.10.17).

12 de Abril de 2017
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 58.010,00 Euros. Desembolsado: 58.010,00 Euros. Resultante Suscrito: 725.522,55 Euros.Resultante Desembolsado: 725.522,55 Euros. Modificaciones estatutarias. SE ACUERDA LA APROBACION DEL TEXTOREFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DERIVADOS DE LA FUSION Y ESPECIALMENTE EL N潞 5.-. Cambio de domiciliosocial. C/ DOCTOR ESQUERDO 136 7陋 (MADRID). Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: S. F. BOHARQUE Y GARCIAASESORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 29362 , F 152, S 8, H M 393290, I/A 24 ( 4.04.17).

03 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: FRUTOS RUIZ NATALIA ELENA. Datos registrales. T 29362 , F 151, S 8, H M 393290, I/A 23(24.02.17).

06 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apoderado: VELASCO MORENO MARILUZ. Datos registrales. T 29362 , F 150, S 8, H M 393290, I/A 22(26.01.17).

Nombramientos. Apoderado: LOSADA VARELA JOSE MIGUEL;MOURI脩O GOMEZ MOISES. Datos registrales. T 29362 , F 150,S 8, H M 393290, I/A 21 (26.01.17).

20 de Enero de 2015
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ FERNANDEZ TRINIDAD. Datos registrales. T 29362 , F 149, S 8, H M 393290, I/A 20(12.01.15).

19 de Noviembre de 2014
Reelecciones. Auditor: AUDITORES CINCO SL. Datos registrales. T 29362 , F 149, S 8, H M 393290, I/A 19 (11.11.14).

18 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Con.Delegado: VIAJES VILLA DE MADRID SA. Datos registrales. T 29362 , F 149, S 8, H M 393290, I/A 18(11.09.14).

13 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MU脩OZ FERNANDEZ JOSEFA;VELASCO MORENO MARIA LUZ;GARCIA LOZANO JOSELUIS;FRUTOS RUIZ NATALIA. Presidente: MU脩OZ FERNANDEZ JOSEFA. Vicepresid.: GARCIA LOZANO JOSE LUIS.Con.Delegado: MU脩OZ FERNANDEZ JOSEFA. Nombramientos. Representan: MU脩OZ FERNANDEZ TRINIDAD;GARCIALOZANO JOSE LUIS;MU脩OZ FERNANDEZ JOSEFA;FRUTOS RUIZ NATALIA. Consejero: VIAJES VILLA DE MADRIDSA;INCENTIVOS GESTION & OCIO SL;VIAJES JUVENTOUR SA;TOP TOURS SA;VERDE Y VIOLETA SL. Presidente: VIAJESVILLA DE MADRID SA. Representan: VELASCO MORENO MARIA LUZ. Reelecciones. Secretario: DE GUZMAN SAMPER DAVIDM. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 17潞, Y 24潞 E INTRUDOCIDOS NUEVOS LOS 17潞 BIS Y 26潞 BISDE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.IAG7viajes.com.Datos registrales. T 29362 , F 147, S 8, H M 393290, I/A 17 ( 4.08.14).

05 de Marzo de 2012
Reelecciones. Auditor: AUDITORES CINCO SL. Datos registrales. T 22054 , F 43, S 8, H M 393290, I/A 16 (22.02.12).

16 de Junio de 2011
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 273.000,00 Euros. Desembolsado: 273.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 667.513,00 Euros.Resultante Desembolsado: 667.513,00 Euros. Datos registrales. T 22054 , F 43, S 8, H M 393290, I/A 15 ( 7.06.11).

24 de Febrero de 2010
Ampliacion del objeto social. ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y ORGANIZACION DECONGRESOS, REUNIONES, INCENTIVOS Y TODO TIPO DE EVENTOS. Datos registrales. T 22054 , F 42, S 8, H M 393290, I/A14 (12.02.10).

14 de Abril de 2009
Nombramientos. Auditor: AUDITORES CINCO SL. Datos registrales. T 22054 , F 42, S 8, H M 393290, I/A 13 (31.03.09).

08 de Abril de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: FRUTOS RUIZ NATALIA;BARBERO MAQUEDA JOSE LUIS;MU脩OZ FERNANDEZ JOSEFA.Presidente: MU脩OZ FERNANDEZ JOSEFA. Consejero: MU脩OZ FERNANDEZ TRINIDAD;PRIETO OTERO JOSE LUIS. Secretario:BARBERO MAQUEDA JOSE LUIS. Consejero: MARTIN LOPEZ MARIA CRISTINA;GARCIA LOZANO JOSE LUIS. Co.De.Ma.So:GARCIA LOZANO JOSE LUIS;MU脩OZ FERNANDEZ JOSEFA. Nombramientos. Consejero: MU脩OZ FERNANDEZJOSEFA;VELASCO MORENO MARIA LUZ;GARCIA LOZANO JOSE LUIS;FRUTOS RUIZ NATALIA. Presidente: MU脩OZFERNANDEZ JOSEFA. Vicepresid.: GARCIA LOZANO JOSE LUIS. Con.Delegado: MU脩OZ FERNANDEZ JOSEFA. SecreNoConsj:DE GUZMAN SAMPER DAVID M. Apoderado: GARCIA LOZANO JOSE LUIS;VELASCO MORENO MARIA LUZ;FRUTOS RUIZNATALIA;GARCIA LOZANO JOSE LUIS;PRIETO OTERO JOSE LUIS;BARBERO MAQUEDA JOSE LUIS;MU脩OZ FERNANDEZTRINIDAD;OLIVA DE LA SERNA RAMON DAMASO. Otros conceptos: Se modifica el articulo 20, 23, 25, 26 , 28 de los EstatutosSociales. Datos registrales. T 22054 , F 40, S 8, H M 393290, I/A 12 (30.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n