Buscador CIF Logo

Actos BORME Intelligent Atlas Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Intelligent Atlas Sl

Actos BORME Intelligent Atlas Sl - B65391328

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Intelligent Atlas Sl con CIF B65391328

馃敊 Perfil de Intelligent Atlas Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Intelligent Atlas Sl

01 de Diciembre de 2023
Revocaciones. CONSEJERO: ARCE HIDALGO VALENTIN;FERNANDEZ SACRISTAN MARTA. Nombramientos. CONSEJERO:GARCIA PEREZ ANA MARIA;SEISDEDOS CORTES JAVIER. Datos registrales. T 45111 , F 135, S 8, H B 400543, I/A 22(22.11.23).

27 de Abril de 2023
Ampliaci贸n de capital. Capital: 155.232,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.203.050,00 Euros. Datos registrales. T 45111 , F 134, S 8,H B 400543, I/A 21 (20.04.23).

28 de Septiembre de 2022
Ampliaci贸n de capital. Capital: 285.768,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.047.818,00 Euros. Datos registrales. T 45111 , F 132, S 8,H B 400543, I/A 20 (20.09.22).

27 de Julio de 2022
Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL NUM.431 BIS P.1 (BARCELONA). Datos registrales. T 45111 , F 132, S 8, H B400543, I/A 19 (19.07.22).

04 de Abril de 2022
Revocaciones. CONS. DELEG.: FALCON MARTINEZ DE MARA脩ON LUIS F. Nombramientos. DTOR.GENERAL: TORTMARTORELL LLABRES PEDRO. APOD.SOL/MAN: SEISDEDOS CORTES JAVIER;SILVIA BANCHINI;FALCON MARTINEZ DEMARA脩ON LUIS FERNANDO Datos registrales. T 45111 , F 130, S 8, H B 400543, I/A 18 (25.03.22).

15 de Marzo de 2022
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 8, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES YADICION A LOS MISMOS DE LOS ARTICULOS 12 BIS, 13 BIS, 13 TER Y 14 BIS. Datos registrales. T 45111 , F 128, S 8, H B400543, I/A 17 ( 7.03.22).

25 de Febrero de 2022
Ampliaci贸n de capital. Capital: 304.979,00 Euros. Resultante Suscrito: 381.025,00 Euros. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 7.-SUPRESION DE CLASES DE PARTICIPACIONES. Datos registrales. T 45111 , F 126, S 8, H B 400543, I/A 15(15.02.22).

Revocaciones. SECRETARIO: FALCON MARTINEZ DE MARA脩ON LUIS F. CONSEJERO: ELSA CRISTINA MERCEDESHOFMANN. Nombramientos. CONSEJERO: SILVIA BANCHINI;MARTINEZ ALCARAZ CONRADO;ARCE HIDALGOVALENTIN;FERNANDEZ SACRISTAN MARTA. SECR.NO CONS: TORO GARCIA MARIA PIA. Ampliaci贸n de capital. Capital:

20 de Abril de 2021
Otros conceptos: SE RECTIFICA LA INSCRIPCION 9 EN CUANTO A LA NUMERACION DE LAS PARTICIPACIONES DE"SUCESODRES DE W.HOFMANN, SL", TRAS EL AUMENTO DE CAPITAL. Datos registrales. T 45111 , F 126, S 8, H B 400543, I/A14 ( 9.04.21).

04 de Marzo de 2021
Ampliaci贸n de capital. Capital: 18.430,00 Euros. Resultante Suscrito: 76.046,00 Euros. Datos registrales. T 45111 , F 125, S 8, H B400543, I/A 13 (23.02.21).

24 de Marzo de 2020
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.667,00 Euros. Resultante Suscrito: 57.616,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 7.-PARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 45111 , F 125, S 8, H B 400543, I/A 12 (17.03.20).

19 de Octubre de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.195,00 Euros. Resultante Suscrito: 52.949,00 Euros. Datos registrales. T 45111 , F 124, S 8, H B400543, I/A 11 (10.10.17).

26 de Enero de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 9.895,00 Euros. Resultante Suscrito: 48.754,00 Euros. Datos registrales. T 42053 , F 113, S 8, H B400543, I/A 9 (19.01.16).

Cambio de domicilio social. CL VILAMARI Num.50 P.8 (BARCELONA). Datos registrales. T 45111 , F 123, S 8, H B 400543, I/A10 (19.01.16).

22 de Abril de 2015
Revocaciones. ADM.UNICO: FALCON MARTINEZ DE MARA脩ON LUIS FERNANDO. Nombramientos. CONSEJERO: HOFMANNBATLLORI MARCOS. PRESIDENTE: HOFMANN BATLLORI MARCOS. CONSEJERO: FALCON MARTINEZ DE MARA脩ON LUIS F.SECRETARIO: FALCON MARTINEZ DE MARA脩ON LUIS F. CONS. DELEG.: FALCON MARTINEZ DE MARA脩ON LUIS F.CONSEJERO: ELSA CRISTINA MERCEDES HOFMANN. Ampliaci贸n de capital. Capital: 8.844,00 Euros. Resultante Suscrito:38.859,00 Euros. Datos registrales. T 42053 , F 112, S 8, H B 400543, I/A 8 (14.04.15).

03 de Noviembre de 2014
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: SILVIA BANCHINI. Modificaciones estatutarias. ART.18.- SISTEMA RETRIBUTIVO DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 42053 , F 111, S 8, H B 400543, I/A 7 (27.10.14).

07 de Mayo de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.015,00 Euros. Datos registrales. T 42053 , F 110, S 8, H B400543, I/A 6 (25.04.13).

23 de Agosto de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.899,00 Euros. Resultante Suscrito: 25.015,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 7:PARTICIPACIONES. Datos registrales. T 42053 , F 109, S 8, H B 400543, I/A 5 (10.08.12).

27 de Abril de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 110,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.116,00 Euros. Datos registrales. T 42053 , F 105, S 8, H B400543, I/A 3 (18.04.12).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 20.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.116,00 Euros. Datos registrales. T 42053 , F 107, S 8, H B400543, I/A 4 (18.04.12).

19 de Abril de 2012
Modificaciones estatutarias. ARTS.6 Y 7:CREACION DE PARTICIPACIONES SOCIALES TIPO A Y B. Datos registrales. T 42053, F 104, S 8, H B 400543, I/A 2 ( 5.04.12).

20 de Agosto de 2010
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 1.12.10. Objeto social: SERVICIOS DE CONSULTORIA A EMPRESAS PUBLICAS YPRIVADAS SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES,DESARROLLO DE POLITICAS URBANAS Y MAPPING DE INTELIGENCIACOMPETITIVA.ETC. Domicilio: CL ARAGON Num.224 P.3 PTA.1 (BARCELONA). Capital: 3.006,00 Euros. Nombramientos.ADM.SOLIDAR.: FALCON MARTINEZ DE MARA脩ON LUIS FERNANDO;SILVIA BANCHINI. Datos registrales. T 42053 , F 102, S 8,H B 400543, I/A 1 (11.08.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n