Buscador CIF Logo

Actos BORME Interal Sociedad Anonima

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Interal Sociedad Anonima

Actos BORME Interal Sociedad Anonima - A20031126

Tenemos registrados 57 Actos BORME del Registro Mercantil de Guipuzcoa para Interal Sociedad Anonima con CIF A20031126

🔙 Perfil de Interal Sociedad Anonima
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Guipuzcoa

Actos BORME de Interal Sociedad Anonima

21 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: BARROS PEREZ DE CIRIZA URKO. Datos registrales. T 2909 , F 177, S 8, H SS 2174, I/A 100 (5.12.23).

Nombramientos. Apoderado: BARROS PEREZ DE CIRIZA URKO. Datos registrales. T 2909 , F 177, S 8, H SS 2174, I/A 101 (5.12.23).

Nombramientos. Apoderado: BARROS PEREZ DE CIRIZA URKO. Datos registrales. T 2909 , F 178, S 8, H SS 2174, I/A 102 (5.12.23).

Nombramientos. Apoderado: IGUIÑIZ ARTAZAIN ANGEL MARIA. Datos registrales. T 2909 , F 178, S 8, H SS 2174, I/A 103 (5.12.23).

Nombramientos. Apoderado: IGUIÑIZ ARTAZAIN ANGEL MARIA. Datos registrales. T 2909 , F 179, S 8, H SS 2174, I/A 104 (5.12.23).

Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ ARCE MONICA. Datos registrales. T 2909 , F 179, S 8, H SS 2174, I/A 105 ( 5.12.23).

Nombramientos. Apoderado: CABASES OROZCO JUANA. Datos registrales. T 2909 , F 179, S 8, H SS 2174, I/A 106 ( 5.12.23).

Nombramientos. Apoderado: NIETO GARCIA CAROLINA. Datos registrales. T 2909 , F 180, S 8, H SS 2174, I/A 107 ( 5.12.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: ORLANDO OLASO SANTIAGO;MARTINEZ CAMPO ALEJANDRO. Apoderado: MARTINEZ CAMPOALEJANDRO;ALONSO AZCONA ELENA;ALONSO AZCONA ELENA;MORENO LEOZ JESUS ANGEL;SALCEDO GOROSTIETAFRANCISCO JAVIER;SALCEDO GOROSTIETA FRANCISCO JAVIER Datos registrales. T 2909 , F 180, S 8, H SS 2174, I/A 108 (5.12.23).

10 de Febrero de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2909 , F 176, S 8, H SS 2174, I/A 98 ( 2.02.23).

22 de Julio de 2021
Nombramientos. Apoderado: TABOADA FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 2909 , F 175, S 8, H SS 2174, I/A 95(12.07.21).

Nombramientos. Apoderado: RECARTE MENDILUCE MAIDER. Datos registrales. T 2909 , F 175, S 8, H SS 2174, I/A 96(12.07.21).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ LOPEZ FERNANDO. Datos registrales. T 2909 , F 176, S 8, H SS 2174, I/A 97 (12.07.21).

22 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: ALONSO AZCONA ELENA. Datos registrales. T 2909 , F 169, S 8, H SS 2174, I/A 83 ( 5.03.21).

Nombramientos. Apoderado: ALONSO AZCONA ELENA. Datos registrales. T 2909 , F 170, S 8, H SS 2174, I/A 84 ( 5.03.21).

Nombramientos. Apoderado: SALCEDO GOROSTIETA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2909 , F 170, S 8, H SS 2174,I/A 85 ( 5.03.21).

Nombramientos. Apoderado: SALCEDO GOROSTIETA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2909 , F 171, S 8, H SS 2174,I/A 86 ( 5.03.21).

Nombramientos. Apoderado: IGUIÑIZ ARTAZAIN ANGEL MARIA. Datos registrales. T 2909 , F 171, S 8, H SS 2174, I/A 87 (5.03.21).

Nombramientos. Apoderado: MORENO LEOZ JESUS ANGEL. Datos registrales. T 2909 , F 171, S 8, H SS 2174, I/A 88 ( 5.03.21).

Nombramientos. Apoderado: MORENO LEOZ JESUS ANGEL. Datos registrales. T 2909 , F 172, S 8, H SS 2174, I/A 89 ( 5.03.21).

Nombramientos. Apoderado: GOROSTIDI AGUIRREZABALA MIKEL. Datos registrales. T 2909 , F 173, S 8, H SS 2174, I/A 90 (5.03.21).

Nombramientos. Apoderado: CABASES OROZCO JUANA. Datos registrales. T 2909 , F 173, S 8, H SS 2174, I/A 91 ( 5.03.21).

Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ ARCE MONICA. Datos registrales. T 2909 , F 174, S 8, H SS 2174, I/A 92 ( 5.03.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: VILLAPUN JUAREZ MARIA ESTHER. Apo.Manc.: VILLAPUN JUAREZ MARIA ESTHER;MORENO LEOZJESUS ANGEL;ARANA MUÑOZ CLARA;CASTEJON GARBAYO JOSE ANGEL. Datos registrales. T 2909 , F 174, S 8, H SS 2174,I/A 93 ( 5.03.21).

Nombramientos. Apo.Manc.: MORENO LEOZ JESUS ANGEL;CASTEJON GARBAYO JOSE ANGEL;MARTINEZ CAMPOALEJANDRO;ORLANDO OLASO SANTIAGO;ARANA MUÑOZ CLARA. Datos registrales. T 2909 , F 174, S 8, H SS 2174, I/A 94 (5.03.21).

21 de Enero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: VERGARAJAUREGUI SATRUSTEGUI ALVARO;PORTOBELLO BETA SL;PORTOBELLO ALFASL;PORTOBELLO GAMMA SL;INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA SA;ALCAMISSORT SL;OROLA SL. Vicepresid.:PORTOBELLO ALFA SL. Presidente: ALCAMISSORT SL. Vicesecret.: OROLA SL. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZCAMPO ALEJANDRO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.MODIFICACION ESTATUTARIA Y NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Datos registrales. T 2909 , F 166, S 8,H SS 2174, I/A 82 (12.01.21).

20 de Agosto de 2020
Modificación de poderes. Apo.Sol.: MARTINEZ CAMPO ALEJANDRO;ORLANDO OLASO SANTIAGO. Datos registrales. T 2909 ,F 166, S 8, H SS 2174, I/A 80 ( 6.08.20).

16 de Junio de 2020
Nombramientos. Apoderado: ARANA MUÑOZ CLARA. Datos registrales. T 2909 , F 165, S 8, H SS 2174, I/A 79 ( 4.06.20).

05 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Auditor: EASO AUDITORES CONSULTORES SL. Aud.C.Con.: EASO AUDITORES CONSULTORES SL.Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Otros conceptos: Revocación como Auditoresde Cuentas Individuales y Consolidadas de la entidad "Easo Auditores Consultores", por justa causa, de los ejercicios 2019 y 2020.Datos registrales. T 2909 , F 165, S 8, H SS 2174, I/A 78 (22.01.20).

27 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: EGUREN HERNANDEZ JAVIER. Nombramientos. Consejero: VERGARAJAUREGUISATRUSTEGUI ALVARO. Datos registrales. T 2909 , F 165, S 8, H SS 2174, I/A 77 (10.01.20).

31 de Diciembre de 2019
Otros conceptos: Modificación del art. 6º de los Estatutos Sociales con el objeto de reclasificar participaciones tanto de la Clase A,como de la B. Datos registrales. T 2909 , F 165, S 8, H SS 2174, I/A 76 (19.12.19).

13 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ CAMPO ALEJANDRO;ORLANDO OLASO SANTIAGO;ORLANDO OLASO SANTIAGO.Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ CAMPO ALEJANDRO;ORLANDO OLASO SANTIAGO. Datos registrales. T 2909 , F 163, S8, H SS 2174, I/A 74 (25.11.19).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ CAMPO ALEJANDRO. Datos registrales. T 2909 , F 164, S 8, H SS 2174, I/A 75(25.11.19).

13 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ CAMPO ALEJANDRO;ORLANDO OLASO SANTIAGO. Nombramientos. Apo.Sol.: ORLANDOOLASO SANTIAGO;ORLANDO OLASO SANTIAGO;VILLAPUN JUAREZ MARIA ESTHER. Apo.Manc.: VILLAPUN JUAREZ MARIAESTHER;MORENO LEOZ JESUS ANGEL;ARANA MUÑOZ CLARA;CASTEJON GARBAYO JOSE ANGEL. Apo.Sol.: MARTINEZCAMPO ALEJANDRO. Datos registrales. T 2909 , F 161, S 8, H SS 2174, I/A 72 ( 4.09.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ CAMPO ALEJANDRO;ORLANDO OLASO SANTIAGO. Datos registrales. T 2909 , F 162, S8, H SS 2174, I/A 73 ( 4.09.19).

05 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: ORLANDO OLASO SANTIAGO;EGUREN HERNANDEZ JAVIER;VERGARAJAUREGUISATRUSTEGUI ALVARO;OROLA SL;ALCAMISSORT SL. Secretario: ORLANDO OLASO IÑIGO-FRANCISCO. Vicepresid.:VERGARAJAUREGUI SATRUSTEGUI ALVARO. Presidente: ALCAMISSORT SL. Nombramientos. Consejero: PORTOBELLO ALFASL;PORTOBELLO BETA SL;PORTOBELLO GAMMA SL;INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA SA;ALCAMISSORTSL;OROLA SL;EGUREN HERNANDEZ JAVIER. SecreNoConsj: CERDEIRAS CHECA RAMON. Vicesecret.: OROLA SL. Presidente:ALCAMISSORT SL. Vicepresid.: PORTOBELLO ALFA SL. Datos registrales. T 1097 , F 205, S 8, H SS 2174, I/A 69 (29.07.19).

Otros conceptos: MODIFICACION de los ARTICULOS 6º, 7º, 18º, 20º, 21º, 26º, 27º y 28º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,relativos al capital social, al régimen de transmisión de acciones, al régimen de mayorías de la Junta, a la organización del Consejo deAdministración, y a la delegación permanente de facultades.- Datos registrales. T 1097 , F 206, S 8, H SS 2174, I/A 70 (29.07.19).

Revocaciones. Apoderado: ORLANDO OLASAGASTI FERNANDO;ARCONES SAN ANTONIO ANTONIO;ROSSI CAMAGNIFRANCESCO;CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI;ORLANDO OLASO SANTIAGO. Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ CAMPOALEJANDRO;ORLANDO OLASO SANTIAGO. Datos registrales. T 1097 , F 209, S 8, H SS 2174, I/A 71 (29.07.19).

19 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: EGUREN HERNANDEZ JAVIER;ALCAMISSORT SL;OROLA SL;VERGARAJAUREGUISATRUSTEGUI ALVARO;ORLANDO OLASO SANTIAGO. Secretario: ORLANDO OLASO IÑIGO-FRANCISCO. Presidente:ALCAMISSORT SL. Vicepresid.: VERGARAJAUREGUI SATRUSTEGUI ALVARO. Nombramientos. Consejero: ALCAMISSORT SL.Presidente: ALCAMISSORT SL. Consejero: OROLA SL;VERGARAJAUREGUI SATRUSTEGUI ALVARO. Vicepresid.:VERGARAJAUREGUI SATRUSTEGUI ALVARO. Consejero: ORLANDO OLASO SANTIAGO;EGUREN HERNANDEZ JAVIER.Secretario: ORLANDO OLASO IÑIGO-FRANCISCO. Datos registrales. T 1097 , F 205, S 8, H SS 2174, I/A 68 ( 8.11.18).

08 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Aud.C.Con.: EASO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1097 , F 205, S 8, H SS 2174, I/A 67(26.10.18).

26 de Julio de 2018
Reelecciones. Auditor: EASO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1097 , F 204, S 8, H SS 2174, I/A 66(17.07.18).

01 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Secretario: ALCAMISSORT SL. Presidente: OROLA SL. Nombramientos. Presidente: ALCAMISSORT SL.Secretario: ORLANDO OLASO IÑIGO-FRANCISCO. Dir. General: ORLANDO OLASO SANTIAGO. Datos registrales. T 1097 , F 204,S 8, H SS 2174, I/A 65 (22.02.18).

11 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA ALEGRE FERNANDO. Vicepresid.: GARCIA ALEGRE FERNANDO. Nombramientos.Consejero: EGUREN HERNANDEZ JAVIER. Vicepresid.: VERGARAJAUREGUI SATRUSTEGUI ALVARO. Datos registrales. T 1097, F 204, S 8, H SS 2174, I/A 64 ( 5.10.17).

13 de Septiembre de 2017
Ampliación de capital. Suscrito: 2.970.000,00 Euros. Desembolsado: 2.970.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.030.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 6.030.000,00 Euros. Datos registrales. T 1095 , F 174, S 8, H SS 2174, I/A 63 (31.08.17).

09 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ORLANDO OLASAGASTI FERNANDO;CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI. Presidente: ORLANDOOLASAGASTI FERNANDO. Secretario: CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI. Nombramientos. Consejero: ALCAMISSORTSL;OROLA SL. Presidente: OROLA SL. Secretario: ALCAMISSORT SL. Datos registrales. T 1095 , F 174, S 8, H SS 2174, I/A 62(19.04.17).

13 de Marzo de 2017
Revocaciones. Apoderado: GARCIA ALEGRE FERNANDO. Datos registrales. T 1095 , F 172, S 8, H SS 2174, I/A 60 ( 6.03.17).

Nombramientos. Apoderado: ORLANDO OLASO SANTIAGO. Datos registrales. T 1095 , F 172, S 8, H SS 2174, I/A 61 ( 6.03.17).

01 de Febrero de 2017
Otros conceptos: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA SU ADAPTACION A LA VIGENTELEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL. Cambio de domicilio social. POLIG IND. 103, C/ URUNE, Nº34. (LEZO). Datos registrales.T 1095 , F 169, S 8, H SS 2174, I/A 59 (25.01.17).

18 de Enero de 2016
Reelecciones. Aud.C.Con.: EASO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1095 , F 169, S 8, H SS 2174, I/A 58 (8.01.16).

25 de Agosto de 2014
Nombramientos. Auditor: EASO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1095 , F 168, S 8, H SS 2174, I/A 57(14.08.14).

11 de Septiembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GARCIA ALEGRE FERNANDO. Secretario: CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI. Presidente:ORLANDO OLASAGASTI FERNANDO. Consejero: CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI;VERGARAJAUREGUI SATRUSTEGUI

31 de Enero de 2013
Nombramientos. Aud.C.Con.: EASO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1095 , F 168, S 8, H SS 2174, I/A 55(24.01.13).

22 de Agosto de 2011
Reelecciones. Auditor: ECHEVERRIA IRIONDO AGUSTIN. Aud.Supl.: IRURE GOROSTEGUI IGNACIO-MARIA. Datos registrales.T 1095 , F 168, S 8, H SS 2174, I/A 54 (10.08.11).

20 de Agosto de 2010
Ampliación de capital. Suscrito: 2.070.000,00 Euros. Desembolsado: 2.070.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.060.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.060.000,00 Euros. Datos registrales. T 1095 , F 13, S 8, H SS 2174, I/A 53 (11.08.10).

30 de Julio de 2010
Reelecciones. Auditor: ECHEVERRIA IRIONDO AGUSTIN. Aud.Supl.: IRURE GOROSTEGUI IGNACIO-MARIA. Datos registrales.T 1095 , F 13, S 8, H SS 2174, I/A 52 (20.07.10).

21 de Abril de 2010
Revocaciones. Apoderado: ROSSI FRANCESCO-CIRILO. Nombramientos. Apoderado: ROSSI FRANCESCO-CIRILO. Datosregistrales. T 1095 , F 11, S 8, H SS 2174, I/A 51 (12.04.10).

01 de Septiembre de 2009
Reelecciones. Auditor: ECHEVERRIA IRIONDO AGUSTIN. Aud.Supl.: IRURE GOROSTEGUI IGNACIO-MARIA. Datos registrales.T 1095 , F 11, S 8, H SS 2174, I/A 50 (21.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información