Buscador CIF Logo

Actos BORME Intercister Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Intercister Sl

Actos BORME Intercister Sl - B80704273

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Intercister Sl con CIF B80704273

馃敊 Perfil de Intercister Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Intercister Sl

28 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PORTEROS MA脩UECO LIBORIO ALVARO;SHEEHAN JUNKO IO;COLE BRIAN ROY. Fusi贸n porabsorci贸n. Sociedades absorbidas: SETOR SA. EAR SOCIEDAD LIMITADA. RIVASER SL. SERVICIOS DEL AUTOMOVIL SA.INTERCISTER GESA SL. Escisi贸n total. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: ATEN OIL SETOR OPERACIONES SL. ATENOIL SETOR DISTRIBUCION SL. ATEN OIL SETOR ACTIVOS SL. Disoluci贸n. Escision. Extinci贸n. Datos registrales. T 10446 , F167, S 8, H M 125365, I/A 29 (20.12.18).

28 de Junio de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO;LOPEZ FERNANDEZ JULIA;BARNUSELL CORONADOJORGE. Datos registrales. T 10446 , F 166, S 8, H M 125365, I/A 28 (21.06.18).

02 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 10446 , F 166, S 8, H M 125365, I/A 27 (22.12.17).

13 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PORTEROS MA脩UECO LIBORIO ALVARO. Nombramientos. Adm. Solid.: PORTEROSMA脩UECO LIBORIO ALVARO;SHEEHAN JUNKO IO;COLE BRIAN ROY. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales. T 10446 , F 165, S 8, H M 125365, I/A 26 ( 4.12.17).

16 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: ONYHER SL;ONIEVA HERRERO ANTONIO JULIO;LLORD MARTINEZ DOLORES. Nombramientos.Apo.Man.Soli: AZNAR MORENO MARIA DEL MAR;ARAUZO ARRANZ JESUS JULIAN;GALLEGO CARDABA JOSEROBERTO;LOPEZ FERNANDEZ JULIA. Datos registrales. T 10446 , F 163, S 8, H M 125365, I/A 25 ( 7.11.17).

30 de Octubre de 2017
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ATEN OIL SETOR SL. Datos registrales. T 10446 , F 163, S 8, H M 125365, I/A 24(20.10.17).

18 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA NEBREDA VICTOR JOSE;ONYHER SL;PARTICIPASA SL;ONIEVA HERRERO ANTONIOJULIO;ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Presidente: ALBARRAN ISABEL JESUS. Cons.Del.Sol: ALBARRAN ISABELJESUS;ONYHER SL;ONIEVA HERRERO ANTONIO;GARCIA NEBREDA VICTOR. Secretario: ONYHER SL. Representan: HERRERODE LUCAS DANIEL;ONIEVA LLORD ANDREA. Nombramientos. Adm. Unico: PORTEROS MA脩UECO LIBORIO ALVARO. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 10446 , F162, S 8, H M 125365, I/A 23 (10.10.17).

14 de Enero de 2015
Nombramientos. Aud.Supl.: STANDARS AUDITORES SLP. Reelecciones. Auditor: VI脩AS PEYA JUAN. Datos registrales. T10446 , F 162, S 8, H M 125365, I/A 22 ( 5.01.15).

09 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: HERRERO MU脩OZ ANGEL;ONIEVA LLORD RAQUEL. Secretario: HERRERO MU脩OZ ANGEL.Cons.Del.Sol: PARTICIPASA SL. Nombramientos. Representan: HERRERO DE LUCAS DANIEL;ONIEVA LLORD ANDREA.Secretario: ONYHER SL. Datos registrales. T 10446 , F 161, S 8, H M 125365, I/A 21 ( 2.04.13).

19 de Agosto de 2011
Reelecciones. Auditor: VI脩AS PEYA JUAN. Aud.Supl.: SPP AUDITORES Y CONSULTORES DE GESTION SL. Datos registrales.T 10446 , F 161, S 8, H M 125365, I/A 20 ( 8.08.11).

18 de Marzo de 2011
Reelecciones. Auditor: VI脩AS PEYA JUAN. Aud.Supl.: SPP AUDITORES Y CONSULTORES DE GESTION SL. Datos registrales.T 10446 , F 161, S 8, H M 125365, I/A 19 ( 8.03.11).

16 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Representan: LLORD MARTINEZ DOLORES. Consejero: GIL MARTIN CARLOS. Presidente: GIL MARTINCARLOS. Nombramientos. Representan: ONIEVA LLORD RAQUEL. Presidente: ALBARRAN ISABEL JESUS. Cons.Del.Sol:

30 de Julio de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 525.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.100.000,00 Euros. Datos registrales. T 10446 , F 160, S 8,H M 125365, I/A 17 (20.07.10).

03 de Febrero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 525.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.575.000,00 Euros. Datos registrales. T 10446 , F 160, S 8,H M 125365, I/A 16 (22.01.10).

23 de Septiembre de 2009
Nombramientos. Aud.Supl.: SPP AUDITORES Y CONSULTORES DE GESTION SL. Consejero: ALBARRAN ISABEL ANGELJESUS. Con.Delegado: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Reelecciones. Auditor: VI脩AS PEYA JUAN. Ampliaci贸n de capital.Capital: 945.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.050.000,00 Euros. Datos registrales. T 10446 , F 159, S 8, H M 125365, I/A 15 (8.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n