Actos BORME de Intermoney Sa
06 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: DRAPER FONTANALS MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.: ARGUEDAS FERNANDEZ ANTONIO;DELA PARTE RODRIGUEZ JAVIER;VAZQUEZ TERRY JOAQUIN. Datos registrales. T 27597 , F 168, S 8, H M 32140, I/A 111(29.09.23).
20 de Julio de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27597 , F 168, S 8, H M 32140, I/A110 (13.07.23).
30 de Junio de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Adm. Mancom.: DE LA PARTE RODRIGUEZJAVIER;VAZQUEZ TERRY JOAQUIN. Datos registrales. T 27597 , F 168, S 8, H M 32140, I/A 109 (23.06.22).
28 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: DRAPER FONTANALS MARIA. Datos registrales. T 27597 , F 167, S 8, H M 32140, I/A 108(21.09.21).
08 de Julio de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: DE LA PARTE RODRIGUEZ JAVIER;VAZQUEZ TERRY JOAQUIN;GONZALO ANGULO VICTOR. Datosregistrales. T 27597 , F 167, S 8, H M 32140, I/A 107 ( 1.07.21).
23 de Junio de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27597 , F 167, S 8, H M 32140, I/A106 (16.06.21).
08 de Junio de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27597 , F 166, S 8, H M 32140, I/A105 ( 1.06.20).
05 de Febrero de 2020Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 4 DE LOS ESTATUTOS. Cambio de objeto social. LAPRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA. LA ELABORACION DE TODO TIPO DE INFORMES, ESTUDIOS YPUBLICACIONES; DISEÑO, PREPARACION Y EJECUCION DE CURSOS Y SEMINARIOS. Datos registrales. T 27597 , F 166, S 8,H M 32140, I/A 104 (29.01.20).
19 de Junio de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: TRINCADO BOVILLE IÑIGO;BUNZL CSONKA RAFAEL;DE LA PARTE RODRIGUEZJAVIER;ALVAREZ ORTIZ DE ZUÑIGA ANA;VERDE MORENO JOSE IGNACIO;SENIS GILMARTIN BEATRIZ;MARTINEZ PEREZLUIS;VAZQUEZ TERRY JOAQUIN. Datos registrales. T 27597 , F 166, S 8, H M 32140, I/A 103 (12.06.19).
07 de Junio de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27597 , F 166, S 8, H M 32140, I/A102 (31.05.19).
08 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: DE LA PARTE RODRIGUEZ JAVIER;VAZQUEZ TERRY JOAQUIN;GONZALO ANGULO VICTOR.Datos registrales. T 27597 , F 165, S 8, H M 32140, I/A 101 (29.04.19).
21 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ TERRY JOAQUIN. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 100ªLA PUBLICACION DE PODER OTORGADO A VAZQUEZ TERRY JOAQUIN. Datos registrales. T 27597 , F 163, S 8, H M 32140, I/A100 (14.12.18).
26 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: MAYO MUÑIZ JESUS ANGEL. Datos registrales. T 27597 , F 163, S 8, H M 32140, I/A 100(14.12.18).
13 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: TRINCADO BOVILLE IÑIGO. Presidente: TRINCADO BOVILLE IÑIGO. Consejero: SENISGILMARTIN BEATRIZ;BUNZL CSONKA RAFAEL. SecreNoConsj: BLANCO CASO MIRIAM. VsecrNoConsj: BOREN VENDELA.Nombramientos. Adm. Mancom.: DE LA PARTE RODRIGUEZ JAVIER;VAZQUEZ TERRY JOAQUIN. Modificaciones estatutarias.Modificación de los artículos 3º, 9º, 10º, 12º, 13º, 15º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º y 33º. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 27597 , F 163, S 8, HM 32140, I/A 99 ( 5.11.18).
28 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: COULON EMMANUEL. Datos registrales. T 27597 , F 163, S 8, H M 32140, I/A 98 (21.06.18).
12 de Junio de 2018Ampliacion del objeto social. DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE PARA SU COMERCIALIZACION A TERCEROS. Datosregistrales. T 27597 , F 162, S 8, H M 32140, I/A 97 ( 4.06.18).
24 de Mayo de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27597 , F 162, S 8, H M 32140, I/A96 (17.05.18).
02 de Junio de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: BUNZL CSONKA RAFAEL. Datosregistrales. T 27597 , F 162, S 8, H M 32140, I/A 95 (24.05.17).
12 de Mayo de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: SENIS GILMARTIN BEATRIZ. Datosregistrales. T 27597 , F 55, S 8, H M 32140, I/A 94 ( 4.05.16).
16 de Marzo de 2016Modificaciones estatutarias. Modificado el artículo 29 de los estatutos.. Datos registrales. T 27597 , F 55, S 8, H M 32140, I/A 93 (3.03.16).
13 de Enero de 2016Nombramientos. VsecrNoConsj: BOREN VENDELA. Datos registrales. T 27597 , F 55, S 8, H M 32140, I/A 92 ( 5.01.16).
03 de Junio de 2015Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: TRINCADO BOVILLE IÑIGO. Presidente:TRINCADO BOVILLE IÑIGO. Datos registrales. T 27597 , F 54, S 8, H M 32140, I/A 91 (27.05.15).
24 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: LINARES MARTINEZ NICOLAS. Datos registrales. T 27597 , F 52, S 8, H M 32140, I/A 88(13.11.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VAZQUEZ TERRY JOAQUIN. Datos registrales. T 27597 , F 52, S 8, H M 32140, I/A 89 (14.11.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: COULON EMMANUEL. Datos registrales. T 27597 , F 54, S 8, H M 32140, I/A 90 (14.11.14).
10 de Octubre de 2014Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA131 - PLANTA 3& (MADRID). Datos registrales. T 27597 , F 51, S 8, H M 32140, I/A 87 ( 3.10.14).
19 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: LINARES MARTINEZ NICOLAS. Datos registrales. T 27597 , F 51, S 8, H M 32140, I/A 85 (6.08.14).
Modificaciones estatutarias. se modifica el articulo 29º de los estatutos sociales. Datos registrales. T 27597 , F 51, S 8, H M32140, I/A 86 ( 6.08.14).
28 de Mayo de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27597 , F 50, S 8, H M 32140, I/A84 (21.05.14).
26 de Febrero de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ GALIANO VALLADARES IÑAKI;SANCHEZ DIAZ NATIVIDAD. Nombramientos. Apoderado:FERNANDEZ GALIANO VALLADARES IÑAKI;SANCHEZ DIAZ NATIVIDAD. Datos registrales. T 27597 , F 50, S 8, H M 32140, I/A83 (18.02.14).
03 de Febrero de 2014Revocaciones. Apoderado: BUNZL CSONKA RAFAEL;TRINCADO BOVILLE IÑIGO;SENIS GILMARTIN BEATRIZ;GONZALOANGULO VICTOR;ALVAREZ ORTIZ DE ZUÑIGA ANA. Apo.Man.Soli: VERDE MORENO JOSE IGNACIO. Apoderado: LINARESMARTINEZ NICOLAS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TRINCADO BOVILLE IÑIGO;BUNZL CSONKA RAFAEL;DE LA PARTERODRIGUEZ JAVIER;LINARES MARTINEZ NICOLAS;ALVAREZ ORTIZ DE ZUÑIGA ANA;VERDE MORENO JOSE IGNACIO;SENISGILMARTIN BEATRIZ;MARTINEZ PEREZ LUIS. Datos registrales. T 27597 , F 47, S 8, H M 32140, I/A 82 (24.01.14).
27 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: SENIS GILMARTIN BEATRIZ. Nombramientos. SecreNoConsj: BLANCO CASO MIRIAM. Datosregistrales. T 27597 , F 47, S 8, H M 32140, I/A 81 (18.12.13).
10 de Mayo de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: BUNZL CSONKA RAFAEL. Datosregistrales. T 27597 , F 47, S 8, H M 32140, I/A 80 ( 3.05.13).
10 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: LINARES MARTINEZ NICOLAS. Consejero: LINARES MARTINEZ NICOLAS. Datos registrales. T27597 , F 45, S 8, H M 32140, I/A 79 (27.09.12).
24 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: VERDE MORENO JOSE IGNACIO;FERNANDEZ VILLAVERDE GONZALEZ CRISTOBAL.Nombramientos. Apo.Man.Soli: VERDE MORENO JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 27597 , F 42, S 8, H M 32140, I/A 78(13.09.12).
05 de Junio de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: SENIS GILMARTIN BEATRIZ. Secretario:SENIS GILMARTIN BEATRIZ. Datos registrales. T 27597 , F 42, S 8, H M 32140, I/A 77 (24.05.12).
22 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: PEREZ FERNANDEZ JOSE. Consejero: PEREZ FERNANDEZ JOSE. Revocaciones. Apoderado:SANCHEZ DIAZ NATIVIDAD;FERNANDEZ GALIANO VALLADARES IÑAKI. Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ GALIANOVALLADARES IÑAKI;SANCHEZ DIAZ NATIVIDAD. Presidente: TRINCADO BOVILLE IÑIGO. Datos registrales. T 27597 , F 41, S 8,H M 32140, I/A 76 (10.06.11).
01 de Junio de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: TRINCADO BOVILLE IÑIGO. Datosregistrales. T 27597 , F 41, S 8, H M 32140, I/A 75 (20.05.11).
07 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apoderado: MUÑOZ ACHIRICA JUAN. Datos registrales. T 27597 , F 41, S 8, H M 32140, I/A 74 (24.11.10).
02 de Junio de 2010Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27597 , F 41, S 8, H M 32140, I/A73 (24.05.10).
20 de Abril de 2010Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ ORTIZ DE ZUÑIGA ANA. Datos registrales. T 1778 , F 129, S 8, H M 32140, I/A 72 (8.04.10).
15 de Marzo de 2010Revocaciones. Apoderado: NIETO VELA ROBERTO. Nombramientos. Apo.Manc.: VERDE MORENO JOSEIGNACIO;FERNANDEZ VILLAVERDE GONZALEZ CRISTOBAL. Datos registrales. T 1778 , F 128, S 8, H M 32140, I/A 71 ( 4.03.10).
23 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ SOMALO MIGUEL. Revocaciones. Apoderado: PEREZ SOMALO MIGUEL. Datosregistrales. T 1778 , F 127, S 8, H M 32140, I/A 70 (11.12.09).
16 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: BUNZL CSONKA RAFAEL;TRINCADO BOVILLE IÑIGO;MUÑOZ ACHIRICA JUAN;SENIS GILMARTINBEATRIZ;PEREZ SOMALO MIGUEL;GONZALO ANGULO VICTOR. Apo.Man.Soli: NIETO VELA ROBERTO. Nombramientos.Apoderado: BUNZL CSONKA RAFAEL;TRINCADO BOVILLE IÑIGO;MUÑOZ ACHIRICA JUAN;SENIS GILMARTIN BEATRIZ;PEREZSOMALO MIGUEL;GONZALO ANGULO VICTOR;NIETO VELA ROBERTO. Datos registrales. T 1778 , F 23, S 8, H M 32140, I/A 69( 3.11.09).
25 de Mayo de 2009Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: BUNZL CSONKA RAFAEL. Datosregistrales. T 1778 , F 23, S 8, H M 32140, I/A 68 (11.05.09).