Actos BORME de International Oncology Group Sa
16 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: COLLINS DAN JACOB. Datos registrales. T 38928 , F 57, S 8, H M 371854, I/A 40 ( 8.05.23).
14 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: SEBASTIAN QUETGLAS RAFAEL;ACOSTA ALVAREZ TOMAS JOSE;MONTA脩ES LOZANO JAVIER.Nombramientos. Apoderado: GOMEZ SANCHEZ PABLO;CRACCO ALEXANDRA;CORDON PERALTA CRISTINA;ENRICH RUIZ DEVELASCO JAIME;NORDMANN RODRIGUEZ MARIA. Datos registrales. T 38928 , F 55, S 8, H M 371854, I/A 39 ( 5.12.22).
10 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MORAIS D'ALMEIDA SACCHETTI DE PASSOS JONAS. Datos registrales. T 38928 , F 55, S 8, H M371854, I/A 38 ( 1.12.21).
07 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: ROLFO ALDO. Nombramientos. Representan: CAPELL BRENDAN. Datos registrales. T 38928, F 55, S 8, H M 371854, I/A 37 (29.11.21).
28 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: SANZ MARTIN GEMMA. Datos registrales. T 38928 , F 55, S 8, H M 371854, I/A 36 (21.08.20).
20 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: PEREZ BRETONES MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 38928 , F 54, S 8, H M 371854, I/A 35(13.07.20).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: CAPELL BRENDAN. Datos registrales. T 38928 , F 52, S 8, H M 371854, I/A 34 (19.06.20).
10 de Junio de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: BRICE脩O LAGOS CONRADO. Nombramientos. Representan: ROLFO ALDO. Datosregistrales. T 38928 , F 52, S 8, H M 371854, I/A 33 ( 3.06.20).
30 de Enero de 2020Revocaciones. Apoderado: ALONSO ALONSO JOSE LUIS. Datos registrales. T 38928 , F 52, S 8, H M 371854, I/A 32 (23.01.20).
22 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: MURIEL SANZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 38928 , F 50, S 8, H M 371854, I/A 30 (16.11.19).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ BRETONES MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 38928 , F 50, S 8, H M 371854, I/A 31(16.11.19).
18 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: MORAIS D'ALMEIDA SACCHETTI DE PASSOS JONAS. Nombramientos. Representan:BRICE脩O LAGOS CONRADO. Datos registrales. T 38928 , F 50, S 8, H M 371854, I/A 29 (11.11.19).
19 de Agosto de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ALLEN MICHAEL JOHN;PICKETT AARON MACKENZIE;BERRA DE UNAMUNO RAMON. Datosregistrales. T 38928 , F 49, S 8, H M 371854, I/A 28 ( 9.08.19).
09 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: BERRA DE UNAMUNO RAMON. Nombramientos. Representan: MORAIS D'ALMEIDASACCHETTI DE PASSOS JONAS. Datos registrales. T 38928 , F 49, S 8, H M 371854, I/A 27 ( 5.08.19).
18 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MORAIS D'ALMEIDA SACCHETTI DE PASSOS JONAS;SANZ MARTIN GEMMA;MURIEL SANZ JOSEMANUEL. Datos registrales. T 31657 , F 85, S 8, H M 371854, I/A 26 (11.06.19).
12 de Diciembre de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 24.074,64 Euros. Desembolsado: 24.074,64 Euros. Resultante Suscrito: 665.972,80 Euros.Resultante Desembolsado: 665.972,80 Euros. Datos registrales. T 31657 , F 84, S 8, H M 371854, I/A 25 ( 3.12.18).
22 de Junio de 2018Cambio de domicilio social. C/ EMILIO VARGAS 16 (MADRID). Datos registrales. T 31657 , F 82, S 8, H M 371854, I/A 23(15.06.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Nombramientos. Apoderado: ALONSO ALONSO JOSELUIS. Datos registrales. T 31657 , F 82, S 8, H M 371854, I/A 24 (15.06.18).
04 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Nombramientos. Representan: BERRA DEUNAMUNO RAMON. Datos registrales. T 31657 , F 82, S 8, H M 371854, I/A 22 (24.04.18).
30 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGIA SA. Representan: JIMENEZ-HERRERABURGALETA PABLO. Nombramientos. Adm. Unico: GENESIS CARE ESPA脩A HOLDINGS SL. Representan: JIMENEZ-HERRERABURGALETA PABLO. Datos registrales. T 31657 , F 80, S 8, H M 371854, I/A 20 (23.11.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: COLLINS DAN JACOB;PICKETT AARON MACKENZIE;BERRA DE UNAMUNO RAMON. Datosregistrales. T 31657 , F 80, S 8, H M 371854, I/A 21 (23.11.17).
10 de Octubre de 2017Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31657 , F 79, S 8, H M 371854,I/A 19 ( 3.10.17).
09 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: SEBASTIAN QUETGLAS RAFAEL;ACOSTA ALVAREZ TOMAS JOSE;MONTA脩ES LOZANO JAVIER.Datos registrales. T 31657 , F 79, S 8, H M 371854, I/A 18 (29.09.17).
08 de Mayo de 2017Modificaciones estatutarias. SE APRUEBA UN TEXTO REFUNDIDO DE ESTATUTOS SOCIALES.. Cambio de objeto social.ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE CANCER, EXPLOTACION Y DIAGNOSTICO CLINICO. GESTION, ASESORAMIENTO,ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE SERVICIOS ONCOLOGICOS, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. FOMENTO YDESARROLLO DE ASISTENCIA SOCIAL. Datos registrales. T 31657 , F 75, S 8, H M 371854, I/A 17 (27.04.17).
01 de Marzo de 2017Revocaciones. Apoderado: BOCCHINO ANTOINE MARIE LAURENT;SAMBLAS GARCIA JOSE;ISACH GABALDON MARIAANTONIA;JIMENEZ HERRERA BURGALETA PABLO. Datos registrales. T 31657 , F 75, S 8, H M 371854, I/A 16 (22.02.17).
23 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: ALLEN MICHAEL JOHN;JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Datos registrales. T 31657 , F 73,S 8, H M 371854, I/A 15 (15.02.17).
08 de Agosto de 2016Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Datos registrales. T 31657 , F 73, S 8, H M 371854, I/A 14(29.07.16).
11 de Marzo de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO;ISACH GABALDON MARIA ANTONIA. Datos registrales. T31657 , F 72, S 8, H M 371854, I/A 13 (27.02.14).
28 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: SAMBLAS GARCIA JOSE;ISACH GABALDON MARIA ANTONIA;JIMENEZ HERRERA BURGALETAPABLO Datos registrales. T 31657 , F 71, S 8, H M 371854, I/A 12 (20.11.13).
27 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: SAMBLAS GARCIA JOSE MANUEL;JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO;ISACH GABALDONMARIA ANTONIA. Presidente: SAMBLAS GARCIA JOSE MANUEL. Secretario: JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO.Nombramientos. Representan: JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Adm. Unico: RADIOCIRUGIA SAN FRANCISCO DEASIS SA. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 7, 14, 15, 16, 17 Y 18 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 31657 , F70, S 8, H M 371854, I/A 11 (20.11.13).
22 de Octubre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 749.901,84 Euros. Resultante Suscrito: 641.898,16 Euros. Datos registrales. T 20970 , F98, S 8, H M 371854, I/A 10 (14.10.13).
24 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: SAMBLAS GARCIA JOSE MANUEL. Reelecciones. Consejero: SAMBLAS GARCIA JOSEMANUEL;JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO;ISACH GABALDON MARIA ANTONIA. Presidente: SAMBLAS GARCIA JOSEMANUEL. Secretario: JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 67.800,00 Euros.Desembolsado: 67.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.391.800,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.391.800,00 Euros. Datosregistrales. T 20970 , F 97, S 8, H M 371854, I/A 9 (16.04.13).
21 de Julio de 2011Otros conceptos: SE ACUERDA SUPRIMIR LAS LIMITACIONES A LA TRANSMISION DE ACCIONES QUE CONSTAN EN ELARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS, EL CUAL QUEDA SUPRIMIDO. Datos registrales. T 20970 , F 97, S 8, H M 371854, I/A 8(11.07.11).
30 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: BOCCHINO ANTOINE MARIE LAURENT. Datos registrales. T 20970 , F 97, S 8, H M 371854, I/A 7(19.05.11).
06 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 760.000,00 Euros. Desembolsado: 760.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.324.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.324.000,00 Euros. Datos registrales. T 20970 , F 96, S 8, H M 371854, I/A 6 (24.03.09).