Buscador CIF Logo

Actos BORME International Procurement And Logistics -spain- Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera International Procurement And Logistics -spain- Sl

Actos BORME International Procurement And Logistics -spain- Sl - B53905626

Tenemos registrados 9 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para International Procurement And Logistics -spain- Sl con CIF B53905626

🔙 Perfil de International Procurement And Logistics -spain- Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de International Procurement And Logistics -spain- Sl

15 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MICHAEL JOHN BLAND SNELL. Presidente: MICHAEL JOHN BLAND SNELL. Nombramientos.Consejero: JANE MARIE BERRY. Presidente: JANE MARIE BERRY. Datos registrales. T 3224 , F 212, S 8, H MU 71478, I/A 16 (8.06.23).

08 de Septiembre de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JONATHAN QUALTROUGH. Nombramientos. Apo.Man.Soli: VARINDERPAL SINGH REHAL.Apo.Sol.: CATHERINE MARY EVANS. Datos registrales. T 3224 , F 210, S 8, H MU 71478, I/A 15 ( 1.09.22).

07 de Octubre de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BRONAGH LOWRY. Datos registrales. T 3224 , F 210, S 8, H MU 71478, I/A 14 (30.09.21).

27 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: JAMES EDWARD FASEY. Revocaciones. Apo.Man.Soli: GAYNOR WILLIAMS. Apo.Sol.: JAMESEDWARD FASEY. Apo.Man.Soli: NICOLA GAIL IRVING. Nombramientos. Consejero: PAUL ALASTAIR GROVER. Apo.Man.Soli:PAUL ALASTAIR GROVER;JONATHAN QUALTROUGH;BRONAGH LOWRY. Datos registrales. T 3224 , F 210, S 8, H MU 71478,I/A 13 (20.11.20).

16 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CATHERINE MARY EVANS. Datos registrales. T 3224 , F 210, S 8, H MU 71478, I/A 12 ( 9.03.20).

04 de Junio de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: IAN HARRISON. Datos registrales. T 3224 , F 210, S 8, H MU 71478, I/A 11 (28.05.19).

16 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: JONATHAN MICHAEL TREMAYNE. Revocaciones. Apo.Sol.: JONATHAN MICHAEL TREMAYNE.Nombramientos. Apoderado: DOMINIC EDWARDS. Consejero: DOMINIC EDWARDS. Datos registrales. T 3224 , F 209, S 8, HMU 71478, I/A 10 ( 8.10.18).

23 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Secretario: VALERA MARTOS ENRIQUE. Revocaciones. Apo.Man.Soli: IAIN HIGHLANDS;FRANCIS BRIANWALTON;KATHRYN ANN GRAY;GORDON CAMERON;MARK CHRISTOPHER OWEN;MANUEL JAIME LOPEZ TAYLOR.Nombramientos. Apo.Sol.: CATHERINE MARY EVANS;IAN HARRISON;VARINDERPAL SINGH REHAL;JONATHAN MICHAELTREMAYNE;JAMES EDWARD FASEY. Apo.Man.Soli: GAYNOR WILLIAMS;NICOLA GAIL IRVING;CLAIRE LAURA PECK. Secretario:VARINDERPAL SINGH REHAL. Datos registrales. T 2717 , F 85, S 8, H MU 71478, I/A 8 (15.03.17).

06 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: SIAN LOUISE LAND;GORDON CAMERON;JAMES MARK JEFCOATE. Presidente: GORDONCAMERON. Nombramientos. Consejero: MICHAEL JOHN BLAND SNELL;JONATHAN MICHAEL TREMAYNE;JAMES EDWARDFASEY. Apoderado: VALERA MARTOS ENRIQUE. Datos registrales. T 2717 , F 85, S 8, H MU 71478, I/A 7 (27.02.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información