Buscador CIF Logo

Actos BORME International Supply Management Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera International Supply Management Sl

Actos BORME International Supply Management Sl - B84396167

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para International Supply Management Sl con CIF B84396167

🔙 Perfil de International Supply Management Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de International Supply Management Sl

27 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES ANGEL. Aud.Supl.: CARRASCO MARTIN JUAN PEDRO. Datosregistrales. T 31622 , F 184, S 8, H M 384437, I/A 30 (20.01.23).

19 de Octubre de 2022
Reelecciones. Consejero: JIMENEZ RANDELL MARIA ISABEL;SALVADOR TORRO ARMANDO;LLORET MESA JOSE CARLOS.Presidente: JIMENEZ RANDELL DANIEL EDEN MARTIN. Consejero: JIMENEZ RANDELL DANIEL MARTINEDEN. Vicepresid.:SALVADOR TORRO ARMANDO. Secretario: LLORET MESA JOSE CARLOS. Con.Delegado: JIMENEZ RANDELL DANIEL MARTINEDEN. Vicepresid.: JIMENEZ RANDELL MARIA ISABEL. Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 8º de los estatutos..Datos registrales. T 31622 , F 183, S 8, H M 384437, I/A 29 (11.10.22).

24 de Junio de 2020
Cambio de domicilio social. AVDA CAÑADA 56 (COSLADA). Datos registrales. T 31622 , F 183, S 8, H M 384437, I/A 28(17.06.20).

20 de Febrero de 2020
Reelecciones. Auditor: VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES ANGEL. Aud.Supl.: CARRASCO MARTIN JUAN PEDRO. Datosregistrales. T 31622 , F 183, S 8, H M 384437, I/A 27 (13.02.20).

08 de Febrero de 2019
Reelecciones. Auditor: VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES ANGEL. Aud.Supl.: CARRASCO MARTIN JUAN PEDRO. Datosregistrales. T 31622 , F 182, S 8, H M 384437, I/A 26 ( 1.02.19).

19 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CUADRA ALEJANDRO. Datos registrales. T 31622 , F 182, S 8, H M 384437, I/A 25(12.12.18).

12 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ SERRANO MANUEL. Presidente: JIMENEZ SERRANO MANUEL. Consejero: JIMENEZRANDELL MARIA ISABEL;JIMENEZ RANDELL DANIEL EDEN. Cons.Del.Sol: JIMENEZ SERRANO MANUEL. Consejero:SALVADOR TORRO ARMANDO;LLORET MESA JOSE CARLOS. Secretario: LLORET MESA JOSE CARLOS. Cons.Del.Sol:JIMENEZ RANDELL DANIEL EDEN MARTIN. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ RANDELL MARIA ISABEL;SALVADORTORRO ARMANDO;LLORET MESA JOSE CARLOS. Presidente: JIMENEZ RANDELL DANIEL EDEN MARTIN. Consejero: JIMENEZRANDELL DANIEL MARTINEDEN. Vicepresid.: SALVADOR TORRO ARMANDO. Secretario: LLORET MESA JOSE CARLOS.Con.Delegado: JIMENEZ RANDELL DANIEL MARTIN EDEN. Vicepresid.: JIMENEZ RANDELL MARIA ISABEL. Datos registrales. T31622 , F 182, S 8, H M 384437, I/A 24 ( 5.02.18).

16 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: SALVADOR TORRO ARMANDO. Datos registrales. T 31622 , F 181, S 8, H M 384437, I/A 23 (8.03.17).

07 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMERO MARCO FRANCISCO JAVIER. Cons.Del.Sol: ROMERO MARCO FRANCISCO JAVIER.Vicepresid.: ROMERO MARCO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Cons.Del.Sol: JIMENEZ RANDELL DANIEL EDEN MARTIN.Datos registrales. T 31622 , F 181, S 8, H M 384437, I/A 22 (24.02.17).

14 de Febrero de 2017
Nombramientos. Auditor: VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES ANGEL. Aud.Supl.: CARRASCO MARTIN JUAN PEDRO. Datosregistrales. T 31622 , F 181, S 8, H M 384437, I/A 21 ( 6.02.17).

24 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES ANGEL. Aud.Supl.: BRAZA GALLO Y BARRIOS AUDITORES SL.Datos registrales. T 31622 , F 180, S 8, H M 384437, I/A 20 (17.01.17).

27 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Consejero: LLORET MESA JOSE CARLOS. Secretario: LLORET MESA JOSE CARLOS. Datos registrales. T 31622, F 180, S 8, H M 384437, I/A 19 (19.12.16).

01 de Septiembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA CAL LANZA ALBERTO. Presidente: DE LA CAL LANZA ALBERTO. Consejero: HERNANDEZCUESTA JAVIER;MARTIN ALVAREZ SAUL;JURADO MATEOS ALFONSO. Con.Delegado: ROMERO MARCO FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Consejero: JIMENEZ SERRANO MANUEL. Presidente: JIMENEZ SERRANO MANUEL. Consejero: JIMENEZRANDELL MARIA ISABEL;JIMENEZ RANDELL DANIEL EDEN. Cons.Del.Sol: JIMENEZ SERRANO MANUEL;ROMERO MARCOFRANCISCO JAVIER. Reelecciones. Secretario: LLORET MESA JOSE CARLOS. Vicepresid.: ROMERO MARCO FRANCISCOJAVIER. Consejero: SALVADOR TORRO ARMANDO. Datos registrales. T 31622 , F 179, S 8, H M 384437, I/A 18 (24.08.15).

01 de Abril de 2015
Nombramientos. Auditor: VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES ANGEL. Aud.Supl.: BRAZA GALLO Y BARRIOS AUDITORES SL.Datos registrales. T 31622 , F 179, S 8, H M 384437, I/A 17 (23.03.15).

03 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ RANDELL MARIA ISABEL. Vicepresid.: JIMENEZ RANDELL MARIA ISABEL. Consejero:JIMENEZ RANDELL DANIEL EDEN MARTIN;DEL RIO GUERRA TOMAS. Nombramientos. Vicepresid.: ROMERO MARCOFRANCISCO JAVIER. Consejero: MARTIN ALVAREZ SAUL;SALVADOR TORRO ARMANDO;JURADO MATEOS ALFONSO. Datosregistrales. T 31622 , F 179, S 8, H M 384437, I/A 16 (26.06.14).

05 de Febrero de 2014
Reelecciones. Auditor: VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES ANGEL. Aud.Supl.: BRAZA GALLO Y BARRIOS AUDITORES SL.Datos registrales. T 31622 , F 178, S 8, H M 384437, I/A 15 (28.01.14).

23 de Diciembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ RANDELL MARIA ISABEL. Datos registrales. T 21606 , F 116, S 8, H M 384437, I/A 12(13.12.13).

Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ SERRANO MANUEL. Datos registrales. T 21606 , F 116, S 8, H M 384437, I/A 13(13.12.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ RANDELL MARIA ISABEL;LLORET MESA JOSE CARLOS. Datos registrales. T 31622 , F178, S 8, H M 384437, I/A 14 (13.12.13).

21 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES ANGEL. Aud.Supl.: BRAZA GALLO Y BARRIOS AUDITORES SL.Datos registrales. T 21606 , F 115, S 8, H M 384437, I/A 11 (14.01.13).

18 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES ANGEL. Aud.Supl.: BRAZA GALLO Y BARRIOS AUDITORES SL.Datos registrales. T 21606 , F 115, S 8, H M 384437, I/A 10 ( 5.01.12).

02 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ RANDELL DANIEL;GARCIA SANSIGRE EDUARDO. Presidente: GARCIA SANSIGRE

22 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ RANDELL DAVID ENMANUEL. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ RANDELLDANIEL. Datos registrales. T 21606 , F 115, S 8, H M 384437, I/A 8 ( 8.08.11).

26 de Enero de 2011
Reelecciones. Auditor: VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES ANGEL. Aud.Supl.: BRAZA GALLO Y BARRIOS AUDITORES SL.Datos registrales. T 21606 , F 114, S 8, H M 384437, I/A 7 (14.01.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información