Buscador CIF Logo

Actos BORME Interurbana De Autobuses Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Interurbana De Autobuses Sa

Actos BORME Interurbana De Autobuses Sa - A28170207

Tenemos registrados 56 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Interurbana De Autobuses Sa con CIF A28170207

馃敊 Perfil de Interurbana De Autobuses Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Interurbana De Autobuses Sa

22 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: BLAZQUEZ RODRIGO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 45653 , F 169, S 8, H M 74275, I/A 99(15.12.23).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ COCHO RICARDO. Datos registrales. T 45948 , F 100, S 8, H M 74275, I/A 100(15.12.23).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ LOPEZ-REY SERGIO. Datos registrales. T 45948 , F 102, S 8, H M 74275, I/A 101(15.12.23).

Nombramientos. Apoderado: TORRES RODRIGUEZ LUISA MARIA. Datos registrales. T 45948 , F 105, S 8, H M 74275, I/A 102(15.12.23).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MARTIALAY PAOLA. Datos registrales. T 45948 , F 106, S 8, H M 74275, I/A 103(15.12.23).

Nombramientos. Apoderado: INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 45948 , F 108, S 8, H M 74275, I/A 104(15.12.23).

Nombramientos. Apoderado: CALDERON AREVALO LAURA. Datos registrales. T 45948 , F 110, S 8, H M 74275, I/A 105(15.12.23).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ ABRIL ROCIO. Datos registrales. T 45948 , F 113, S 8, H M 74275, I/A 106 (15.12.23).

Nombramientos. Apoderado: SOLDEVILLA RUBIERA ALFREDO. Datos registrales. T 45948 , F 115, S 8, H M 74275, I/A 107(14.12.23).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ CERNUDA MATIAS. Datos registrales. T 45948 , F 118, S 8, H M 74275, I/A 108 (15.12.23).

21 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: MARINO ARZUA CARLOS. Datos registrales. T 45653 , F 149, S 8, H M 74275, I/A 93 (14.12.23).

Nombramientos. Apoderado: MATUTE PEREZ MARTA. Datos registrales. T 45653 , F 153, S 8, H M 74275, I/A 94 (14.12.23).

Nombramientos. Apoderado: PERALTA MATEOS MARIA ROSA. Datos registrales. T 45653 , F 157, S 8, H M 74275, I/A 95(14.12.23).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ FLOREZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 45653 , F 160, S 8, H M 74275, I/A 96(14.12.23).

Nombramientos. Apoderado: ALMIRA GARCIA JOAQUIN. Datos registrales. T 45653 , F 163, S 8, H M 74275, I/A 97 (14.12.23).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GONZALEZ JAVIER. Datos registrales. T 45653 , F 166, S 8, H M 74275, I/A 98(14.12.23).

20 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: DE LA GANDARA MARTINEZ DE VELASCO JOSE. Datos registrales. T 45653 , F 145, S 8, H M74275, I/A 92 (13.12.23).

24 de Noviembre de 2023
Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 88 el nombramiento de AGUADO RUBIO ENRIQUE como apoderado, siendo locorrecto MARINO ARZUA CARLOS. Datos registrales. T 40989 , F 72, S 8, H M 74275, I/A 88 ( 3.05.23).

27 de Septiembre de 2023
Nombramientos. Consejero: AGUADO GAVILAN ALMUDENA. Datos registrales. T 40989 , F 74, S 8, H M 74275, I/A 91 (20.09.23).

25 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUADO GARCIA SANTIAGO;AGUADO RUBIO ENRIQUE;AGUADO GAVILAN MIGUELANGEL;AGUADO GAVILAN EDUARDO. Presidente: AGUADO GARCIA SANTIAGO. Cons.Del.Sol: AGUADO GARCIASANTIAGO;AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL. Consejero: AGUADO RUBIO MARIA MARTA. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIOENRIQUE. Nombramientos. Consejero: AGUADO RUBIO ENRIQUE;AGUADO RUBIO MARIA MARTA;AGUADO GAVILAN MIGUELANGEL;AGUADO GAVILAN EDUARDO;FLORES PEREZ GONZALO JESUS. Presidente: AGUADO RUBIO ENRIQUE. Cons.Del.Sol:AGUADO RUBIO ENRIQUE;AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 40989 , F 74, S 8, H M 74275, I/A 90(18.08.23).

26 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ DARRIBA BREOGAN. Datos registrales. T 40989 , F 74, S 8, H M 74275, I/A 89 (19.05.23).

10 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUADO RUBIO ENRIQUE. Apo.Manc.: DE LA GANDARA MARTINEZ DE VELASCO JOSE. Datosregistrales. T 40989 , F 72, S 8, H M 74275, I/A 88 ( 3.05.23).

28 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MOTOYA LEGARIA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 40989 , F 71, S 8, H M 74275, I/A 87(21.04.23).

19 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: CHURTICHAGA GUTIERREZ FRANCISCO. Datos registrales. T 40989 , F 71, S 8, H M 74275, I/A86 (12.12.22).

25 de Abril de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LOPEZ-REY SERGIO. Datos registrales. T 40989 , F 71, S 8, H M 74275, I/A 85(18.04.22).

02 de Marzo de 2022
Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 40989 , F 70, S 8, H M 74275, I/A 84 (23.02.22).

27 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLAQUEZ RODRIGO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 40989 , F 70, S 8, H M 74275, I/A 83(20.12.21).

07 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTIALAY PAOLA. Datos registrales. T 40989 , F 69, S 8, H M 74275, I/A 81(31.05.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: CALDERON AREVALO LAURA;ISABEL ALONSO MARIA. Datos registrales. T 40989 , F 69, S 8, H M74275, I/A 82 (31.05.21).

31 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ SU脩ER OCTAVIO. Datos registrales. T 40989 , F 61, S 8, H M 74275, I/A 74(23.12.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTIALAY PAOLA. Datos registrales. T 40989 , F 61, S 8, H M 74275, I/A 75(23.12.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: CALDERON AREVALO LAURA;ISABEL ALONSO MARIA;INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA. Datosregistrales. T 40989 , F 62, S 8, H M 74275, I/A 76 (23.12.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ FLOREZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 40989 , F 62, S 8, H M 74275, I/A 77(23.12.20).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA GANDARA MARTINEZ DE VELASCO JOSE. Datos registrales. T 40989 , F 64, S 8, H M74275, I/A 78 (23.12.20).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLAQUEZ RODRIGO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 40989 , F 66, S 8, H M 74275, I/A 79(23.12.20).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FLORES PEREZ GONZALO;MATUTE PEREZ MARTA. Datos registrales. T 40989 , F 67, S 8, H M74275, I/A 80 (23.12.20).

28 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLAQUEZ RODRIGO MIGUEL ANGEL;INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA. Apo.Sol.: LOPEZDARRIBA BREOGAN. Datos registrales. T 4506 , F 223, S 8, H M 74275, I/A 73 (18.12.20).

13 de Octubre de 2020
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 25.-DE LOS ESTATUTOS SOCIALES .- RETRIBUCION.- . Datosregistrales. T 4506 , F 222, S 8, H M 74275, I/A 72 ( 5.10.20).

06 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUADO RUBIO SANTIAGO. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO SANTIAGO. Nombramientos.Consejero: AGUADO RUBIO MARIA MARTA. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO ENRIQUE. Datos registrales. T 4506 , F 222, S 8, H M74275, I/A 71 (29.06.20).

24 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Auditor: AVANTER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4506 , F 222, S 8, H M 74275, I/A 70 (17.09.19).

30 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO ENRIQUE. Nombramientos. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO SANTIAGO.Datos registrales. T 4506 , F 221, S 8, H M 74275, I/A 69 (23.04.19).

24 de Febrero de 2017
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 25.- RETRIBUCION.- . Datos registrales. T 4506 , F 221, S 8, H M74275, I/A 68 (17.02.17).

20 de Enero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUADO GAVILAN ESTHER BEATRIZ;AGUADO RUBIO ENRIQUE;AGUADO GAVILAN MIGUELANGEL;AGUADO GARCIA SANTIAGO. Presidente: AGUADO GARCIA SANTIAGO. Secretario: AGUADO GAVILAN ESTHERBEATRIZ. Cons.Del.Sol: AGUADO GARCIA SANTIAGO;AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL;AGUADO RUBIO ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: AGUADO GARCIA SANTIAGO;AGUADO RUBIO ENRIQUE;AGUADO RUBIO SANTIAGO;AGUADOGAVILAN MIGUEL ANGEL;AGUADO GAVILAN EDUARDO;CHURTICHAGA GUTIERREZ FRANCISCO. Presidente: AGUADOGARCIA SANTIAGO. SecreNoConsj: RUEDA GONZALEZ PEDRO ANTONIO. Cons.Del.Sol: AGUADO GARCIA SANTIAGO;AGUADORUBIO ENRIQUE;AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4506 , F 220, S 8, H M 74275, I/A 67 (12.01.17).

22 de Julio de 2016
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 20 Y 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales.T 4506 , F 219, S 8, H M 74275, I/A 66 (15.07.16).

04 de Julio de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 396.082,30 Euros. Resultante Suscrito: 203.556,22 Euros. Escisi贸n parcial. Sociedades

12 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Auditor: AVANTER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4506 , F 217, S 8, H M 74275, I/A 64 ( 3.11.15).

22 de Enero de 2015
Otros conceptos: SE ACLARA Y SUBSANA LA ESCRITURA DE ESCISION TOTAL QUE CAUSO LA INSCRIPCION 60& DE LAHOJA SOCIAL. Datos registrales. T 4506 , F 216, S 8, H M 74275, I/A 63 (15.01.15).

03 de Junio de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ FLOREZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 4506 , F 216, S 8, H M 74275, I/A 61(27.05.14).

26 de Mayo de 2014
Otros conceptos: Beneficiaria de la Escisi贸n total de la entidad "LINEAS Y AUTOCARES SA" inscrita en el Registro Mercantil deMurcia en la hoja MU-8622. Datos registrales. T 4506 , F 211, S 8, H M 74275, I/A 60 (16.05.14).

01 de Abril de 2013
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DARRIBA BREOGAN. Datos registrales. T 4506 , F 210, S 8, H M 74275, I/A 59 (20.03.13).

29 de Enero de 2013
Ampliacion del objeto social. TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCIAS POR FERROCARRIL, CON APORTE DETRACCION, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL SECTOR FERROVIARIO... Datos registrales. T 4506 , F 210, S8, H M 74275, I/A 58 (22.01.13).

24 de Diciembre de 2012
Reelecciones. Auditor: AVANTER AUDITORES SL. Datos registrales. T 4506 , F 210, S 8, H M 74275, I/A 57 (17.12.12).

03 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: AGUADO GARCIA SANTIAGO;AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL;AGUADO RUBIO ENRIQUE.Nombramientos. Cons.Del.Sol: SANTIAGO AGUADO GARCIA;AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL;AGUADO RUBIO ENRIQUE.Reelecciones. Consejero: AGUADO GAVILAN ESTHER BEATRIZ;AGUADO RUBIO ENRIQUE;AGUADO GAVILAN MIGUELANGEL;AGUADO GARCIA SANTIAGO. Presidente: AGUADO GARCIA SANTIAGO. Secretario: AGUADO GAVILAN ESTHERBEATRIZ. Datos registrales. T 4506 , F 209, S 8, H M 74275, I/A 56 (24.07.12).

03 de Febrero de 2011
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.638,52 Euros. Desembolsado: 1.638,52 Euros. Resultante Suscrito: 599.638,52 Euros. ResultanteDesembolsado: 599.638,52 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: DAIBUS SL. Datos registrales. T 4506 , F 203,S 8, H M 74275, I/A 55 (20.01.11).

15 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: AVANTER AUDITORES SL. Datos registrales. T 4506 , F 203, S 8, H M 74275, I/A 54 ( 4.02.10).

11 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORALES FERNANDEZ JACINTO FRANCISCO. Datos registrales. T 4506 , F 202, S 8, H M 74275,I/A 53 ( 1.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n