Buscador CIF Logo

Actos BORME Inversion Corporativa I C Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Inversion Corporativa I C Sa

Actos BORME Inversion Corporativa I C Sa - A41105511

Tenemos registrados 38 Actos BORME del Registro Mercantil de Sevilla para Inversion Corporativa I C Sa con CIF A41105511

馃敊 Perfil de Inversion Corporativa I C Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Sevilla

Actos BORME de Inversion Corporativa I C Sa

20 de Junio de 2022
Otros conceptos: SE DESIGNA A PATRICIA AYA SAENZ EN SUSTITUCION DE ANA MARIA ABAURREA AYA POR RENUNCIADE ESTA COMO REPRESENTANTE PERSONA FISICA DE "INAYABA, S.L.", EN EL EJERCICIO DEL CARGO DE CONSEJERO YVICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD "INVERSION CORPORATIVA IC, S.A.". Datos registrales. T 6678 , F 205, S 8, H SE112145,I/A 17 (10.06.22).

31 de Agosto de 2021
Reelecciones. Consejero: BENJUMEA LLORENTE MARIA TERESA;INAYABA SL. Vicepresid.: INAYABA SL. Otros conceptos:"INAYABA, S.L." , designada como represennte persona fisica a D. Ana Mar铆a Abaurrea Aya, con DNI 27307132-Z. Datos registrales.T 6678 , F 205, S 8, H SE112145, I/A 16 (23.08.21).

12 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Consejero: BENJUMEA LLORENTE ELENA;SOLIS GUARDIOLA IGNACIO. Otros conceptos: La Junta General de31/07/2020 RATIFICA los nombramientos por cooptaci贸n realizados por el Consejo a favor de los CONSEJEROS don RICARDOABAURRE LLORENTE, Y DON FELIPE BENJUMEA LLORENTE.- Datos registrales. T 6678 , F 204, S 8, H SE112145, I/A 14 (3.11.20).

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: SOLIS GUARDIOLA IGNACIO. Presidente: SOLIS GUARDIOLA IGNACIO. Nombramientos.Presidente: BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Con.Delegado: BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Datos registrales. T 6678 , F 204, S8, H SE112145, I/A 15 ( 4.11.20).

01 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: BENJUMEA LLORENTE MERCEDES. Nombramientos. Consejero: BENJUMEA LLORENTEFELIPE. Datos registrales. T 6678 , F 203, S 8, H SE112145, I/A 13 (16.09.20).

03 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: ABAURRE LLORENTE JOSE JOAQUIN. Nombramientos. Consejero: ABAURRE LLORENTERICARDO. Datos registrales. T 6678 , F 203, S 8, H SE112145, I/A 12 (25.06.20).

25 de Septiembre de 2019
Fe de erratas: Seg煤n la inscripci贸n 7陋 el Administrador Concursal es "AATI CONCURSAL, SLP" y su representante persona f铆sica esdon Joaqu铆n Miguel Aguilar Cazorla.- Datos registrales. T 6309 , F 81, S 8, H SE112145, I/A 7 ( 8.03.19).

28 de Agosto de 2019
Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Otros conceptos: en la Junta General de 28/06/19 se RATIFICA el nombramientoefectuado por el sistema de cooptaci贸n en el seno de la reuni贸n del Consejo de Administraci贸n celebrado el d铆a 29/03/2019, en elaccionista DON CARLOS SUNDHEIM LOSADA, como CONSEJERO POR 5 A脩OS.- Datos registrales. T 6678 , F 202, S 8, HSE112145, I/A 11 (14.08.19).

05 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Consejero: BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Apo.Sol.:BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Presidente: BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Nombramientos. Consejero: SUNDHEIM LOSADACARLOS. Presidente: SOLIS GUARDIOLA IGNACIO. Con.Delegado: SOLIS GUARDIOLA IGNACIO. Datos registrales. T 6678 , F202, S 8, H SE112145, I/A 10 (24.06.19).

10 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apoderado: PEREZ CABA脩AS JUAN;MARTOS HINOJOSA SALVADOR;PAREJA GOMEZ JOSE. Apo.Manc.:MARCOS ROMERO JOSE;JIMENEZ LORA JUAN CARLOS. Apoderado: LUENGO MERINO LUIS;PEREZ RODRIGUEZ JESUS.Apo.Manc.: JIMENEZ LORA JUAN CARLOS;MARCOS ROMERO JOSE;JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL Datosregistrales. T 6678 , F 201, S 8, H SE112145, I/A 9 ( 3.05.19).

28 de Marzo de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.269.949,06 Euros. Resultante Suscrito: 56.426.050,94 Euros. Reducci贸n de capital.Importe reducci贸n: 49.793.148,49 Euros. Resultante Suscrito: 6.632.902,45 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de losestatutos: 5. Capital social.-. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6309 , F 82, S 8, H SE112145, I/A 8(15.03.19).

21 de Marzo de 2019
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 574/2018. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 8/01/2019. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE SEVILLA. Juez: MIGUEL ANGEL NAVARROROBLES. Resoluciones: PRACTICADA INSCRIPCION DE DECLARACION DE CONCURSO. ACUMULADO. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 574/2018. Fecha de resoluci贸n 8/01/2019. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 0 JUZGADODE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE SEVILLA. Juez: MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES. Administrador Concursal. Fecha8/01/2019, NIF/CIF 28879576V. AGUILAR CAZORLA JOAQUIN MIGUEL. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 574/2018.FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 8/01/2019. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸ny disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE SEVILLA. Juez: MIGUEL ANGELNAVARRO ROBLES. Resoluciones: INTERVENCION. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 574/2018. FIRME: Si, Fechade resoluci贸n 8/01/2019. Resoluci贸n judicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO3 DE SEVILLA. Juez: MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES. Resoluciones: Practicada la inscripci贸n de declaraci贸n de concursovoluntario de acumulaci贸n. Datos registrales. T 6309 , F 81, S 8, H SE112145, I/A 8 ( 8.03.19).

30 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BERTRAN SUNDHEIM FRANCISCO DE BORJA;GARCIA CARRANZA BENJUMEAJOSE;BENJUMEA LLORENTE JAVIER. Datos registrales. T 6309 , F 81, S 8, H SE112145, I/A 6 (19.07.18).

23 de Octubre de 2017
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. FINCACASA QUEMADA S/N (SANLUCAR LA MAYOR). Datos registrales. T 6309 , F 81, S 8, H SE112145, I/A 5 (11.10.17).

26 de Septiembre de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6309 , F 80, S 8, H SE112145, I/A 4(18.09.17).

24 de Enero de 2017
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Domicilio, Sucursales, Agencias y Delegaciones.-. Cambio de domiciliosocial. C/ CONCEJAL FRANCISCO BALLESTEROS 4 2 - EDIFICIO P (SEVILLA). Datos registrales. T 6309 , F 80, S 8, HSE112145, I/A 3 (13.01.17).

23 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: BENJUMEA BENJUMEA RAFAEL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: GARCIACARRANZA BENJUMEA JOSE. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Otros conceptos: RATIFICADOS EN SUS CARGOS DECONSEJERO-VICEPRESIDENTE LA MERCANTIL "INAYABA SL" y CONSEJERO DO脩A MARIA TERESA BENJUMEA LLORENTEDESDE 23 DE JUNIO DE 2016, POR PLAZO DE CINCO A脩OS. Datos registrales. T 24775 , F 224, S 8, H M 7821, I/A 94(16.09.16).

08 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: INAYABASL;BENJUMEA LLORENTE MARIA TERESA. SecreNoConsj: MARISCAL SIERRA MANUEL. Representan: ABAURREA AYA ANAMARIA. Vicepresid.: INAYABA SL. Datos registrales. T 24775 , F 222, S 8, H M 7821, I/A 92 (29.07.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Datos registrales. T 24775 , F 224, S 8, H M 7821, I/A 93 (29.07.16).

20 de Junio de 2016
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: JIMENEZ VELASCO MAZARIO MIGUELANGEL;MARCOS ROMERO JOSE;JIMENEZ LORA JUAN CARLOS;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Nombramientos. Apo.Sol.:GARCIA COLLADOS LUCIANO;MARQUEZ GONZALEZ JUAN. Datos registrales. T 24775 , F 222, S 8, H M 7821, I/A 91 (10.06.16).

24 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: PALMERA NUEVE SA;AYA ABAURRE JOSE LUIS;BENJUMEA LLORENTE FRANCISCOJAVIER;ABAURRE LLORENTE JOSE JOAQUIN;BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Presidente: BENJUMEA LLORENTE FELIPE.Vicepresid.: AYA ABAURRE JOSE LUIS. Cons.Del.Sol: BENJUMEA LLORENTE FELIPE;AYA ABAURRE JOSE LUIS. Consejero:VALDEMEDE FINANCIERA SL;SOLIS MARTINEZ CAMPOS FERNANDO;SOLIS GUARDIOLA IGNACIO;DOMINGUEZ ABASCALJOSE. Vicepr.2: DOMINGUEZ ABASCAL JOSE. Consejero: BENJUMEA LLORENTE MARIA MERCEDES. Representan: SUNDHEIM

Nombramientos. Cons.Del.Sol: BENJUMEA LLORENTE FELIPE;AYA ABAURRE JOSE LUIS. Datos registrales. T 24775 , F 221, S8, H M 7821, I/A 90 (15.12.15).

30 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA COLLADOS LUCIANO. Datos registrales. T 24775 , F 220, S 8, H M 7821, I/A 88 (23.10.15).

05 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: BENJUMEA LLORENTE MARIA VICTORIA. Nombramientos. Consejero: BENJUMEA LLORENTEMARIA MERCEDES. Vicepr.2: DOMINGUEZ ABASCAL JOSE. Reelecciones. Consejero: BENJUMEA LLORENTE MARIAMERCEDES. Datos registrales. T 24775 , F 220, S 8, H M 7821, I/A 87 (28.07.15).

24 de Abril de 2015
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GOMEZ-SANCHA TRUEBA IGNACIO. Nombramientos. SecreNoConsj: JIMENEZ-VELASCOMAZARIO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 24775 , F 219, S 8, H M 7821, I/A 86 (15.04.15).

07 de Abril de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: BENJUMEA LLORENTE ELENA MARIA. Consejero: VALDEMEDE SL. Nombramientos.Consejero: VALDEMEDE FINANCIERA SL;DOMINGUEZ ABASCAL JOSE. Representan: SUNDHEIM LOSADA ANA MARIA.Reelecciones. Consejero: SOLIS MARTINEZ CAMPOS FERNANDO;SOLIS GUARDIOLA IGNACIO. Datos registrales. T 24775 , F219, S 8, H M 7821, I/A 85 (26.03.15).

12 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: CORREA PORTILLO SANTIAGO;JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;MARCOSROMERO JOSE;JIMENEZ LORA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 24775 , F 218, S 8, H M 7821, I/A 84 ( 5.02.15).

24 de Octubre de 2013
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: BENJUMEA LLORENTE MARIA JESUS. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 2潞. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 43 - 6潞-PLANTA (MADRID).Datos registrales. T 24775 , F 218, S 8, H M 7821, I/A 83 (17.10.13).

19 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: JIMENEZ VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. SecreNoConsj: GOMEZ-SANCHA TRUEBA IGNACIO. Datos registrales. T 24775 , F 217, S 8, H M 7821, I/A 82 (11.02.13).

19 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Consejero: BENJUMEA LLORENTE MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 24775 , F 217, S 8, H M 7821, I/A 80(30.08.12).

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 24775 , F 217, S 8, H M 7821, I/A 81 (30.08.12).

25 de Mayo de 2012
Nombramientos. Cons.Del.Sol: BENJUMEA LLORENTE FELIPE;AYA ABAURRE JOSE LUIS. Datos registrales. T 24775 , F 216, S8, H M 7821, I/A 79 (11.05.12).

14 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 24775 , F 216, S 8, H M 7821, I/A 78 ( 1.12.11).

13 de Diciembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Cons.Del.Sol: AYA ABAURRE JOSE LUIS;BENJUMEALLORENTE FELIPE. Nombramientos. Representan: BENJUMEA LLORENTE ELENA MARIA. Reelecciones. Consejero:PALMERA NUEVE SA;AYA ABAURRE JOSE LUIS;BENJUMEA LLORENTE FRANCISCO JAVIER;ABAURRE LLORENTE JOSEJOAQUIN;BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Presidente: BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Vicepresid.: AYA ABAURRE JOSE LUIS.Datos registrales. T 24775 , F 215, S 8, H M 7821, I/A 77 (29.11.11).

16 de Noviembre de 2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 24775 , F 215, S 8, H M 7821, I/A 76 ( 3.11.10).

21 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: SUNDHEIM LOSADA CARLOS. Nombramientos. Consejero: VALDEMEDE SL. Representan:SUNDHEIM LOSADA ANA MARIA. Reelecciones. Consejero: SOLIS MARTINEZ CAMPOS FERNANDO;SOLIS GUARDIOLAIGNACIO. Datos registrales. T 24775 , F 214, S 8, H M 7821, I/A 74 ( 1.09.09).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 24775 , F 215, S 8, H M 7821, I/A 75 ( 1.09.09).

07 de Enero de 2009
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: BENJUMEA LLORENTE FRANCISCO JAVIER;BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Presidente:BENJUMEA LLORENTE FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Nombramientos. Presidente:BENJUMEA LLORENTE FELIPE. Vicepresid.: AYA ABAURRE JOSE LUIS. Cons.Del.Sol: AYA ABAURRE JOSE LUIS;BENJUMEALLORENTE FELIPE. Datos registrales. T 24775 , F 214, S 8, H M 7821, I/A 73 (22.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n