Actos BORME de Inversiones Ameca Sl
24 de Septiembre de 2021Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 36265 , F 103, S 8, H M 308888, I/A 12 (18.09.21).
09 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLEGAS RAMIREZ PAULINO J. Secretario: VILLEGAS RAMIREZ PAULINO J. Nombramientos.Secretario: MERINA CASTILLA ANTONIO TOMAS. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 107.100,00 Euros. ResultanteSuscrito: 1.422.900,00 Euros. Datos registrales. T 36265 , F 102, S 8, H M 308888, I/A 11 ( 2.02.21).
14 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ARANDA JIMENEZ JOSE RAMON. Vicepresid.: ARANDA JIMENEZ JOSE RAMON. Datosregistrales. T 36265 , F 102, S 8, H M 308888, I/A 9 ( 7.05.19).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MERINA ORTEGA TOMAS. Nombramientos. Consejero: MERINA CASTILLA ANTONIOTOMAS. Con.Delegado: MERINA CASTILLA ANTONIO TOMAS. Reelecciones. Presidente: MERINA ORTEGA TOMAS. Secretario:VILLEGAS RAMIREZ PAULINO J. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 21潞 de los estatutos sociales. Retribuci贸n..Datos registrales. T 36265 , F 102, S 8, H M 308888, I/A 10 ( 7.05.19).
10 de Octubre de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 270.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.530.000,00 Euros. Datos registrales. T 36265 ,F 100, S 8, H M 308888, I/A 8 ( 2.10.18).
10 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: MERINA CASTILLA ANTONIO TOMAS. Datos registrales. T 17895 , F 45, S 8, H M 308888, I/A 7 (2.10.17).
06 de Marzo de 2013Reelecciones. Consejero: CASTILLA OCAMPO ANGELA;MERINA ORTEGA TOMAS;VILLEGAS RAMIREZ PAULINO J. Presidente:MERINA ORTEGA TOMAS. Secretario: VILLEGAS RAMIREZ PAULINO J. Con.Delegado: MERINA ORTEGA TOMAS. Consejero:ARANDA JIMENEZ JOSE RAMON. Vicepresid.: ARANDA JIMENEZ JOSE RAMON. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA ELARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS.. Datos registrales. T 17895 , F 45, S 8, H M 308888, I/A 6 (26.02.13).
23 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: DIAZ NAVARRO ANA MARIA. Nombramientos. Consejero: ARANDA JIMENEZ JOSE RAMON.Vicepresid.: ARANDA JIMENEZ JOSE RAMON. Ampliaci贸n de capital. Capital: 618.000,00 Euros. Resultante Suscrito:1.800.000,00 Euros. Datos registrales. T 17895 , F 44, S 8, H M 308888, I/A 5 (11.12.09).
20 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CASTILLA OCAMPO ANGELA MARIA;MERINA CASTILLA ALICIA. Nombramientos. Consejero:CASTILLA OCAMPO ANGELA;MERINA ORTEGA TOMAS;VILLEGAS RAMIREZ PAULINO J;DIAZ NAVARRO ANA MARIA.Presidente: MERINA ORTEGA TOMAS. Vicepresid.: DIAZ NAVARRO ANA MARIA. Secretario: VILLEGAS RAMIREZ PAULINO J.Con.Delegado: MERINA ORTEGA TOMAS. Ampliaci贸n de capital. Capital: 972.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.182.000,00Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n.SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 19, 20 Y 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Ampliacion del objeto social. CONSULTORIA YASESORAMIENTO INTEGRAL DE EMPRESAS DEL SECTOR SANITARIO. Datos registrales. T 17895 , F 41, S 8, H M 308888, I/A4 (10.02.09).