Buscador CIF Logo

Actos BORME Inversiones Financieras Suton Pl Sicav Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Inversiones Financieras Suton Pl Sicav Sociedad Anonima

Actos BORME Inversiones Financieras Suton Pl Sicav Sociedad Anonima - A95485371

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Inversiones Financieras Suton Pl Sicav Sociedad Anonima con CIF A95485371

馃敊 Perfil de Inversiones Financieras Suton Pl Sicav Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Inversiones Financieras Suton Pl Sicav Sociedad Anonima

20 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Ent. Gestora: CONSULNOR GESTION SA;MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA. Ent.Reg.Cont:IBERCLEAR SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE R. Consejero: MENDEZ ROTH JOSE ANTONIO;FALCONFERRANDO MARIA JOSE. Secretario: FALCON FERRANDO MARIA JOSE. Consejero: ESCRIBANO MENA FRANCISCO JAVIER.Presidente: ESCRIBANO MENA FRANCISCO JAVIER. EntidDeposit: BANCA MARCH SA. Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL.Nombramientos. Liquidador: MAGA脩A LIMON DAVID VICENTE. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 27637 ,F 70, S 8, H M 498042, I/A 15 (13.12.22).

23 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTEGA LOPEZ DE SANTA MARIA JOSE MARIA. Presidente: ORTEGA LOPEZ DE SANTA MARIAJOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: ESCRIBANO MENA FRANCISCO JAVIER. Presidente: ESCRIBANO MENAFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 27637 , F 69, S 8, H M 498042, I/A 14 (16.04.21).

11 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: ONZAIN GUTIERREZ JESUS. Secretario: ONZAIN GUTIERREZ JESUS. Nombramientos.Consejero: FALCON FERRANDO MARIA JOSE. Secretario: FALCON FERRANDO MARIA JOSE. Reelecciones. Auditor: DELOITTESL. Datos registrales. T 27637 , F 69, S 8, H M 498042, I/A 13 ( 3.11.20).

16 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: CANALES ABAITUA RAFAEL AGUSTIN. Presidente: CANALES ABAITUA RAFAEL AGUSTIN.Con.Delegado: CANALES ABAITUA RAFAEL AGUSTIN. Consejero: DE LA CRUZ O脩ATE MARIA VEGA. Nombramientos.Consejero: MENDEZ ROTH JOSE ANTONIO;ORTEGA LOPEZ DE SANTA MARIA JOSE MARIA. Presidente: ORTEGA LOPEZ DESANTA MARIA JOSE MARIA. Datos registrales. T 27637 , F 68, S 8, H M 498042, I/A 12 ( 8.08.19).

07 de Septiembre de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: ONZAIN GUTIERREZ JESUS. Secretario: ONZAIN GUTIERREZ JESUS.Consejero: DE LA CRUZ O脩ATE MARIA VEGA. Datos registrales. T 27637 , F 68, S 8, H M 498042, I/A 11 (30.08.17).

29 de Julio de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 27637 , F 68, S 8, H M 498042, I/A 10 (21.07.16).

21 de Abril de 2016
Ceses/Dimisiones. Ent.Reg.Cont: SERVICIO COMPENSACION LIQUIDACION VALORES SA. Nombramientos. Ent.Reg.Cont:IBERCLEAR SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE R. Datos registrales. T 27637 , F 67, S 8, H M 498042, I/A 9(13.04.16).

17 de Septiembre de 2014
Reelecciones. Consejero: CANALES ABAITUA RAFAEL AGUSTIN. Presidente: CANALES ABAITUA RAFAEL AGUSTIN.Con.Delegado: CANALES ABAITUA RAFAEL AGUSTIN. Datos registrales. T 27637 , F 67, S 8, H M 498042, I/A 8 ( 9.09.14).

28 de Febrero de 2014
Nombramientos. Con.Delegado: CANALES ABAITUA RAFAEL AGUSTIN. Apoderado: MARCH GESTION DE FONDOS SGIIC SA.Datos registrales. T 27637 , F 67, S 8, H M 498042, I/A 7 (24.02.14).

31 de Julio de 2013
Ceses/Dimisiones. EntidDeposit: BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA. Ent. Gestora: CONSULNOR GESTION SGIIC SOCIEDADANONIMA. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Ent. Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS SGIIC SA. Auditor:DELOITTE SL. EntidDeposit: BANCA MARCH SA. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LOSESTATUTOS SOCIALES.. Cambio de domicilio social. C/ CASTELLO, 74 (MADRID). Datos registrales. T 27637 , F 66, S 8, H M498042, I/A 6 (23.07.13).

07 de Diciembre de 2012
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS.. Datos registrales. T 27637 , F 65, S 8, H M498042, I/A 5 (28.11.12).

20 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: ONZAIN GUTIERREZ JESUS;DE LA CRUZ O脩ATE MARIA VEGA. Secretario: ONZAIN GUTIERREZJESUS. Nombramientos. Consejero: ONZAIN GUTIERREZ JESUS. Secretario: ONZAIN GUTIERREZ JESUS. Consejero: DE LACRUZ O脩ATE MARIA VEGA. Datos registrales. T 27637 , F 65, S 8, H M 498042, I/A 4 (27.07.12).

22 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27637 ,F 65, S 8, H M 498042, I/A 3 (10.11.11).

19 de Abril de 2010
Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ, - NUMERO 12, 5潞 (MADRID). Datos registrales. T 27637 , F 64, S 8, H M 498042, I/A2 ( 7.04.10).

08 de Abril de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: MIJANGOS UGARTE ANA;MINGUEZ ROPI脩ON ARANZAZU;CORRAL BASTERRA DIEGO.Presidente: MIJANGOS UGARTE ANA. Nombramientos. Consejero: CANALES ABAITUA RAFAEL AGUSTIN. Presidente:CANALES ABAITUA RAFAEL AGUSTIN. Datos registrales. T 4630 , F 44, S 8, H BI 49978, I/Acierr (15.03.10).

20 de Julio de 2009
Otros conceptos: la cifra efectiva del capital social suscrito al cierre delejercicio economico 2008, asciende a 2.400.624 euros. Datosregistrales. T 4630 , F 41, S 8, H BI 49978, I/A 1 m ( 1.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n