Actos BORME de Inversiones Garibay Sa
11 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. LiquiSoli: OTEGUI ARTAZA JUAN;ALLENDE WAKONIGG LUIS MARIA;OTEGUI ARTAZA JAIME. Extinci贸n.Datos registrales. T 2699 , F 156, S 8, H SS 15350, I/A 24 (27.10.16).
01 de Julio de 2015Nombramientos. Apoderado: FORTIN ALVAREZ FRANCISCO. Datos registrales. T 2699 , F 156, S 8, H SS 15350, I/A 22(19.06.15).
08 de Junio de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 160.091,60 Euros. Resultante Suscrito: 6.045.974,00 Euros. Datos registrales. T 1742 , F120, S 8, H SS 15350, I/A 21 (27.05.15).
09 de Octubre de 2014Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SOCIEDAD DE INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIA. Datos registrales.T 1742 , F 119, S 8, H SS 15350, I/A 18 (26.09.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ECHEVARRIA ABONA JAIME. Presidente: ECHEVARRIA ABONA JAIME. Con.Delegado:ECHEVARRIA ABONA JAIME. Nombramientos. Presidente: ARSUAGA CORTAZAR ALFONSO. Consejero: BURUTARANUSANDIZAGA IGNACIO. Datos registrales. T 1742 , F 120, S 8, H SS 15350, I/A 19 (26.09.14).
Nombramientos. Apoderado: ARSUAGA CORTAZAR ALFONSO. Datos registrales. T 1742 , F 120, S 8, H SS 15350, I/A 20(30.09.14).
04 de Septiembre de 2014Reelecciones. Consejero: ARSUAGA CORTAZAR ALFONSO. Datos registrales. T 1742 , F 118, S 8, H SS 15350, I/A 17(25.08.14).
11 de Septiembre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 460.575,20 Euros. Resultante Suscrito: 6.206.065,60 Euros. Datos registrales. T 1742 , F118, S 8, H SS 15350, I/A 16 (30.08.13).
10 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MANUEL. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ GUTIERREZLUIS MANUEL. Secretario: GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MANUEL. Datos registrales. T 1742 , F 118, S 8, H SS 15350, I/A 15(31.12.12).
22 de Septiembre de 2011Cambio de domicilio social. C/ OQUENDO 13 3潞 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). Datos registrales. T 1742 , F 117, S 8, H SS15350, I/A 14 (13.09.11).
21 de Julio de 2011Otros conceptos: Modificaci贸n de los art铆culos 1潞, 8潞, 10潞, 11潞, 13潞, 14潞 y 19潞 de los Estatutos sociales, al objeto de adaptar losmismos a la Ley de Sociedades de Capital. Datos registrales. T 1742 , F 117, S 8, H SS 15350, I/A 13 (12.07.11).
22 de Julio de 2010Nombramientos. Consejero: ECHEVARRIA ABONA JAIME. Presidente: ECHEVARRIA ABONA JAIME. Datos registrales. T 1742 ,F 116, S 8, H SS 15350, I/A 12 (14.07.10).
22 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: URTASUN ERRO FERMIN. Secretario: URTASUN ERRO FERMIN. Presidente: ARSUAGACORTAZAR ALFONSO. Con.Delegado: ARSUAGA CORTAZAR ALFONSO. Nombramientos. Secretario: GONZALEZ GUTIERREZLUIS-MANUEL. Presidente: ECHEVARRIA ABONA JAIME. Consejero: ECHEVARRIA ABONA JAIME. Con.Delegado: ECHEVARRIAABONA JAIME. Datos registrales. T 1742 , F 116, S 8, H SS 15350, I/A 11 (13.04.10).
25 de Agosto de 2009Reelecciones. Consejero: ARSUAGA CORTAZAR ALFONSO;URTASUN ERRO FERMIN. Presidente: ARSUAGA CORTAZARALFONSO. Secretario: URTASUN ERRO FERMIN. Con.Delegado: ARSUAGA CORTAZAR ALFONSO. Datos registrales. T 1742 , F116, S 8, H SS 15350, I/A 10 (13.08.09).