Buscador CIF Logo

Actos BORME Inversiones Guzman Fernandez Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Inversiones Guzman Fernandez Sl

Actos BORME Inversiones Guzman Fernandez Sl - B91183749

Tenemos registrados 6 Actos BORME del Registro Mercantil de Sevilla para Inversiones Guzman Fernandez Sl con CIF B91183749

馃敊 Perfil de Inversiones Guzman Fernandez Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Sevilla

Actos BORME de Inversiones Guzman Fernandez Sl

05 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 4965 , F 155, S 8, H SE 47092,I/A 12 (28.11.22).

08 de Julio de 2022
Ceses/Dimisiones. Presidente: GUZMAN CHARNECO JUAN. Secretario: FERNANDEZ GARCIA DOLORES. Vicepresid.: GUZMANFERNANDEZ JUAN MIGUEL. Vicesecret.: GUZMAN FERNANDEZ MARIA DOLORES. Nombramientos. Presidente: GUZMANFERNANDEZ JUAN MIGUEL. Secretario: GUZMAN FERNANDEZ MARIA DOLORES. Vicepresid.: GUZMAN FERNANDEZ CARLOS.Con.Delegado: GUZMAN FERNANDEZ JUAN MIGUEL. Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 22潞.- Duraci贸n del cargo deadministrador y retribuci贸n.- . Otros conceptos: REVOCA Y DEJA SIN EFECTOS CUANTOS PODERES Y DELEGACION DEFACULTADES DEL CONSEJO SE LE HUBIERAN OTORGADO CON ANTERIORIDAD AL 30/06/2022 A FAVOR DE DON JUANGUZMAN CHARNECO Y A DO脩A MARIA DOLORES FERNANDEZ GARCIA, NO CONSTANDO INSCRITO PODER ALGUNO.Datos registrales. T 4965 , F 154, S 8, H SE 47092, I/A 11 (30.06.22).

17 de Mayo de 2022
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 18.384,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.228.019,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. 21. Eliminaci贸n de la exigencia de ostentar la condici贸n de socio para ser administrador,.Datos registrales. T 4965 , F 153, S 8, H SE 47092, I/A 10 ( 9.05.22).

28 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 4965 , F 153, S 8, H SE 47092, I/A9 (21.12.21).

22 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: GUZMAN FERNANDEZ JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 4965 , F 153, S 8, H SE 47092, I/A 8(14.02.18).

24 de Mayo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CEPERO DIAZ JOSE MANUEL. Secretario: CEPERO DIAZ JOSE MANUEL. Vicepresid.:FERNANDEZ GARCIA DOLORES. Nombramientos. Secretario: FERNANDEZ GARCIA DOLORES. Modificaciones estatutarias.22. Duraci贸n del cargo de Administrador y retribuci贸n.-. Datos registrales. T 3405 , F 46, S 8, H SE 47092, I/A 7 (10.05.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n