Actos BORME de Inversiones Guzman Fernandez Sl
05 de Diciembre de 2022Nombramientos. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 4965 , F 155, S 8, H SE 47092,I/A 12 (28.11.22).
08 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Presidente: GUZMAN CHARNECO JUAN. Secretario: FERNANDEZ GARCIA DOLORES. Vicepresid.: GUZMANFERNANDEZ JUAN MIGUEL. Vicesecret.: GUZMAN FERNANDEZ MARIA DOLORES. Nombramientos. Presidente: GUZMANFERNANDEZ JUAN MIGUEL. Secretario: GUZMAN FERNANDEZ MARIA DOLORES. Vicepresid.: GUZMAN FERNANDEZ CARLOS.Con.Delegado: GUZMAN FERNANDEZ JUAN MIGUEL. Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 22潞.- Duraci贸n del cargo deadministrador y retribuci贸n.- . Otros conceptos: REVOCA Y DEJA SIN EFECTOS CUANTOS PODERES Y DELEGACION DEFACULTADES DEL CONSEJO SE LE HUBIERAN OTORGADO CON ANTERIORIDAD AL 30/06/2022 A FAVOR DE DON JUANGUZMAN CHARNECO Y A DO脩A MARIA DOLORES FERNANDEZ GARCIA, NO CONSTANDO INSCRITO PODER ALGUNO.Datos registrales. T 4965 , F 154, S 8, H SE 47092, I/A 11 (30.06.22).
17 de Mayo de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 18.384,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.228.019,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. 21. Eliminaci贸n de la exigencia de ostentar la condici贸n de socio para ser administrador,.Datos registrales. T 4965 , F 153, S 8, H SE 47092, I/A 10 ( 9.05.22).
28 de Diciembre de 2021Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 4965 , F 153, S 8, H SE 47092, I/A9 (21.12.21).
22 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: GUZMAN FERNANDEZ JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 4965 , F 153, S 8, H SE 47092, I/A 8(14.02.18).
24 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: CEPERO DIAZ JOSE MANUEL. Secretario: CEPERO DIAZ JOSE MANUEL. Vicepresid.:FERNANDEZ GARCIA DOLORES. Nombramientos. Secretario: FERNANDEZ GARCIA DOLORES. Modificaciones estatutarias.22. Duraci贸n del cargo de Administrador y retribuci贸n.-. Datos registrales. T 3405 , F 46, S 8, H SE 47092, I/A 7 (10.05.12).