Actos BORME de Inversiones Inmobiliarias Cre Sl
18 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: RIOS PESET MERCEDES. Cons.Del.Man: RIOS PESET MERCEDES. Consejero: SALAZARGARCIA JORGE. Cons.Del.Man: SALAZAR GARCIA JORGE. Consejero: MARTIN MARCO JOSE-RAMON. Cons.Del.Man: MARTINMARCO JOSE-RAMON. Nombramientos. Consejero: BEITIA BASTIDA MARIA BEGO脩A;GONZALEZ DEL VALLE GARCIAFRANCISCO JAVIER;CALVO GONZALEZ-VALLINAS DULCE MARIA. Cons.Del.Man: BEITIA BASTIDA MARIA BEGO脩A;GONZALEZDEL VALLE GARCIA FRANCISCO JAVIER;CALVO GONZALEZ-VALLINAS DULCE MARIA. Reelecciones. Consejero: TABARESCUADRADO JOSE MIGUEL. Cons.Del.Man: TABARES CUADRADO JOSE MIGUEL. Presidente: TABARES CUADRADO JOSEMIGUEL. Consejero: RAMIREZ-CARDENAS GIL JOSE MARIA. Secretario: RAMIREZ-CARDENAS GIL JOSE MARIA. Cons.Del.Man:RAMIREZ-CARDENAS GIL JOSE MARIA. Consejero: RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA DEL PILAR. Cons.Del.Man: RODRIGUEZALVAREZ MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 25916 , F 119, S 8, H M 316062, I/A 25 (11.02.22).
28 de Febrero de 2020Nombramientos. Consejero: MARTIN MARCO JOSE-RAMON. Cons.Del.Man: MARTIN MARCO JOSE-RAMON. Datos registrales.T 25916 , F 119, S 8, H M 316062, I/A 24 (21.02.20).
17 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ENTRALA BUENO EDUARDO. Cons.Del.Man: ENTRALA BUENO EDUARDO. Datos registrales. T25916 , F 119, S 8, H M 316062, I/A 23 (10.01.20).
31 de Agosto de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.306,75 Euros. Resultante Suscrito: 498.821,25 Euros. Datos registrales. T 25916 , F118, S 8, H M 316062, I/A 22 (24.08.18).
15 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: GINER GARGALLO ANTONIO;GOMEZ JENE FRANCISCO JAVIER;OZAMIZ FORTISNIEVES;RAMOS BLANES ANTONIO JOSE;BARBIER GAMINDE GERMAN. Secretario: GOMEZ JENE FRANCISCO JAVIER.Vicepresid.: RAMOS BLANES ANTONIO JOSE. Cons.Del.Man: GINER GARGALLO ANTONIO;GOMEZ JENE FRANCISCO JAVIER.Presidente: GINER GARGALLO ANTONIO. Cons.Del.Man: OZAMIZ FORTIS NIEVES;RAMOS BLANES ANTONIO JOSE;BARBIERGAMINDE GERMAN. Consejero: DIAZ FRAILE JUAN MARIA. Cons.Del.Man: DIAZ FRAILE JUAN MARIA. Nombramientos.Consejero: TABARES CUADRADO JOSE MIGUEL. Cons.Del.Man: TABARES CUADRADO JOSE MIGUEL. Presidente: TABARESCUADRADO JOSE MIGUEL. Consejero: RAMIREZ-CARDENAS GIL JOSE MARIA. Secretario: RAMIREZ-CARDENAS GIL JOSEMARIA. Cons.Del.Man: RAMIREZ-CARDENAS GIL JOSE MARIA. Consejero: ENTRALA BUENO EDUARDO. Cons.Del.Man:ENTRALA BUENO EDUARDO. Consejero: RIOS PESET MERCEDES. Cons.Del.Man: RIOS PESET MERCEDES. Consejero:RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA DEL PILAR. Cons.Del.Man: RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA DEL PILAR. Consejero: SALAZARGARCIA JORGE. Cons.Del.Man: SALAZAR GARCIA JORGE. Datos registrales. T 25916 , F 117, S 8, H M 316062, I/A 21 ( 8.02.18).
16 de Enero de 2017Nombramientos. Consejero: DIAZ FRAILE JUAN MARIA. Cons.Del.Man: DIAZ FRAILE JUAN MARIA. Datos registrales. T 25916 ,F 117, S 8, H M 316062, I/A 20 ( 3.01.17).
24 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: BLANCO URZAIZ JORGE. Cons.Del.Man: BLANCO URZAIZ JORGE. Datos registrales. T 25916 , F116, S 8, H M 316062, I/A 18 (14.06.16).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO UREBA MANUEL. Cons.Del.Man: ALONSO UREBA MANUEL. Datos registrales. T 25916, F 116, S 8, H M 316062, I/A 19 (15.06.16).
21 de Diciembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 28.194.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.290.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:5.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 105.290.000,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 101.351.101,00 Euros.Resultante Suscrito: 3.938.899,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.438.771,00 Euros. Resultante Suscrito:500.128,00 Euros. Datos registrales. T 25916 , F 114, S 8, H M 316062, I/A 17 (14.12.15).
15 de Septiembre de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 75.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 72.096.000,00 Euros. Datos registrales. T 25916 ,F 114, S 8, H M 316062, I/A 16 ( 5.09.14).
22 de Enero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: DE GRADO SANZ MARIA DEL CARMEN;DE ECHAVE-SUSTAETA Y DE LA TORRE MARIAANGELES;TORRES GARCIA JOSE. Presidente: DE GRADO SANZ MARIA DEL CARMEN. Cons.Del.Man: DE GRADO SANZ MARIADEL CARMEN;DE ECHAVE-SUSTAETA Y DE LA TORRE MARIA ANGELES;TORRES GARCIA JOSE. Vicepresid.: DE ECHAVE-SUSTAETA Y DE LA TORRE MARIA ANGELES. Vicesecret.: TORRES GARCIA JOSE. Consejero: SOLER GARCIA JULIO.
07 de Diciembre de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 189.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 72.171.000,00 Euros. Modificacionesestatutarias. MODIFICADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES Y SUSTITUIDOS POR OTROS DE NUEVA REDACCION. Cambio dedomicilio social. C/ DIEGO DE LEON 21 (MADRID). P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: iicre.es.Datos registrales. T 25916 , F 110, S 8, H M 316062, I/A 13 (27.11.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: SIEIRA GIL JESUS. Vicepresid.: SIEIRA GIL JESUS. Cons.Del.Man: SIEIRA GIL JESUS.Nombramientos. Vicepresid.: DE ECHAVE-SUSTAETA Y DE LA TORRE MARIA ANGELES. Vicesecret.: TORRES GARCIA JOSE.Datos registrales. T 25916 , F 113, S 8, H M 316062, I/A 14 (28.11.12).
23 de Diciembre de 2011Modificaciones estatutarias. 10. Derecho de voto de las distintas Clases de Participaciones. Datos registrales. T 25916 , F 109, S8, H M 316062, I/A 12 (13.12.11).
03 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: ARGUELLES PINTOS JOSE. Secr.Com.Inv: ARGUELLES PINTOS JOSE. Nombramientos.Secretario: SOLER GARCIA JULIO. Secr.Com.Inv: SOLER GARCIA JULIO. Datos registrales. T 25916 , F 109, S 8, H M 316062, I/A11 (22.07.10).
01 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: ALFIN MASSOT JOSE MARIA. Consejero: ALFIN MASSOT JOSE MARIA;JORDANA DE POZASGONZALBEZ JOSE ANTONIO. Vicepresid.: JORDANA DE POZAS GONZALBEZ JOSE ANTONIO. Consejero: ALVAREZ PEREZMARIANO;RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA;BARRIGA RINCON VALENTIN. Pres.Com.Inv: ALFIN MASSOT JOSE MARIA.Revocaciones. Apo.Manc.: ALFIN MASSOT JOSE MARIA;JORDANA DE POZAS GONZALBEZ JOSE ANTONIO;BARRIGA RINCONVALENTIN;ALVAREZ PEREZ MARIANO;RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: DE GRADO SANZ MARIA DELCARMEN;SIEIRA GIL JESUS;SOLER GARCIA JULIO;DE ECHAVE-SUSTAETA Y DE LA TORRE MARIA ANGELES;TORRESGARCIA JOSE. Presidente: DE GRADO SANZ MARIA DEL CARMEN. Vicepresid.: SIEIRA GIL JESUS. Cons.Del.Man: BABIERGAMINDE GERMAN;SOLER GARCIA JULIO;DE GRADO SANZ MARIA DEL CARMEN;SIEIRA GIL JESUS;ALONSO UREBAMANUEL;DE ECHAVE-SUSTAETA Y DE LA TORRE MARIA ANGELES;TORRES GARCIA JOSE. Datos registrales. T 25916 , F107, S 8, H M 316062, I/A 10 (16.02.10).
22 de Diciembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 14.472.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 72.360.000,00 Euros. Datos registrales. T 25916 , F 104,S 8, H M 316062, I/A 9 (10.12.09).
20 de Agosto de 2009Nombramientos. Pres.Com.Inv: ALFIN MASSOT JOSE MARIA. M.Com.Inv: SOLER GARCIA JULIO;HERNANDEZ GIL MANCHAMANUEL ANTONIO. Secr.Com.Inv: ARGUELLES PINTOS JOSE. Consejero: BABIER GAMINDE GERMAN;ALONSO UREBAMANUEL. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 10潞 Y 13潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Comisi贸n de Inversiones. Datos registrales. T 25916 , F 101, S 8, H M316062, I/A 8 ( 7.08.09).
05 de Febrero de 2009P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 25916 , F 99, S 8, H M 316062, I/A 6 (23.01.09).
Nombramientos. Apo.Manc.: ALFIN MASSOT JOSE MARIA;JORDANA DE POZAS GONZALBEZ JOSE ANTONIO;BARRIGARINCON VALENTIN;ALVAREZ PEREZ MARIANO;RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 25916 , F 99, S 8, H M316062, I/A 7 (23.01.09).