Buscador CIF Logo

Actos BORME Inversiones Inmobiliarias Limara Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Inversiones Inmobiliarias Limara Sl

Actos BORME Inversiones Inmobiliarias Limara Sl - B87703260

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Inversiones Inmobiliarias Limara Sl con CIF B87703260

馃敊 Perfil de Inversiones Inmobiliarias Limara Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Inversiones Inmobiliarias Limara Sl

19 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 43730 , F 132, S 8, H M 636973, I/A 30 (12.12.23).

04 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: ALCAY MORANDEIRA CARLOS JESUS. Apo.Sol.: ALCAY MORANDEIRA CARLOS JESUS;MARTINEZMARISCAL JOSE JOAQUIN. Apo.Man.Soli: MELGAR SABATER DAVID. Apo.Manc.: MANZANO SANCHEZ PATRICIA. Apo.Sol.:

19 de Septiembre de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ GARCIA LAURA. Apo.Manc.: GRA脩A FAJARDO VANESSA. Apo.Sol.: FERNANDEZGARCIA LAURA. Apo.Man.Soli: CASAJUANA MIRAS ALBERT. Apo.Manc.: SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DELCANTO;ESTEBANEZ FERNANDEZ MONICA. Apo.Sol.: DEL VAL MARTINEZ JORGE. Datos registrales. T 43730 , F 131, S 8, H M636973, I/A 28 (12.09.23).

04 de Septiembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Representan: FERNANDEZ GARCIA LAURA. Nombramientos. Representan: ACOSTA RAMIREZ MIGUELPEDRO. Datos registrales. T 43730 , F 131, S 8, H M 636973, I/A 27 (28.08.23).

13 de Junio de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: BLAZQUEZ MARQUEZ ADOLFO. Apo.Man.Soli: BLAZQUEZ MARQUEZ ADOLFO;DIAZ LATORREANTONIO MARIA;MENENDEZ MATHE GIL;RISUE脩O LLAMAS EVA MARIA. Apo.Manc.: MARTIN CABRERA PEDRO. Datosregistrales. T 43730 , F 131, S 8, H M 636973, I/A 26 ( 6.06.23).

25 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: CAMPOS LEON FRANCISCO JOSE;RODRIGUEZ ROMAN ELISA. Apo.Manc.: PEREZ FIUNTE JOSELUIS;MADUENO MOYANO JUAN JOSE;ECHEVARRIA CORTADA MARIA DOLORESApo.Sol.: VELASCO LASTRA RUBEN. Datosregistrales. T 43730 , F 130, S 8, H M 636973, I/A 23 (18.04.23).

Cambio de objeto social. 1. El arrendamiento de viviendas situadas en territorio espa帽ol que haya construido, promovido o adquiridopor cualquier medio. 2. La promoci贸n, gesti贸n e inversi贸n inmobiliaria en su m谩s amplia acepci贸n y, en particular: a) La adquisici贸n yventa de terrenos, solares, edificios;. Datos registrales. T 43730 , F 130, S 8, H M 636973, I/A 24 (18.04.23).

Revocaciones. Apo.Manc.: VIOQUE RUIZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 43730 , F 131, S 8, H M 636973, I/A 25 (18.04.23).

16 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: MATEU OTIN DAVID;DE PABLO REPES XABIER MARIANO;CANALS CANALS MARTA;SANCHEZBARCO MIGUEL;DIAZ GONZALEZ MARIA. Apo.Sol.: LOPEZ GALLEGO ANTONIO;BRA脩A ABASCAL ALEJANDRO. Apo.Manc.:LLUELMA LAYNEZ ANTONIO;COMESANA ALVAREZ DARIO MANUEL;ILARREGUI YOLDI EDUARDO;DAUDEN MARTINEZ JOSEANTONIO;DOMINGUEZ RODRIGUEZ JULIO;FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA ANAApo.Man.Soli: DEY SHOMIT;SANZ BERNAUSDANIEL. Apo.Manc.: GARCIA ROMERA JOSE ENRIQUE. Apo.Sol.: SANZ BERNAUS DANIEL. Apo.Man.Soli: SARRATE GARCIACARLOS. Datos registrales. T 43730 , F 129, S 8, H M 636973, I/A 22 ( 9.02.23).

20 de Enero de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: USED ALONSO ENRIQUE;SUALDEA MONTES MONICA. Otros conceptos: Modificados los poderesconferidos a don Carlos Montoya Reguera, en escritura de fecha 18 de enero de 2019, otorgada ante el Notario de Barcelona, donEmilio Rosell贸 Carri贸n, n煤mero 152 de protocolo, origen de la inscripci贸n 22陋 de traslado comprendidas en la 9陋, en cuanto a los l铆mitesecon贸micos. Datos registrales. T 43730 , F 129, S 8, H M 636973, I/A 21 (13.01.23).

23 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: USED ALONSO ENRIQUE. Nombramientos. Representan: MONTOYA REGUERA CARLOS.Datos registrales. T 43730 , F 129, S 8, H M 636973, I/A 20 (16.12.22).

13 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 43730 , F 129, S 8, H M 636973, I/A 19 ( 2.12.22).

20 de Septiembre de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ-VELAYOS RIVERA MAYA;PARRA ARRIZABALAGA MARIA ESTIBALIZ. Apo.Sol.:GONZALEZ-VELAYOS RIVERA MAYA. Apo.Man.Soli: MU脩OZ LOPEZ DAVID;CANALES MANRESA RUBEN. Nombramientos.Apo.Sol.: NU脩O CANDELA LUIS. Datos registrales. T 43730 , F 126, S 8, H M 636973, I/A 18 (13.09.22).

01 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: ALISEDA SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA SL. Datos registrales. T 42421 , F 225, S 8, H M636973, I/A 17 (25.08.22).

13 de Junio de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: NEIRA BARROSO FRANCISCO JOSE;LOZANO PAREDES JOSE;VINAS BARBA JOSE LUIS;NAVARRODE LA FUENTE ANTONIO. Apo.Man.Soli: QIPERT UGH GLOBAL SL;GESTIMED LEVANTE SL;ARRIBAS ROSENDO JAVIERESTEBAN;OLMOS CASTEJON JUANA MARIA. Apo.Sol.: OLMOS CASTEJON JUANA MARIA;QIPERT UGH GLOBAL SL.Apo.Man.Soli: BARTOLOME RODRIGUEZ LUIS ANTONIO. Datos registrales. T 42421 , F 224, S 8, H M 636973, I/A 16 ( 6.06.22).

22 de Abril de 2022
Nombramientos. Apoderado: VERA MARTIN JUAN PABLO;ROSON GOMEZ NOELIA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;IZQUIERDOSEBASTIAN OLIVIA;FERNANDEZ NAVARRO CARLOS;GARCIA DEL CASTILLO DE LAMA CARMEN;CAVA MARTINEZMARIO;LUENGO REGALADO SANTOS MANUEL. Datos registrales. T 42421 , F 223, S 8, H M 636973, I/A 15 (13.04.22).

25 de Marzo de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42421 , F 223, S 8, H M 636973, I/A 14 (18.03.22).

17 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: BERNA NI脩EROLA JAVIER ENRIQUE. Apo.Man.Soli: PEREZ CARRETERO SANTIAGO JOSE.Apo.Sol.: CENTENO CERRATO ANDRES SANTIAGO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: URRESTARAZU MAGALLON MARIAJESUS;LUIS ARAMENDIA I脩IGO. Datos registrales. T 42421 , F 222, S 8, H M 636973, I/A 13 (10.03.22).

23 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: ARIZCUN MU脩OZ ARANZAZU. Apo.Man.Soli: DE LA GUARDIA GARCIA LOMAS BEATRIZ;SALAS DEYNZA GUADALUPE MARIA PILAR. Apo.Manc.: MARQUETTI TORRES CLAUDIA. Apo.Sol.: INTRUM SERVICING SPAIN SA.Apo.Man.Soli: GONZALEZ ALONSO ROSA ANA;MORENO ARANDA RAUL ANTONIO. Apo.Sol.: MARRERO FERNANDEZ-CID

22 de Diciembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Representan: CAMPOS LEON FRANCISCO. Nombramientos. Representan: FERNANDEZ GARCIA LAURA.Datos registrales. T 42421 , F 220, S 8, H M 636973, I/A 11 (15.12.21).

15 de Diciembre de 2021
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 280 - PLANTA 2陋 (MADRID). Datos registrales. T 42421 , F 220, S 8, HM 636973, I/A 10 ( 7.12.21).

17 de Mayo de 2018
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7 Y 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T35436 , F 104, S 8, H M 636973, I/A 8 (25.04.18).

05 de Abril de 2018
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: BANCO POPULAR ESPA脩OL SA. Datos registrales. T 35436 , F104, S 8, H M 636973, I/A 6 (23.03.18).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SA. Datos registrales.T 35436 , F 104, S 8, H M 636973, I/A 7 (23.03.18).

28 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ANTICIPA REAL ESTATE SL. Datos registrales. T 35436 , F 101, S 8, H M 636973, I/A 5(20.03.18).

27 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apoderado: DAVIES SIMON DAVID AUSTIN;KOSTADINOV VASILEV PANAYOT;NOVOA BERREDO DANIELARMANDO;BOSSY JEAN-FRANCOIS PASCAL EMMANUEL;HOFFMANN SOLVEIG DIANA;MEDIANE ANISSA;MENDILUCEFRADERA EDUARD;CAMPOS LEON FRANCISCO JOSE;MCKENZIE PETER;CAIS FONTANELLA HELENA;DE LA TORRELORENZO NOELIA;JULIA ARMENGOL MARC;MATEU OTIN DAVID;BUENO GALVEZ MARIA LUISA;DE PABLO REPES XABIER

26 de Enero de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PARDO GARCIA JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: PARDO GARCIA JOSE;JIMENEZ MARTINFERNANDO;OTERO BLANCO JOSE. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 35436 , F 99, S 8, H M 636973, I/A 3 (18.01.18).

21 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ MARTIN FERNANDO;GUZMAN DIAZ SILVIA;PARDO GARCIA JOSE;MARTIN SAEZPATRICIA;OTERO BLANCO JOSE MARCOS;MOINELO LOPEZ TANIA;CABELLO GONZALEZ MARIA;CORTES GARCIAMARIO;LOPEZ MEJIAS JESUS MIGUEL. Datos registrales. T 35436 , F 98, S 8, H M 636973, I/A 2 (14.12.17).

05 de Enero de 2017
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 14.11.16. Objeto social: 1.- La explotaci贸n en forma de venta, sociedad, arriendo (excepto el

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n