Actos BORME de Inversiones Provisa Sa
18 de Marzo de 2021Reelecciones. Adm. Unico: VILLANUEVA HUELGA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 5579, L 4486, F 7, S 8, H MA 6002,I/A 31 (10.03.21).
05 de Enero de 2021Nombramientos. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 5579, L 4486, F 7, S 8, H MA 6002, I/A 30(22.12.20).
28 de Octubre de 2019Nombramientos. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 5579, L 4486, F 5, S 8, H MA 6002, I/A 29(16.10.19).
17 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 5579, L 4486, F 4, S 8, H MA 6002, I/A 27 ( 8.10.18).
02 de Noviembre de 2017Nombramientos. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 5579, L 4486, F 4, S 8, H MA 6002, I/A 26(24.10.17).
11 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ REVILLA RICARDO. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 167, S 8, H MA 6002, I/A 25(29.12.16).
01 de Septiembre de 2016Nombramientos. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 167, S 8, H MA 6002, I/A 24(12.08.16).
02 de Noviembre de 2015Reelecciones. Adm. Unico: VILLANUEVA HUELGA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 167, S 8, H MA 6002,I/A 23 (19.10.15).
18 de Agosto de 2015Reelecciones. Auditor: AUDITORES CINCO SLP. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 167, S 8, H MA 6002, I/A 22 ( 6.08.15).
30 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: AUDITORES CINCO SLP. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 167, S 8, H MA 6002, I/A 21 (18.09.14).
15 de Enero de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.225.171,58 Euros. Desembolsado: 1.225.171,58 Euros. Resultante Suscrito: 3.475.871,43 Euros.Resultante Desembolsado: 3.475.871,43 Euros. Modificaciones estatutarias. De la remuneraci贸n del administrador. Datosregistrales. T 2989, L 1902, F 166, S 8, H MA 6002, I/A 20 ( 7.01.14).
07 de Agosto de 2013Reelecciones. Auditor: AUDITORES CINCO SLP. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 165, S 8, H MA 6002, I/A 19 (29.07.13).
06 de Agosto de 2012Reelecciones. Auditor: AUDITORES CINCO SLP. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 165, S 8, H MA 6002, I/A 18 (25.07.12).
25 de Agosto de 2011Reelecciones. Auditor: AUDITORES CINCO SLP. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 165, S 8, H MA 6002, I/A 17 (12.08.11).
28 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.001.783,41 Euros. Desembolsado: 2.001.783,41 Euros. Resultante Suscrito: 2.250.699,85 Euros.Resultante Desembolsado: 2.250.699,85 Euros. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 165, S 8, H MA 6002, I/A 16 (14.02.11).
09 de Febrero de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: VILLALBA VERDUGO CARLOS;GARCIA PADILLA MANUEL;AGUILERA RUIZ ANTONIO;VILLALBAVERDUGO CARLOS;PEREZ MATEO FERNANDO;AGUILERA RUIZ ANTONIO;PEREZ MATEO FERNANDO;GARCIA HUELGAFRANCISCO JOSE;AGUILERA RUIZ ANTONIO. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 164, S 8, H MA 6002, I/A 13 (24.01.11).
Nombramientos. Apoderado: SIERRA SANCHEZ EUSEBIO. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 164, S 8, H MA 6002, I/A 14(24.01.11).
Nombramientos. Auditor: AUDITORES CINCO SLP. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 164, S 8, H MA 6002, I/A 15 (26.01.11).
18 de Agosto de 2010Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: BURGOS MONTERO JOSE;ARRUPE FERREIRA ALBERTO;AGUILERARUIZ ANTONIO. Cons.Del.Man: AGUILERA RUIZ ANTONIO. Consejero: CARDENAS VILLAR FRANCISCO. Cons.Del.Man:CARDENAS VILLAR FRANCISCO. Consejero: VILLANUEVA HUELGA FRANCISCO JOSE. Cons.Del.Man: VILLANUEVA HUELGAFRANCISCO JOSE. Presidente: BURGOS MONTERO JOSE. Consejero: BURGOS MONTERO JOSE. Cons.Del.Man: BURGOSMONTERO JOSE. Secretario: ARRUPE FERREIRA ALBERTO. Consejero: ARRUPE FERREIRA ALBERTO. Cons.Del.Man: ARRUPEFERREIRA ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: VILLANUEVA HUELGA FRANCISCO JOSE. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 2989, L 1902, F 163, S8, H MA 6002, I/A 12 ( 9.08.10).