Buscador CIF Logo

Actos BORME Inversiones York Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Inversiones York Sl

Actos BORME Inversiones York Sl - B86914157

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Inversiones York Sl con CIF B86914157

馃敊 Perfil de Inversiones York Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Inversiones York Sl

18 de Agosto de 2023
Modificaciones estatutarias. Art铆culo 23潞. Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 31886 , F 223, S 8, H M 573840, I/A 22(10.08.23).

16 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: KRIN VLADIMIR. Nombramientos. Consejero: CHUTE ROBERTO EDUARDO. Datos registrales.T 31886 , F 223, S 8, H M 573840, I/A 21 ( 8.08.23).

08 de Agosto de 2022
Otros conceptos: Declaraci贸n del Cambio de Denominacion del Socio unico: Opal Properties B.V. Cambio de domicilio social. C/PINAR 7 - 1潞 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 31886 , F 222, S 8, H M 573840, I/A 20 ( 1.08.22).

05 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: RYAN WILLIAM P;KRIN VLADIMIR;DE ANGELO MICHAEL VINCENT;SALEMAN DANIELBENJAMIN;UROVISH RONI. Datos registrales. T 31886 , F 222, S 8, H M 573840, I/A 19 (29.07.22).

25 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION. Revocaciones. Apoderado: HOYOS RAMIREZANDRES;GARCIA RESTREPO LILIANA;ARDILA GARZON FABIO-ALEJANDRO;MORALES CELY PAULA-ALEJANDRA;BOCKERLEE EDWARD;SAEZ SERRANO SARA;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCELSANCHEZ PAULA. Apo.Manc.: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANAGOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN. Apo.Sol.: CASTA脩O CASTROCONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGASANCHEZ RUBEN;MONREAL JORDE VICTOR;CASTA脩O CASTRO CONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZOJULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN;MONREAL JORDE VICTOR.Nombramientos. SecreNoConsj: GOMEZ DIEZ ISABEL. VsecrNoConsj: PELAEZ VARA JULIA. Apo.Man.Soli: GOMEZ DIEZISABEL;PELAEZ VARA JULIA;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PIRES DOS SANTOS FRANCISCO IPO;AYLLONFERNANDEZ MARIA ANGELES;CEACERO ESCOLAR IRENE. Apo.Sol.: REY HERNANDEZ DIEGO. Datos registrales. T 31886 , F221, S 8, H M 573840, I/A 18 (18.05.21).

14 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA;ARANGO CLAUDIA;ARANGO CLAUDIA.Nombramientos. Apo.Sol.: GERMANOV ANDY ALEX. Apo.Manc.: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN. Apo.Sol.: CASTA脩OCASTRO CONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZPAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN;MONREAL JORDE VICTOR;CASTA脩O CASTRO CONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN;ORVAY ARROYOMERCEDES;HERNANDEZ MOLEDOUS JOHANA MARLENE;MONREAL JORDE VICTOR. Datos registrales. T 31886 , F 219, S 8,H M 573840, I/A 17 ( 7.02.20).

13 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA. Consejero: BOCKER LEE;ARANGO CLAUDIA. Presidente:BOCKER LEE. Nombramientos. SecreNoConsj: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION. Consejero: GERMANOV ANDYALEX;PERRONE GUILLERMO LUIS. Presidente: GERMANOV ANDY ALEX. Datos registrales. T 31886 , F 218, S 8, H M 573840,I/A 16 ( 6.02.20).

07 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GOMEZ DIEZ ISABEL. Revocaciones. Apoderado: GOMEZ DIEZ ISABEL. Datos registrales.T 31886 , F 218, S 8, H M 573840, I/A 15 (31.01.20).

26 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERRARO FRANCIS SCOTT. Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ HERNANDEZRAQUEL;ANSON LORENTE MARTA;FERRARO FRANCIS SCOTT;FERRARO FRANCIS SCOTT. Nombramientos. Consejero:KRIN VLADIMIR. Apoderado: KRIN VLADIMIR;SAEZ SERRANO SARA;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANAGOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA. Datos registrales. T 31886 , F 217, S 8, H M 573840, I/A 14 (19.02.19).

10 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: ARANGO CLAUDIA. Datos registrales. T 31886 , F 217, S 8, H M 573840, I/A 13 ( 3.10.17).

11 de Mayo de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 909.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.084.600,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 31886 , F 216, S 8, H M 573840, I/A 12 ( 3.05.16).

12 de Diciembre de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 118.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.175.600,00 Euros. Datos registrales. T 31886 , F 216, S 8,H M 573840, I/A 11 ( 3.12.14).

05 de Noviembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MAROM JONATHAN TAYLOR. Revocaciones. Apoderado: MAROM JONATHAN TAYLOR.Nombramientos. Consejero: FERRARO FRANCIS SCOTT. Apoderado: FERRARO FRANCIS SCOTT. Datos registrales. T 31886 ,F 215, S 8, H M 573840, I/A 10 (28.10.14).

03 de Octubre de 2014
Nombramientos. Apoderado: FERRARO FRANCIS SCOTT;BOCKER LEE EDWARD. Datos registrales. T 31886 , F 28, S 8, H M573840, I/A 9 (24.09.14).

16 de Septiembre de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 20.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.057.000,00 Euros. Datos registrales. T 31886 , F 28, S 8, HM 573840, I/A 8 ( 8.09.14).

23 de Julio de 2014
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: OPAL PROPERTIES SARL. Datos registrales. T 31886 , F 28, S 8,H M 573840, I/A 7 (16.07.14).

27 de Mayo de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.033.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.036.500,00 Euros. Datos registrales. T 31886 , F 27, S8, H M 573840, I/A 6 (19.05.14).

16 de Abril de 2014
Nombramientos. Apoderado: ARANGO CLAUDIA;ALLENDE TOMAS;HOYOS RAMIREZ ANDRES;GARCIA RESTREPOLILIANA;ARDILA GARZON FABIO-ALEJANDRO;MORALES CELY PAULA-ALEJANDRA. Datos registrales. T 31886 , F 26, S 8, H M573840, I/A 5 ( 8.04.14).

21 de Marzo de 2014
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;HERNANDEZ HERNANDEZRAQUEL;DOMINGUEZ HUELAMO NATALIA;MARTIN COMES JOSE MIGUEL;ANSON LORENTE MARTA. Datos registrales. T31886 , F 26, S 8, H M 573840, I/A 4 (13.03.14).

13 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA. Nombramientos.SecreNoConsj: GOMEZ DIEZ ISABEL. Consejero: BOCKER LEE;ARANGO CLAUDIA;MAROM JONATHAN TAYLOR. Presidente:BOCKER LEE. VsecrNoConsj: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Se modifica la redacci贸n del art铆culo 23 de los estatutossociales. Datos registrales. T 31886 , F 23, S 8, H M 573840, I/A 2 ( 5.03.14).

Nombramientos. Apoderado: MAROM JONATHAN TAYLOR;GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZPALOMA;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA;ANSON LORENTE MARTA. Datosregistrales. T 31886 , F 25, S 8, H M 573840, I/A 3 ( 5.03.14).

04 de Febrero de 2014
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.01.14. Objeto social: 1. Actividades de las sociedades holding, esto es la direcci贸n ygesti贸n de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio espa帽ol que determinen un porcentajede participaci贸n directa o indirecta, igual o superior al cinco (5) por ciento mediante... Domicilio: C/ PINAR 7 5潞 - IZQUIERDA(MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CITCO CORPORATE MANAGEMENT -MADRID- SL. Nombramientos. Adm. Solid.: GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA. Datosregistrales. T 31886 , F 19, S 8, H M 573840, I/A 1 (28.01.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n