Actos BORME de Inversiones York Sl
18 de Agosto de 2023Modificaciones estatutarias. Art铆culo 23潞. Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 31886 , F 223, S 8, H M 573840, I/A 22(10.08.23).
16 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: KRIN VLADIMIR. Nombramientos. Consejero: CHUTE ROBERTO EDUARDO. Datos registrales.T 31886 , F 223, S 8, H M 573840, I/A 21 ( 8.08.23).
08 de Agosto de 2022Otros conceptos: Declaraci贸n del Cambio de Denominacion del Socio unico: Opal Properties B.V. Cambio de domicilio social. C/PINAR 7 - 1潞 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 31886 , F 222, S 8, H M 573840, I/A 20 ( 1.08.22).
05 de Agosto de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: RYAN WILLIAM P;KRIN VLADIMIR;DE ANGELO MICHAEL VINCENT;SALEMAN DANIELBENJAMIN;UROVISH RONI. Datos registrales. T 31886 , F 222, S 8, H M 573840, I/A 19 (29.07.22).
25 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION. Revocaciones. Apoderado: HOYOS RAMIREZANDRES;GARCIA RESTREPO LILIANA;ARDILA GARZON FABIO-ALEJANDRO;MORALES CELY PAULA-ALEJANDRA;BOCKERLEE EDWARD;SAEZ SERRANO SARA;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCELSANCHEZ PAULA. Apo.Manc.: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANAGOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN. Apo.Sol.: CASTA脩O CASTROCONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGASANCHEZ RUBEN;MONREAL JORDE VICTOR;CASTA脩O CASTRO CONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZOJULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN;MONREAL JORDE VICTOR.Nombramientos. SecreNoConsj: GOMEZ DIEZ ISABEL. VsecrNoConsj: PELAEZ VARA JULIA. Apo.Man.Soli: GOMEZ DIEZISABEL;PELAEZ VARA JULIA;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PIRES DOS SANTOS FRANCISCO IPO;AYLLONFERNANDEZ MARIA ANGELES;CEACERO ESCOLAR IRENE. Apo.Sol.: REY HERNANDEZ DIEGO. Datos registrales. T 31886 , F221, S 8, H M 573840, I/A 18 (18.05.21).
14 de Febrero de 2020Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA;ARANGO CLAUDIA;ARANGO CLAUDIA.Nombramientos. Apo.Sol.: GERMANOV ANDY ALEX. Apo.Manc.: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN. Apo.Sol.: CASTA脩OCASTRO CONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZPAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN;MONREAL JORDE VICTOR;CASTA脩O CASTRO CONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN;ORVAY ARROYOMERCEDES;HERNANDEZ MOLEDOUS JOHANA MARLENE;MONREAL JORDE VICTOR. Datos registrales. T 31886 , F 219, S 8,H M 573840, I/A 17 ( 7.02.20).
13 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA. Consejero: BOCKER LEE;ARANGO CLAUDIA. Presidente:BOCKER LEE. Nombramientos. SecreNoConsj: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION. Consejero: GERMANOV ANDYALEX;PERRONE GUILLERMO LUIS. Presidente: GERMANOV ANDY ALEX. Datos registrales. T 31886 , F 218, S 8, H M 573840,I/A 16 ( 6.02.20).
07 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GOMEZ DIEZ ISABEL. Revocaciones. Apoderado: GOMEZ DIEZ ISABEL. Datos registrales.T 31886 , F 218, S 8, H M 573840, I/A 15 (31.01.20).
26 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: FERRARO FRANCIS SCOTT. Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ HERNANDEZRAQUEL;ANSON LORENTE MARTA;FERRARO FRANCIS SCOTT;FERRARO FRANCIS SCOTT. Nombramientos. Consejero:KRIN VLADIMIR. Apoderado: KRIN VLADIMIR;SAEZ SERRANO SARA;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANAGOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA. Datos registrales. T 31886 , F 217, S 8, H M 573840, I/A 14 (19.02.19).
10 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: ARANGO CLAUDIA. Datos registrales. T 31886 , F 217, S 8, H M 573840, I/A 13 ( 3.10.17).
11 de Mayo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 909.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.084.600,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 31886 , F 216, S 8, H M 573840, I/A 12 ( 3.05.16).
12 de Diciembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 118.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.175.600,00 Euros. Datos registrales. T 31886 , F 216, S 8,H M 573840, I/A 11 ( 3.12.14).
05 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MAROM JONATHAN TAYLOR. Revocaciones. Apoderado: MAROM JONATHAN TAYLOR.Nombramientos. Consejero: FERRARO FRANCIS SCOTT. Apoderado: FERRARO FRANCIS SCOTT. Datos registrales. T 31886 ,F 215, S 8, H M 573840, I/A 10 (28.10.14).
03 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: FERRARO FRANCIS SCOTT;BOCKER LEE EDWARD. Datos registrales. T 31886 , F 28, S 8, H M573840, I/A 9 (24.09.14).
16 de Septiembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 20.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.057.000,00 Euros. Datos registrales. T 31886 , F 28, S 8, HM 573840, I/A 8 ( 8.09.14).
23 de Julio de 2014Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: OPAL PROPERTIES SARL. Datos registrales. T 31886 , F 28, S 8,H M 573840, I/A 7 (16.07.14).
27 de Mayo de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.033.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.036.500,00 Euros. Datos registrales. T 31886 , F 27, S8, H M 573840, I/A 6 (19.05.14).
16 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: ARANGO CLAUDIA;ALLENDE TOMAS;HOYOS RAMIREZ ANDRES;GARCIA RESTREPOLILIANA;ARDILA GARZON FABIO-ALEJANDRO;MORALES CELY PAULA-ALEJANDRA. Datos registrales. T 31886 , F 26, S 8, H M573840, I/A 5 ( 8.04.14).
21 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;HERNANDEZ HERNANDEZRAQUEL;DOMINGUEZ HUELAMO NATALIA;MARTIN COMES JOSE MIGUEL;ANSON LORENTE MARTA. Datos registrales. T31886 , F 26, S 8, H M 573840, I/A 4 (13.03.14).
13 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA. Nombramientos.SecreNoConsj: GOMEZ DIEZ ISABEL. Consejero: BOCKER LEE;ARANGO CLAUDIA;MAROM JONATHAN TAYLOR. Presidente:BOCKER LEE. VsecrNoConsj: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Se modifica la redacci贸n del art铆culo 23 de los estatutossociales. Datos registrales. T 31886 , F 23, S 8, H M 573840, I/A 2 ( 5.03.14).
Nombramientos. Apoderado: MAROM JONATHAN TAYLOR;GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZPALOMA;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA;ANSON LORENTE MARTA. Datosregistrales. T 31886 , F 25, S 8, H M 573840, I/A 3 ( 5.03.14).
04 de Febrero de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.01.14. Objeto social: 1. Actividades de las sociedades holding, esto es la direcci贸n ygesti贸n de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio espa帽ol que determinen un porcentajede participaci贸n directa o indirecta, igual o superior al cinco (5) por ciento mediante... Domicilio: C/ PINAR 7 5潞 - IZQUIERDA(MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CITCO CORPORATE MANAGEMENT -MADRID- SL. Nombramientos. Adm. Solid.: GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA. Datosregistrales. T 31886 , F 19, S 8, H M 573840, I/A 1 (28.01.14).