Actos BORME de Inversiones Zalle Sl
25 de Julio de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.:GARCIA MONTE ALEJANDRO. Apo.Sol.: GARCIA MONTE ALEJANDRO. Datos registrales. T 3197 , F 221, S 8, H AS 30074, I/A 19(18.07.23).
04 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION. Nombramientos. Consejero: ZABALALLERANDI MIGUEL ANGEL. Modificaciones estatutarias. 23. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad. Duraci贸n.Retribuci贸n.-. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social.-. Cambio de domicilio social. C/ J, NAVE 1 - POLIGONO DE PRONI.MERES. (SIERO). Datos registrales. T 3197 , F 105, S 8, H AS 30074, I/A 18 (24.02.22).
29 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3197 , F 105, S 8, H AS 30074, I/A 17(22.10.21).
26 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL;GARCIA MONTE ALEJANDRO. Apo.Manc.: ZABALA LLERANDIMIGUEL ANGEL;GARCIA MONTE ALEJANDRO. Datos registrales. T 3197 , F 103, S 8, H AS 30074, I/A 16 (18.06.19).
21 de Junio de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ MACIAS VERONICA. Apo.Manc.: GONZALEZ MACIAS VERONICA. Apo.Sol.: GONZALEZFERNANDEZ BEATRIZ. Apo.Manc.: GONZALEZ FERNANDEZ BEATRIZ;ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL;GONZALEZ MACIASVERONICA;GONZALEZ FERNANDEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 3197 , F 103, S 8, H AS 30074, I/A 15 (13.06.19).
08 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ MACIAS VERONICA. Apo.Manc.: GONZALEZ MACIAS VERONICA. Apo.Sol.: GONZALEZFERNANDEZ BEATRIZ. Apo.Manc.: GONZALEZ FERNANDEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 3197 , F 102, S 8, H AS 30074, I/A 13(31.05.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL;GONZALEZ MACIAS VERONICA;GONZALEZ FERNANDEZBEATRIZ Datos registrales. T 3197 , F 103, S 8, H AS 30074, I/A 14 (31.05.18).
10 de Mayo de 2018Revocaciones. Consejero: LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA;SUAREZ GARCIA IVAN. Secretario: SUAREZ GARCIA IVAN.Nombramientos. Apo.Manc.: ZABALA LLERANDI JORGE ABELARDO. Apo.Sol.: ZABALA LLERANDI JORGE ABELARDO.Consejero: ZABALA LLERANDI JORGE ABELARDO. Secretario: ZABALA LLERANDI JORGE ABELARDO. Apo.Manc.: CAMPILLOMARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social y webcorporativa.-. Cambio de domicilio social. C/ LIBERTAD 27 1潞 A (GIJON). Datos registrales. T 3197 , F 102, S 8, H AS 30074, I/A12 ( 2.05.18).
07 de Febrero de 2018Revocaciones. Apoderado: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA. Apo.Sol.:LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA. Apo.Manc.: CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION. Apo.Sol.: CAMPILLOMARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION. Apo.Manc.: SUAREZ GARCIA IVAN. Apo.Sol.: SUAREZ GARCIA IVAN. Nombramientos.
02 de Agosto de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: SUAREZ GARCIA IVAN. Datos registrales. T 3197 , F 96, S 8, H AS 30074, I/A 10 ( 4.10.15).
14 de Octubre de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.:LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA. Apo.Sol.: LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA. Apo.Manc.: SUAREZ GARCIA IVAN. Apo.Sol.:SUAREZ GARCIA IVAN. Consejero: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: CAMPILLO MARTINEZPRUDENCIA ENCARNACION. Apo.Sol.: CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION. Apo.Manc.: CAMPILLO MARTINEZPRUDENCIA ENCARNACION. Apo.Sol.: LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA. Apo.Manc.: LLAMES GONZALEZ JOSEMARIA;SUAREZ GARCIA IVAN. Reelecciones. Presidente: ZABALA DEL REY MIGUEL ANGEL. Secretario: SUAREZ GARCIAIVAN. Modificaciones estatutarias. 23. Administraci贸n y Representacion.- . Datos registrales. T 3197 , F 96, S 8, H AS 30074, I/A10 ( 5.10.15).
12 de Enero de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.555.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.110.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 3197 , F 96, S 8, H AS 30074, I/A 9 (30.12.14).
19 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ASTUR BARNIZ SL. Nombramientos. Apo.Sol.: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL. Consejero:ZABALA DEL REY MIGUEL ANGEL. Presidente: ZABALA DEL REY MIGUEL ANGEL. Consejero: LLAMES GONZALEZ JOSEMARIA;ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL;SUAREZ GARCIA IVAN. Secretario: SUAREZ GARCIA IVAN. Apo.Sol.: LLAMESGONZALEZ JOSE MARIA;SUAREZ GARCIA IVAN. Apo.Manc.: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL;LLAMES GONZALEZ JOSEMARIA;SUAREZ GARCIA IVAN. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejode administraci贸n. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Cambio de objeto social. CNAE 7022 La gestion y direccion, general,
25 de Noviembre de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.152.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.555.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 3197 , F 94, S 8, H AS 30074, I/A 7 (15.11.13).
30 de Noviembre de 2012Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. POLIG DE SANTIANES S/N(SARIEGO). Datos registrales. T 3197 , F 94, S 8, H AS 30074, I/A 6 (19.11.12).
25 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3197 , F 94, S 8, H AS 30074, I/A 4(13.01.12).
Modificaciones estatutarias. 23. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 3197 , F 94, S 8, H AS 30074, I/A 5(13.01.12).
07 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ZABALA DEL REY MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: ASTUR BARNIZ SL. Datosregistrales. T 3197 , F 93, S 8, H AS 30074, I/A 3 (26.08.10).