Actos BORME de Inversions Garbet Sicav Sa
28 de Julio de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MASNOU PALAU RAMON;RIERA GLAMES BARTOLOME;LORENZO LOPEZ MARIA DE LOSANGELES. Vicesecret.: URIBARRI CHACON PILAR. EntidDeposit: CACEIS BANK SPAIN SA. Ent. Gestora: SANTANDER PRIVATEBANKING GESTION SOCIEDAD ANONIMA. Presidente: MASNOU PALAU RAMON. Secretario: LORENZO LOPEZ MARIA DE LOSANGELES. Nombramientos. Adm. Unico: ASPEMIR SL. Representan: PARERA FEMENIAS ANA MARIA. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Art铆culo de los estatutos: 1. Otros conceptos: Resoluci贸n de la Comisi贸n Nacional delMercado de Valores dando de baja a la Sociedad en el Registro de Sociedades de Inversi贸n de Capital Variable; el capital social se fijaen 10.135.993 euros, integramente suscrito y desembolsado. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Cambio de denominaci贸n social. INVERSIONS GARBET SA. Cambio de objeto social. La tenencia einversi贸n de activos financieros, obligaciones, acciones, participaciones de otras compa帽铆as. Datos registrales. T 27937 , F 163, S 8,H M 292124, I/A 31 (21.07.23).
04 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: MASNOU PALAU RAMON. Presidente:MASNOU PALAU RAMON. Consejero: RIERA GLAMES BARTOLOME. Datos registrales. T 27937 , F 162, S 8, H M 292124, I/A 30(28.12.22).
28 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27937 , F 162, S 8, H M 292124,I/A 29 (21.10.21).
04 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: LORENZO LOPEZ MARIA DE LOSANGELES. Secretario: LORENZO LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 27937 , F 161, S 8, H M 292124, I/A 28(25.02.21).
01 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID). Datos registrales. T 27937 , F 161, S 8, H M292124, I/A 27 (25.01.19).
13 de Diciembre de 2017Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Reelecciones. Consejero: MASNOU PALAURAMON. Presidente: MASNOU PALAU RAMON. Consejero: RIERA GLAMES BARTOLOME. Datos registrales. T 27937 , F 161, S8, H M 292124, I/A 26 ( 4.12.17).
28 de Septiembre de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 27937 , F 160, S 8, H M 292124, I/A 25 (19.09.16).
06 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. EntidDeposit: SANTANDER INVESTMENT SA. Nombramientos. EntidDeposit: SANTANDER SECURITIESSERVICES SA. Modificaciones estatutarias. 1. Denominaci贸n.-. Datos registrales. T 27937 , F 160, S 8, H M 292124, I/A 24(27.10.15).
21 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ALBORCH BAUMANN JORGE-JOSE. Secretario: ALBORCH BAUMANN JORGE-JOSE.Nombramientos. Consejero: LORENZO LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES. Secretario: LORENZO LOPEZ MARIA DE LOSANGELES. Datos registrales. T 27937 , F 159, S 8, H M 292124, I/A 23 (13.10.15).
21 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Ent. Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC. Revocaciones. Apoderado: SANTANDERASSET MANAGEMENT SA SGIIC. Nombramientos. Ent. Gestora: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SOCIEDADANONIM. Apoderado: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SOCIEDAD ANONIM. Datos registrales. T 27937 , F 158, S 8, HM 292124, I/A 22 (13.11.13).
11 de Noviembre de 2013Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 27937 , F 158, S 8, H M 292124, I/A 21 (30.10.13).
26 de Octubre de 2012Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 13潞 DE LOS ESTUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 27937 , F158, S 8, H M 292124, I/A 20 (17.10.12).
12 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: COSTAFREDA GIMENO IRENE;COSTAFREDA GIMENO CLARA. Nombramientos. Consejero:MASNOU PALAU RAMON. Presidente: MASNOU PALAU RAMON. Consejero: ALBORCH BAUMANN JORGE-JOSE;RIERA GLAMESBARTOLOME. Datos registrales. T 27937 , F 157, S 8, H M 292124, I/A 19 (30.08.12).
25 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: COSTAFREDA GIMENO ALBERT. Nombramientos. Apoderado: MASNOU PALAU RAMON. Datosregistrales. T 27937 , F 157, S 8, H M 292124, I/A 18 (13.06.12).
22 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: COSTAFREDA GIMENO ALBERT. Presidente: COSTAFREDA GIMENO ALBERT. Secretario:COSTAFREDA GIMENO IRENE. Nombramientos. Presidente: MASNOY PALAY RAMON. Consejero: MASNOY PALAY RAMON.SecreNoConsj: ALBORCH BAUMANN JORGE-JOSE. Datos registrales. T 27937 , F 156, S 8, H M 292124, I/A 17 (12.06.12).
09 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apoderado: COSTAFREDA GIMENO ALBERT. Datos registrales. T 27937 , F 156, S 8, H M 292124, I/A 16(28.11.11).
21 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ARNAIZ CABEZAS JUAN ANDRES. Presidente: COSTAFREDA GIMENO IRENE. Secretario:COSTAFREDA GIMENO CLARA. Nombramientos. Consejero: COSTAFREDA GIMENO ALBERT. Presidente: COSTAFREDAGIMENO ALBERT. Secretario: COSTAFREDA GIMENO IRENE. Reelecciones. Consejero: COSTAFREDA GIMENOIRENE;COSTAFREDA GIMENO CLARA. Datos registrales. T 27937 , F 156, S 8, H M 292124, I/A 15 ( 7.11.11).
13 de Septiembre de 2010Nombramientos. Auditor: QUORUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 17069 , F 136, S 8, H M 292124, I/A 14 ( 2.09.10).