Buscador CIF Logo

Actos BORME Ionmed Esterilizacion Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ionmed Esterilizacion Sa

Actos BORME Ionmed Esterilizacion Sa - A81321580

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Cuenca para Ionmed Esterilizacion Sa con CIF A81321580

🔙 Perfil de Ionmed Esterilizacion Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Cuenca

Actos BORME de Ionmed Esterilizacion Sa

04 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUILLOUX AURELIEN. Presidente: IONISOS SAS. Nombramientos. Consejero: EL BOUNAAMANIMOHAMED. Presidente: HERKENS CHRISTOPH. Otros conceptos: Nombramiento de don Aurelien Guilloux como representantepersona física del Consejero IONISOS SAS por don Christoph Herkens. Datos registrales. T 741 , F 181, S 8, H CU 7886, I/A 23(23.02.21).

24 de Diciembre de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: HERKENS CHRISTOPH;MORALES DE CASTRO MIGUEL. Apo.Manc.: MORALES DE CASTRO MIGUEL.Apo.Man.Soli: MORALES DE CASTRO MIGUEL;HERKENS CHRISTOPH. Apo.Sol.: HERKENS CHRISTOPH. Apo.Man.Soli:GUILLOUX AURELIEN. Apo.Sol.: GUILLOUX AURELIEN. Apo.Manc.: GUILLOUX AURELIEN. Nombramientos. Apo.Sol.:HERKENS CHRISTOPH;BUTAUD ADRIEN JAIME MAURICE JACQUES;EL HOUL ABDOUNI MOHAMED. Apo.Man.Soli: HERKENSCHRISTOPH;BUTAUD ADRIEN JAIME MAURICE JACQUES;EL HOUL ABDOUNI MOHAMED. Apo.Sol.: HERKENS CHRISTOPH.Apo.Manc.: BUTAUD ADRIEN JAIME MAURICE JACQUES;EL HOUL ABDOUNI MOHAMED. Datos registrales. T 741 , F 179, S 8,H CU 7886, I/A 22 (15.12.20).

06 de Julio de 2018
Reelecciones. Consejero: IONISOS SAS. Presidente: IONISOS SAS. Datos registrales. T 741 , F 178, S 8, H CU 7886, I/A 21(25.06.18).

07 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMINET MICHEL. Revocaciones. Apo.Sol.: GOMINET MICHEL;GOMINET MICHEL;GOMINETMICHEL;MORALES DE CASTRO MIGUEL;MORALES DE CASTRO MIGUEL. Apo.Manc.: MORALES DE CASTROMIGUEL;GUILLOUX AURELIEN. Apo.Sol.: GUILLOUX AURELIEN;GUILLOUX AURELIEN. Nombramientos. Consejero: HERKENSCHRISTOPH. Apo.Sol.: HERKENS CHRISTOPH;MORALES DE CASTRO MIGUEL;GUILLOUX AURELIEN. Apo.Man.Soli: HERKENSCHRISTOPH;MORALES DE CASTRO MIGUEL;GUILLOUX AURELIEN. Apo.Sol.: HERKENS CHRISTOPH. Apo.Manc.: MORALESDE CASTRO MIGUEL;GUILLOUX AURELIEN. Datos registrales. T 699 , F 61, S 8, H CU 7886, I/A 20 (19.04.18).

01 de Junio de 2017
Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 699 , F 57, S 8, H CU 7886, I/A 17(22.05.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BORNAREL JEAN MARC. Nombramientos. Consejero: GUILLOUX AURELIEN. Datos registrales.T 699 , F 58, S 8, H CU 7886, I/A 18 (22.05.17).

Revocaciones. Apo.Sol.: GOMINET MICHEL;GOMINET MICHEL. Apo.Man.Soli: GOMINET MICHEL. Apo.Sol.: MORALES DECASTRO MIGUEL. Apo.Manc.: MORALES DE CASTRO MIGUEL. Apo.Man.Soli: MORALES DE CASTRO MIGUEL;BORNAREL JEANMARC. Apo.Sol.: BORNAREL JEAN MARC. Apo.Manc.: BORNAREL JEAN MARC. Nombramientos. Apo.Sol.: GOMINET MICHEL.Apo.Manc.: GUILLOUX AURELIEN;MORALES DE CASTRO MIGUEL. Apo.Sol.: GOMINET MICHEL;GUILLOUXAURELIEN;MORALES DE CASTRO MIGUEL;GUILLOUX AURELIEN;MORALES DE CASTRO MIGUEL;GOMINET MICHEL. Datosregistrales. T 699 , F 59, S 8, H CU 7886, I/A 19 (22.05.17).

26 de Mayo de 2016
Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1º, 10º, 11º, 12º, 14º, 16º, 18º, 20º, 23º, 28º Y 29º DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Datos registrales. T 642 , F 80, S 8, H CU 7886, I/A 16 (13.05.16).

28 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: ESMILAIRE HERVE. Nombramientos. Consejero: BORNAREL JEAN MARC. Datos registrales. T642 , F 77, S 8, H CU 7886, I/A 14 (15.01.15).

Revocaciones. Apo.Sol.: GOMINET MICHEL;GOMINET MICHEL. Apo.Man.Soli: GOMINET MICHEL;MORALES DE CASTROMIGUEL. Apo.Sol.: MORALES DE CASTRO MIGUEL. Apo.Manc.: ESMILAIRE HERVE. Apo.Man.Soli: ESMILAIRE HERVE.Apo.Manc.: MORALES DE CASTRO MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: MORALES DE CASTRO MIGUEL;BORNAREL JEANMARC. Apo.Man.Soli: GOMINET MICHEL;MORALES DE CASTRO MIGUEL. Apo.Sol.: GOMINET MICHEL. Apo.Man.Soli:BORNAREL JEAN MARC. Apo.Sol.: GOMINET MICHEL. Apo.Manc.: MORALES DE CASTRO MIGUEL;BORNAREL JEAN MARC.Datos registrales. T 642 , F 78, S 8, H CU 7886, I/A 15 (15.01.15).

02 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: SCD AUDITORIA SL. Datos registrales. T 642 , F 76, S 8, H CU 7886, I/A 13 (24.09.14).

28 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: ROMANI SANCHO JUAN. Nombramientos. VsecrNoConsj: CAÑADAS BOUWEN ANTONIO.Datos registrales. T 580 , F 30, S 8, H CU 7886, I/A 12 (17.06.13).

23 de Mayo de 2013
Reelecciones. Consejero: ESMILAIRE HERVE;IONISOS SAS;GOMINET MICHEL. Presidente: IONISOS SAS. Datos registrales. T580 , F 29, S 8, H CU 7886, I/A 11 (13.05.13).

28 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: SERVET GONZALEZ FERNANDO. Nombramientos. SecreNoConsj: ALONSO DREGI RAFAEL.VsecrNoConsj: ROMANI SANCHO JUAN. Datos registrales. T 580 , F 28, S 8, H CU 7886, I/A 10 (20.02.13).

21 de Junio de 2011
Reelecciones. Auditor: SCD AUDITORIA SL. Datos registrales. T 580 , F 24, S 8, H CU 7886, I/A 8 (23.05.11).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMINET MICHEL;MORALES DE CASTRO MIGUEL;ESMILAIRE HERVE. Nombramientos.Apo.Man.Soli: GOMINET MICHEL;ESMILAIRE HERVE. Apo.Sol.: GOMINET MICHEL. Apo.Manc.: MORALES DE CASTROMIGUEL;ESMILAIRE HERVE. Apo.Sol.: GOMINET MICHEL;MORALES DE CASTRO MIGUEL. Apo.Man.Soli: MORALES DECASTRO MIGUEL. Datos registrales. T 580 , F 24, S 8, H CU 7886, I/A 9 (23.05.11).

20 de Septiembre de 2010
Reducción de capital. Importe reducción: 161.659,80 Euros. Resultante Suscrito: 677.258,55 Euros. Datos registrales. T 531 , F 49,S 8, H CU 7886, I/A 6 (26.08.10).

Revocaciones. Apoderado: MORENO DE MATIAS MACARIO;LUNA VALDES JOSE;RODERGAS PUNTAS FERNANDO;GOMINETMICHEL;MORALES DE CASTRO MIGUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMINET MICHEL;MORALES DE CASTROMIGUEL;ESMILAIRE HERVE. Datos registrales. T 531 , F 50, S 8, H CU 7886, I/A 7 (27.08.10).

13 de Febrero de 2009
Declaración de unipersonalidad. Socio único: IONISOS SAS. Datos registrales. T 531 , F 48, S 8, H CU 7886, I/A 4 ( 4.02.09).

Reelecciones. Auditor: SCD AUDITORIA SL. Datos registrales. T 531 , F 48, S 8, H CU 7886, I/A 5 ( 4.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información