Buscador CIF Logo

Actos BORME Ipsos Understanding Unlimited Research Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ipsos Understanding Unlimited Research Sa

Actos BORME Ipsos Understanding Unlimited Research Sa - A78387156

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ipsos Understanding Unlimited Research Sa con CIF A78387156

馃敊 Perfil de Ipsos Understanding Unlimited Research Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ipsos Understanding Unlimited Research Sa

30 de Octubre de 2023
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 25129 , F 113, S 8, H M 113875, I/A 91 (23.10.23).

24 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: STOCLET LAURENCE. Presidente: STOCLET LAURENCE. Nombramientos. Consejero: PAGEBENJAMIN CHARLES. Presidente: COSTA ARGELAGUET FRANCESC. Datos registrales. T 25129 , F 113, S 8, H M 113875, I/A 90(17.08.23).

30 de Enero de 2023
Nombramientos. Apoderado: WALLY LAURE. Datos registrales. T 25129 , F 111, S 8, H M 113875, I/A 86 (23.01.23).

21 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Secretario: SEGURA BULDU JUAN. Consejero: STOCLET LAURENCE. Presidente: STOCLET LAURENCE.Consejero: TRUCHOT DIDIER;COSTA ARGELAGUET FRANCESC. Con.Delegado: COSTA ARGELAGUET FRANCESC. Vicepresid.:TRUCHOT DIDIER. Datos registrales. T 25129 , F 111, S 8, H M 113875, I/A 85 (14.11.22).

24 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25129 , F 111, S 8, H M 113875, I/A 84 (17.02.21).

19 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: DOMINGO DE BLAS GREGORIO ENRIQUE. Apoderado: CAMPORRO SANDRINE-KARINE. Datosregistrales. T 25129 , F 111, S 8, H M 113875, I/A 83 (12.02.20).

15 de Marzo de 2018
Nombramientos. Vicepresid.: TRUCHOT DIDIER. Reelecciones. Consejero: TRUCHOT DIDIER;COSTA ARGELAGUETFRANCESC. Con.Delegado: COSTA ARGELAGUET FRANCESC. Secretario: SEGURA BULDU JUAN. Datos registrales. T 25129 ,F 110, S 8, H M 113875, I/A 82 ( 6.03.18).

03 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales.T 25129 , F 110, S 8, H M 113875, I/A 81 (22.09.17).

01 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: HARDING CARLOS GUILLERMO. Presidente: HARDING CARLOS GUILLERMO. Nombramientos.Consejero: STOCLET LAURENCE. Presidente: STOCLET LAURENCE. Datos registrales. T 25129 , F 109, S 8, H M 113875, I/A 80(24.07.17).

11 de Noviembre de 2016
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 25129 , F 109, S 8, H M 113875, I/A 79 ( 2.11.16).

30 de Diciembre de 2014
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SYNOVATE ESPA脩A SA. Datos registrales. T 25129 , F 109, S 8, H M 113875, I/A69 (19.12.14).

04 de Septiembre de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: CAMPORRO SANDRINE-KARINE. Datos registrales. T 25129 , F 108, S 8, H M 113875, I/A 68(27.08.14).

08 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: SARTORIUS ALVARGONZALEZ ALVARO;HERNANDO DOMINGO ANTONIO;SEIJO FONT JUANANTONIO;CALDEIRO ZAMORA JESUS. Datos registrales. T 25129 , F 107, S 8, H M 113875, I/A 67 (30.06.14).

26 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ FAZ NINA;COSTA ARGELAGUET FRANCESC;CAMPORRO SANDRINE-KARINE. Datosregistrales. T 25129 , F 107, S 8, H M 113875, I/A 66 (18.06.14).

19 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: RUBIO IGLESIAS JAVIER. Datos registrales. T 25129 , F 106, S 8, H M 113875, I/A 65 ( 7.05.14).

30 de Diciembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: DUTILH ABOGADOS SLP. Representan: DUTILH CARVAJAL ISABEL. Nombramientos. Secretario:SEGURA BULDU JUAN. Cambio de domicilio social. AVDA LLANO CASTELLANO 13 3潞 A (MADRID). Datos registrales. T 25129, F 106, S 8, H M 113875, I/A 64 (19.12.13).

05 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: URBINA GOMEZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 25129 , F 106, S 8, H M 113875, I/A 63 (27.11.13).

31 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGO DE BLAS GREGORIO ENRIQUE. Presidente: DOMINGO DE BLAS GREGORIOENRIQUE. Con.Delegado: DOMINGO DE BLAS GREGORIO ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: COSTA ARGELAGUETFRANCESC. Presidente: HARDING CARLOS GUILLERMO. Con.Delegado: COSTA ARGELAGUET FRANCESC. Datos registrales.T 25129 , F 105, S 8, H M 113875, I/A 62 (24.10.13).

26 de Abril de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: SARTORIUS ALVARGONZALEZ ALVARO. Apo.Manc.: NAVARRO GARCIA MARINA;SARTORIUSALVARGONZALEZ ALVARO;CALDEIRO ZAMORA JESUS;SARTORIUS ALVARGONZALEZ ALVARO;CALDEIRO ZAMORA JESUS.Datos registrales. T 25129 , F 105, S 8, H M 113875, I/A 61 (18.04.13).

17 de Enero de 2013
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.840.918,00 Euros. Desembolsado: 5.840.918,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.569.570,00 Euros.Resultante Desembolsado: 8.569.570,00 Euros. Datos registrales. T 25129 , F 105, S 8, H M 113875, I/A 60 ( 9.01.13).

08 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAN HULLEN RUPERT;WOODLOCK SIMON. Nombramientos. Consejero: HARDING CARLOSGUILLERMO;TRUCHOT DIDIER. Datos registrales. T 25129 , F 104, S 8, H M 113875, I/A 59 (26.10.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n