Buscador CIF Logo

Actos BORME Ireef-urbil Propco Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ireef-urbil Propco Sl

Actos BORME Ireef-urbil Propco Sl - B87491536

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ireef-urbil Propco Sl con CIF B87491536

馃敊 Perfil de Ireef-urbil Propco Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ireef-urbil Propco Sl

04 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MONGE RUIZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 41668 , F 83, S 8, H M 619505, I/A 17(28.07.23).

28 de Julio de 2022
Cambio de domicilio social. C/ PINAR, NUMERO 7, 1陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 41668 , F 82, S 8, H M 619505,I/A 16 (20.07.22).

03 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: FOY JUSTIN DAMIAN. Nombramientos. Apo.Manc.: THORSTEINSDOTTIR SARA. Datos registrales.T 41668 , F 82, S 8, H M 619505, I/A 15 (26.11.21).

29 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: COSTE FABRICE;GENIAUX MARION;ROFE ANDREW;TAFT ALEXANDER;SCHMITZ SIMONE;BROWNHANNAH;MURRU ANDREA;FOY JUSTIN DAMIAN;KAR SAGARIKA;PASTRANA GOMEZ ELENA;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;CASTA脩O CASTRO CONCEPCION;MORRISON RORY;SANCHEZ-PAMPLONA SANCHEZ-RAMADEMARTIN;CASTA脩O CASTRO CONCEPCION;MONREAL JORDE VICTOR;SANCHEZ-PAMPLONA SANCHEZ-RAMADE MARTIN.Apo.Man.Soli: RUIZ SERRANO ELENA. Apo.Sol.: RUIZ SERRANO ELENA;RUIZ SERRANO ELENA. Nombramientos. Apo.Manc.:COSTE FABRICE;GENIAUX MARION;FOY JUSTIN DAMIAN;KAR SAGARIKA;SCHMITZ SIMONE;GURRALA SRAVANKUMAR;HASAN SHAIKH ABDUL;GOMEZ DIEZ ISABEL;PELAEZ VARA JULIA;PIRES DOS SANTOS FRANCISCO IPO;AYLLONFERNANDEZ MARIA ANGELES;CEACERO ESCOLAR IRENE;RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON. Apo.Sol.: GOMEZ DIEZISABEL;PELAEZ VARA JULIA;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PIRES DOS SANTOS FRANCISCO IPO;AYLLONFERNANDEZ MARIA ANGELES;CEACERO ESCOLAR IRENE;RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON;REY HERNANDEZ DIEGO.Otros conceptos: Revocado el poder conferido a Mar铆a Angeles Ayllon Fern谩ndez, en virtud de escritura autorizada el 5/11/2020, porel Notario de Madrid D. F. Javier Barreiros Fern谩ndez con el n煤mero 2475 de su protocolo, que caus贸 la inscripci贸n 12陋, s贸lo respectoal acuerdo 2潞 del 贸rgano de administraci贸n Revocado el poder conferido a Irene Ceacero Escolar, en virtud de escritura autorizada el5/11/2020, por el Notario de Madrid D. F. Javier Barreiros Fern谩ndez con el n煤mero 2475 de su protocolo, que caus贸 la inscripci贸n 12陋,s贸lo respecto al acuerdo 2潞 del 贸rgano de administraci贸n. Datos registrales. T 41668 , F 80, S 8, H M 619505, I/A 14 (22.09.21).

05 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION. Nombramientos. Adm. Mancom.: PEREZ-PELLONVALENTIN-GAMAZO JULIA. Datos registrales. T 34441 , F 21, S 8, H M 619505, I/A 13 (27.04.21).

20 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: VAN DER MEER SJORS. Revocaciones. Apoderado: ORTEGA SANCHEZ RUBEN;ORTEGASANCHEZ RUBEN. Nombramientos. Adm. Mancom.: PELAEZ VARA JULIA. Apo.Man.Soli: RUIZ SERRANO ELENA;AYLLONFERNANDEZ MARIA ANGELES;CEACERO ESCOLAR IRENE. Apo.Sol.: RUIZ SERRANO ELENA;AYLLON FERNANDEZ MARIAANGELES;CEACERO ESCOLAR IRENE;RUIZ SERRANO ELENA;AYLLON FERNANDEZ MARIA ANGELES;CEACERO ESCOLARIRENE;ORVAY ARROYO MERCEDES. Datos registrales. T 34441 , F 20, S 8, H M 619505, I/A 12 (13.11.20).

19 de Agosto de 2020
Revocaciones. Apoderado: BINGHAM PADDY;SAEZ SERRANO SARA;CARRASCAL ALONSO AURORA;SAEZ SERRANOSARA;SAEZ SERRANO SARA;MELVIN GAMIR MIA MARIA TERESA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA. Nombramientos.Apoderado: MORRISON RORY;SANCHEZ-PAMPLONA SANCHEZ-RAMADE MARTIN;CASTA脩O CASTROCONCEPCION;MONREAL JORDE VICTOR;SANCHEZ-PAMPLONA SANCHEZ-RAMADE MARTIN;ORTEGA SANCHEZ RUBEN.Datos registrales. T 34441 , F 19, S 8, H M 619505, I/A 11 (12.08.20).

29 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA. Revocaciones. Apoderado: GONZALEZHERNANDEZ PALOMA GLORIA;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA. Nombramientos. Adm. Mancom.: CASTA脩OCASTRO CONCEPCION;VAN DER MEER SJORS. Datos registrales. T 34441 , F 19, S 8, H M 619505, I/A 9 (23.11.19).

Nombramientos. Apoderado: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN.Datos registrales. T 34441 , F 19, S 8, H M 619505, I/A 10 (23.11.19).

16 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GOMEZ DIEZ ISABEL. Revocaciones. Apoderado: GOMEZ DIEZ ISABEL;GOMEZ DIEZISABEL. Datos registrales. T 34441 , F 18, S 8, H M 619505, I/A 8 ( 9.10.19).

21 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apoderado: ZIMMER NADJA;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL. Nombramientos. Apoderado: MURRUANDREA;FOY JUSTIN DAMIAN;KAR SAGARIKA;PASTRANA GOMEZ ELENA;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZOJULIA;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA;SAEZ SERRANO SARA;GOMEZ DIEZ ISABEL;MELVIN GAMIR MIA MARIATERESA. Datos registrales. T 34441 , F 18, S 8, H M 619505, I/A 7 (11.05.18).

20 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: NALDER FRANCIS TIMOTHY. Nombramientos. Adm. Mancom.: SAN JUAN MONJEFERNANDO. Datos registrales. T 34441 , F 17, S 8, H M 619505, I/A 6 (10.11.17).

26 de Enero de 2017
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del articulo 7 de los estatutos. Datos registrales. T 34441 , F 17, S 8, H M 619505, I/A 5(19.01.17).

05 de Mayo de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 454.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 457.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:652.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.109.000,00 Euros. Datos registrales. T 34441 , F 15, S 8, H M 619505, I/A 4 (27.04.16).

25 de Abril de 2016
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9. Datos registrales. T 34441 , F 15, S 8, H M 619505, I/A 3(15.04.16).

02 de Marzo de 2016
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 12.02.16. Objeto social: 1. Actividades de las sociedades holding, esto es la direcci贸n ygesti贸n de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio espa帽ol que determinen un porcentajede participaci贸n directa o indirecta, igual o superior al cinco (5) por ciento. Domicilio: C/ PINAR 7 - 5潞 IZQUIERDA (MADRID). Capital:3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: IREEF-SPANISH HOLDCO SA. Nombramientos. Adm. Mancom.:NALDER FRANCIS TIMOTHY;MONGE RUIZ ALEJANDRO;GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA.Datos registrales. T 34441 , F 10, S 8, H M 619505, I/A 1 (24.02.16).

Nombramientos. Apoderado: COSTE FABRICE;GENIAUX MARION;ROFE ANDREW;TAFT ALEXANDER;BINGHAMPADDY;SCHMITZ SIMONE;BROWN HANNAH;ZIMMER NADJA;SAEZ SERRANO SARA;HERNANDEZ HERNANDEZRAQUEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL;GOMEZ DIEZ ISABEL;CARRASCALALONSO AURORA;SAEZ SERRANO SARA. Datos registrales. T 34441 , F 14, S 8, H M 619505, I/A 2 (24.02.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n