Actos BORME de Isoceanpower Sl
07 de Junio de 2023Revocaciones. CONSEJERO: PELLERIN DE MANUEL VICTOR. Datos registrales. T 48147 , F 68, S 8, H B 528897, I/A 19 (5.05.23).
16 de Marzo de 2023Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.206,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.680,00 Euros. Datos registrales. T 48147 , F 68, S 8, H B528897, I/A 18 ( 8.03.23).
24 de Noviembre de 2022Revocaciones. CONSEJERO: GIUSEPPE CAVALLO. Nombramientos. CONSEJERO: NAVARRO VERA MARIA DE LACONCEPCION. Datos registrales. T 48147 , F 67, S 8, H B 528897, I/A 17 (15.11.22).
04 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: PELLERIN DE MANUEL VICTOR. Datos registrales. T 4321, L 4321, F 161, S 8, H PO 63708, I/A 9(22.04.21).
Nombramientos. Apoderado: CANTO TORTOSA ANDREA. Datos registrales. T 4321, L 4321, F 161, S 8, H PO 63708, I/A 10(22.04.21).
22 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GUINART ROYO FRANCISCO DE PAULA;ROSELLINI FABRIZIO;CAVALLO GIUSEPPE. Presidente:GUINART ROYO FRANCISCO DE PAULA. Con.Delegado: GUINART ROYO FRANCISCO DE PAULA. SecreNoConsj: DE CRUILLESDE P. VIOLA RAUL. Nombramientos. Consejero: GUINART ROYO FRANCISCO DE PAULA. Presidente: GUINART ROYOFRANCISCO DE PAULA. Consejero: BEJAR MU脩OZ JORDI. Secretario: BEJAR MU脩OZ JORDI. Consejero: ROSELLINIFABRIZIO;CAVALLO GIUSEPPE;MEDOU GARCIA IVAN. Con.Delegado: MEDOU GARCIA IVAN. Ampliaci贸n de capital. Capital:919,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.419,00 Euros. Datos registrales. T 4321, L 4321, F 160, S 8, H PO 63708, I/A 8 (12.02.21).
11 de Noviembre de 2020Cambio de domicilio social. PLAZA DE COMPOSTELA 23 2潞 - DERECHA (VIGO). Datos registrales. T 4321, L 4321, F 160, S 8,H PO 63708, I/A 7 (30.10.20).
03 de Junio de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BEJAR MU脩OZ JORDI;GUINART ROYO FRANCISCO DE PAULA. Nombramientos. Consejero:GUINART ROYO FRANCISCO DE PAULA;ROSELLINI FABRIZIO;CAVALLO GIUSEPPE. Presidente: GUINART ROYO FRANCISCODE PAULA. Con.Delegado: GUINART ROYO FRANCISCO DE PAULA. SecreNoConsj: DE CRUILLES DE P. VIOLA RAUL. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T4321, L 4321, F 160, S 8, H PO 63708, I/A 6 (26.05.20).
19 de Mayo de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 750,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.500,00 Euros. Datos registrales. T 4242, L 4242, F 84, S 8, HPO 63708, I/A 5 (11.05.20).
10 de Marzo de 2020Cambio de domicilio social. C/ RUA PADRE SEIXAS 38 15B (VIGO). Datos registrales. T 4242, L 4242, F 82, S 8, H PO 63708,I/A 3 ( 2.03.20).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 4潞 de los estatutos sociales correspondientes al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales.T 4242, L 4242, F 84, S 8, H PO 63708, I/A 4 ( 2.03.20).
27 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: PELLERIN DE MANUEL VICTOR. Datos registrales. T 4242, L 4242, F 81, S 8, H PO 63708, I/A 2(20.11.18).
21 de Junio de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 28.02.18. Objeto social: -El comercio al por mayor, no especializado, de productosalimenticios, bebidas y tabaco. -Comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados. Domicilio: C/URZAIZ 21 1潞 B (VIGO). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: GUINART ROYO FRANCISCO DE PAULA;BEJARMU脩OZ JORDI. Datos registrales. T 4242, L 4242, F 80, S 8, H PO 63708, I/A 1 (13.06.18).