Buscador CIF Logo

Actos BORME Isolux Corsan Aparcamientos Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Isolux Corsan Aparcamientos Sa

Actos BORME Isolux Corsan Aparcamientos Sa - A84626076

Tenemos registrados 34 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Isolux Corsan Aparcamientos Sa con CIF A84626076

馃敊 Perfil de Isolux Corsan Aparcamientos Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Isolux Corsan Aparcamientos Sa

10 de Noviembre de 2023
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 15/09/2023. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS.Resoluciones: Se aprueba la propuesta de convenio de la concursada. Datos registrales. T 35495 , F 19, S 8, H M 399148, I/A C (2.11.23).

24 de Marzo de 2023
Cambio de domicilio social. C/ GENOVA, NUMERO 15 (MADRID). Datos registrales. T 35495 , F 19, S 8, H M 399148, I/A 59(16.03.23).

04 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 35495 , F 17, S 8, H M 399148, I/A 58(27.10.22).

29 de Julio de 2022
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 8/06/2022. Auto de apertura de la fase deconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS.Resoluciones: Se declara finalizada la fase com煤n del procedimiento concursal. Se abre la fase de convenio, form谩ndose la secci贸nquinta. Datos registrales. T 35495 , F 16, S 8, H M 399148, I/A B (21.07.22).

08 de Junio de 2022
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;MORENO ALVAREZ LUIS;PIREABARCA FERNANDO JAVIER;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;MARTIN CASTELLO FELIX;MARTIN CASTELLO FELIX;FOJOARIAS LINO;HERNANDEZ MU脩OZ ANTONIO JESUS;MORENO GRANDE FRANCISCO;SANCHEZ ROJAS JUAN DE DIOS;CALVOREY MANUEL;MARTINEZ LARRAD DANIEL EUSEBIO;ORTIZ DE LA TABLA GONZALEZ JOSE;CODES DIAZ QUETCUTIMANUEL;MINGUITO MARTIN JESUS;LAYOS PARDO JOSE ANTONIO;ARIAS GONZALEZ FERNANDO;ATIENZA LA ORDENJORGE;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;RUIZ DE CASTA脩EDA RODRIGUEZ HENAR;GONZALO HERNANDO MIGUEL;GARCIACREUS RUIZ BERDEJO PEDRO. Apo.Manc.: CRUZ CRUZ BEGO脩A. Apoderado: VARELA ULLASTRES SANTIAGO;MARTINEZBORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOSMANUEL JOSE. Apoderado: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO. Apo.Manc.: GARCIA MATEOSMANUEL JOSE. Apo.Man.Soli: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO. Apoderado: CASADO MARCOS ESTHER. Apo.Man.Soli: VIAOZALLA OSCAR;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL.Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;SAR GOMEZEUGENIO RAMON;MARSAL MOYANO RICARDO;VIA OZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Apoderado: PIREABARCA FERNANDO JAVIER. Apo.Sol.: SANCHEZ ROJAS JUAN DE DIOS;HERNANDEZ MU脩OZ ANTONIOJESUS;SAGASTIZABAL CARDELUS ALFONSO MARIA. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUELJOSE;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;GOMEZMARTINEZ CRISTIAN;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;VIA OZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Apoderado:GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN. Apo.Sol.: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN. Apo.Manc.: SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZBEGO脩A. Apoderado: BENITO RICHARD DAVID;REINA PINTO JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli: VARELA ULLASTRESSANTIAGO;BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;REINA PINTO JUAN CARLOS. Apo.Sol.: VIEJO GONZALEZ DOLORES. Apo.Man.Soli:VERA MARTINEZ RAUL ENRIQUE. Apo.Sol.: HERNANDEZ MU脩OZ ANTONIO JESUS. Apo.Man.Soli: GARRIDO ESPA MIGUEL.Apo.Manc.: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;VERA MARTINEZ RAUL ENRIQUE;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;CRUZCRUZ BEGO脩A;ALVAREZ DIAZ DE CERIO CARLOS. Apo.Man.Soli: BUSCA MARTIN-SANZ ALVARO;REINA PINTO JUANCARLOS. Apo.Sol.: RODRIGUEZ DORADO GONZALO;MEDIANO LORENCI YOLANDA;JESUS CHAVES DECLARA;LOPEZ PEREZROBERTO. Apo.Manc.: DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;ALVAREZ DIAZ DE CERIO CARLOS;CRUZ CRUZBEGO脩A;PEREZ GARCIA SANDRA;SERRANO SANCHEZ FERNANDO. Apo.Man.Soli: BUSCA MARTIN-SANZ ALVARO;ESPARZATORRECILLA JESUS;REINA PINTO JUAN CARLOS. Apo.Manc.: CRUZ CRUZ BEGO脩A. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ DORADOGONZALO. Apo.Manc.: DE LAS CASAS GONZALEZ LUIS. Datos registrales. T 35495 , F 16, S 8, H M 399148, I/A 57 ( 1.06.22).

22 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: LIMON HOSTENCH JAIME;JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;JONES ELORRIAGA ALFREDO;NAVAS-PAREJO MENDEZ EMILIO. Datos registrales. T 35495 , F 15, S 8, H M 399148, I/A 56 (15.12.21).

03 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: BRAVO IVORRA ALFONSO;LIMON HOSTENCH JAIME;JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;NAVASPAREJOMENDEZ EMILIO. Datos registrales. T 35495 , F 15, S 8, H M 399148, I/A 55 (27.05.21).

29 de Octubre de 2020
Cambio de domicilio social. C/ Cristobal Bordi煤 35 - ENTREPLANTA, LOCAL 1 (MADRID). Datos registrales. T 35495 , F 14, S 8,H M 399148, I/A 54 (22.10.20).

07 de Agosto de 2020
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO ISOLUX EPC SL. Datos registrales. T 35495 , F 14, S 8, H M 399148, I/A53 (31.07.20).

06 de Agosto de 2020
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 28 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 35495 ,F 14, S 8, H M 399148, I/A 52 (30.07.20).

06 de Julio de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;LIMON HOSTENCH JAIME. Datos registrales. T 35495 , F 14, S 8, HM 399148, I/A 51 (29.06.20).

24 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: REINA PINTO JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: VERA VAZQUEZ FRANCISCO.Datos registrales. T 35495 , F 13, S 8, H M 399148, I/A 50 (17.02.20).

27 de Enero de 2020
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO.Resoluciones: Se declara la firmeza del auto de 29 de mayo de 2018 por el que se anot贸 la declaraci贸n de concurso de acreedores,nombramiento de administrador concursal. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n29/05/2018. Resoluci贸n judicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DEMADRID. Juez: CARLOS NIETO. Resoluciones: Se acumula el concurso al procedimiento 700/2017 del mismo juzgadocorrespondiente a la sociedad Grupo Isolux Corsan SA. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: Si, Fechade resoluci贸n 29/05/2018. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n delconcursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Datosregistrales. T 35495 , F 13, S 8, H M 399148, I/A 49 (16.01.20).

31 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: AVILA ALVAREZ FEDERICO. Apo.Man.Soli: AVILA ALVAREZ FEDERICO. Datos registrales. T 35495 , F13, S 8, H M 399148, I/A 48 (24.05.19).

29 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apoderado: MARTIN FRANCISCO DAMIAN DOROTEO. Datos registrales. T 35495 , F 13, S 8, H M 399148, I/A 47(22.05.19).

28 de Diciembre de 2018
Cambio de domicilio social. AVDA DE MANOTERAS NUMERO 18 (MADRID). Datos registrales. T 35495 , F 13, S 8, H M 399148,I/A 46 (20.12.18).

17 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: AVILA ALVAREZ FEDERICO;REINA PINTO JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico:REINA PINTO JUAN CARLOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 35495 , F 12, S 8, H M 399148, I/A 45 ( 9.10.18).

29 de Junio de 2018
Nombramientos. Representan: VERA VAZQUEZ FRANCISCO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME:No, Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTILDE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: Se declara en concurso de acreedores de car谩cter voluntario. Eldeudor conserva.las facultades de administraci贸n y disposici贸n sobre su patrimonio. Se acuerda la acumulaci贸n de los anterioresconcursos al que se tramita bajo los autos de concurso n煤mero 700/2017, para su tramitaci贸n coordinada bajo. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 779/2018. Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADODE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 29/05/2018, NIF/CIFB65793879. DATA CONCURSAL SLP. Datos registrales. T 35495 , F 12, S 8, H M 399148, I/A A (20.06.18).

14 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BUSCA MARTIN-SANZ ALVARO;ESPARZA TORRECILLA JESUS;REINA PINTO JUANCARLOS;AVILA ALVAREZ FEDERICO. Apo.Manc.: CRUZ CRUZ BEGO脩A. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ DORADO GONZALO.Apo.Manc.: DE LAS CASAS GONZALEZ LUIS. Datos registrales. T 35495 , F 5, S 8, H M 399148, I/A 44 ( 7.05.18).

19 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN. Consejero: REINA PINTO JUAN CARLOS;BUSCA MARTINSANZ ALVARO. Vicepresid.: REINA PINTO JUAN CARLOS. Consejero: LWOFF IVANISSEVICH ALEJANDRA. Presidente: LWOFFIVANISSEVICH ALEJANDRA. Nombramientos. Adm. Mancom.: AVILA ALVAREZ FEDERICO;REINA PINTO JUAN CARLOS.Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 19, 25, 26, 27, 29, 30 31 y 32 y en consecuencia la totaltiad de los estatutossociales. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados.Datos registrales. T 35495 , F 2, S 8, H M 399148, I/A 43 ( 7.03.18).

17 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALCARAZ GARCIA IGNACIO. Presidente: ALCARAZ GARCIA IGNACIO. Nombramientos.Presidente: LWOFF IVANISSEVICH ALEJANDRA. Datos registrales. T 35495 , F 1, S 8, H M 399148, I/A 42 ( 9.05.17).

27 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: PORTELA ALVAREZ ANTONIO DE PADUA. Presidente: PORTELA ALVAREZ ANTONIO DE PADUA.Consejero: MARTINEZ QUEIMADELOS MARTA VIOLETA. Nombramientos. Consejero: ALCARAZ GARCIA IGNACIO;LWOFFIVANISSEVICH ALEJANDRA. Presidente: ALCARAZ GARCIA IGNACIO. Datos registrales. T 35495 , F 1, S 8, H M 399148, I/A 41(12.04.17).

13 de Enero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO DELSO. Nombramientos. Consejero: MARTINEZQUEIMADELOS MARTA. Datos registrales. T 30329 , F 133, S 8, H M 399148, I/A 40 ( 4.01.17).

30 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BUSCA MARTIN-SANZ ALVARO;REINA PINTO JUAN CARLOS. Apo.Sol.: JIMENEZ AGUAYOESTEBAN;LIMON HOSTENCH JAIME;RODRIGUEZ DORADO GONZALO;AVILA ALVAREZ FEDERICO;MEDIANO LORENCIYOLANDA;JESUS CHAVES DECLARA;LOPEZ PEREZ ROBERTO. Apo.Manc.: DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;ALVAREZDIAZ DE CERIO CARLOS;CRUZ CRUZ BEGO脩A;PEREZ GARCIA SANDRA;SERRANO SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales.T 30329 , F 129, S 8, H M 399148, I/A 39 (17.08.16).

12 de Mayo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: RAMIREZ DEL MOLINO ALVARODELSO. Datos registrales. T 30329 , F 128, S 8, H M 399148, I/A 38 ( 5.05.16).

03 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ TELLO ANTONIO;SANCHEZ TELLO ANTONIO. Apo.Manc.: SANCHEZ TELLOANTONIO;SANCHEZ TELLO ANTONIO;SANCHEZ TELLO ANTONIO. Datos registrales. T 30329 , F 128, S 8, H M 399148, I/A 37(24.02.16).

14 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;VERA MARTINEZ RAUL ENRIQUE;DELSO RAMIREZ DEL MOLINOALVARO;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A;ALVAREZ DIAZ DE CERIO CARLOS. Datos registrales. T 30329 , F127, S 8, H M 399148, I/A 35 ( 6.10.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ TORRALBO ANTONIO. Datos registrales. T 30329 , F 128, S 8, H M 399148, I/A 36 (6.10.15).

08 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER. Secretario: PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER.Nombramientos. Consejero: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO. SecreNoConsj: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN. Apo.Man.Soli:VALERA ULLASTRES SANTIAGO;BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;REINA PINTO JUAN CARLOS. Apo.Sol.: JIMENEZ AGUAYOESTEBAN;VIEJO GONZALEZ DOLORES. Apo.Man.Soli: VERA MARTINEZ RAUL ENRIQUE. Apo.Sol.: HERNANDEZ MU脩OZANTONIO JESUS. Apo.Man.Soli: GARRIDO ESPA MIGUEL. Datos registrales. T 30329 , F 122, S 8, H M 399148, I/A 34 (29.09.15).

06 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO. Vicepresid.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO.Nombramientos. Consejero: REINA PINTO JUAN CARLOS. Vicepresid.: REINA PINTO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 30329, F 119, S 8, H M 399148, I/A 33 (28.09.15).

13 de Mayo de 2014
Nombramientos. Apoderado: BENITO RICHARD DAVID;REINA PINTO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 30329 , F 119, S 8, HM 399148, I/A 32 ( 6.05.14).

31 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: VALENZUELA CONTRERAS COSME;VALENZUELA CONTRERAS COSME. Apo.Manc.: VALENZUELACONTRERAS COSME;VALENZUELA CONTRERAS COSME;VALENZUELA CONTRERAS COSME Datos registrales. T 30329 , F118, S 8, H M 399148, I/A 31 (21.03.14).

20 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DURAN BARBARA. Datos registrales. T 30329 , F 118, S 8, H M 399148, I/A 30(12.02.14).

16 de Diciembre de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30329 , F 118, S 8, H M 399148,I/A 29 ( 5.12.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n