Buscador CIF Logo

Actos BORME Italfarmaco Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Italfarmaco Sa

Actos BORME Italfarmaco Sa - A78570611

Tenemos registrados 68 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Italfarmaco Sa con CIF A78570611

馃敊 Perfil de Italfarmaco Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Italfarmaco Sa

11 de Agosto de 2023
Reelecciones. Consejero: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO;GUELFO SCIALDONE SAVERIO;SAENZ ESPINOSAJOSE ANTONIO;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Presidente: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Consejero:PALACIOS PEREZ JOSE. SecreNoConsj: ENSE脩AT BENLLIURE JAIME LUIS. Datos registrales. T 42249 , F 119, S 8, H M 26060,I/A 125 ( 4.08.23).

14 de Junio de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: D`ANTUONO MARGHERITA. Nombramientos. Apoderado: URSO KATIA;GONZALEZ ZAPATAFRANCISCO JOSE;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER;RODRIGUEZ BELTRAN TERESA;NOMBELAGORDO LEONOR ELENA. Datos registrales. T 42249 , F 118, S 8, H M 26060, I/A 124 ( 7.06.23).

05 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ MILLAN JAIME. Nombramientos. Apoderado: VILCHEZ QUINO TATIANAARACELLI;GARCIA ESTEBAN VERONICA;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER;RODRIGUEZ BELTRANTERESA;NOMBELA GORDO LEONOR ELENA. Datos registrales. T 42249 , F 117, S 8, H M 26060, I/A 123 (29.03.23).

13 de Enero de 2023
Nombramientos. Consejero: PALACIOS PEREZ JOSE. Datos registrales. T 42249 , F 115, S 8, H M 26060, I/A 121 ( 5.01.23).

Revocaciones. Apoderado: MAS GARCIA ENCARNACION. Nombramientos. Apoderado: NOMBELA GORDO LEONORELENA;PRESEDO HUETE JAVIER;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;GARCIA MARIN JOSE. Datos registrales. T 42249 , F 115, S8, H M 26060, I/A 122 ( 5.01.23).

23 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 42249 , F 115, S 8, H M 26060, I/A 120 (16.12.22).

02 de Agosto de 2022
Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: PALACIOS PEREZ JOSE. Revocaciones. Apoderado: NIETO MAGRO CONCEPCION;LEDESMASANCHEZ-CA脩ETE EMILIO-FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ LOPEZ CELIA;LEDESMA SANCHEZ-CA脩ETEEMILIO-FERNANDO;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER;BARJA DE SOROA MARIA PALOMA;CAROLAROSES SANTIAGO;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER. Reelecciones. Consejero: DIAVERICO MARIADE SANTIS FRANCESCO;GUELFO SCIALDONE SAVERIO;SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO.Presidente: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. SecreNoConsj: ENSE脩AT BENLLIURE JAIME LUIS. Datos registrales.T 42249 , F 113, S 8, H M 26060, I/A 119 (26.07.22).

01 de Abril de 2022
Revocaciones. Apoderado: ZAMORANO SANCHEZ MARIA ALICIA. Apo.Sol.: FRAILE GOMEZ CRISTINA. Nombramientos.Apo.Man.Soli: VAZQUEZ LOPEZ CELIA. Apo.Sol.: NOVA NOVA MYRIAM;DIAZ POLLAN CONCEPCION. Apo.Manc.: ACEBRONFERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER. Datos registrales. T 42249 , F 112, S 8, H M 26060, I/A 118 (25.03.22).

20 de Diciembre de 2021
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ANNEPHIL SL. ATHIA FINANCE SL. Datos registrales. T 42249 , F 110, S 8, H M26060, I/A 117 (13.12.21).

03 de Diciembre de 2021
Otros conceptos: Se han actualizado los datos personales de los actuales miembros del consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 31877 , F 225, S 8, H M 26060, I/A 115M (26.11.21).

15 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 42249 , F 110, S 8, H M 26060, I/A116 ( 7.10.21).

24 de Septiembre de 2021
Reelecciones. SecreNoConsj: ENSE脩AT BENLLIURE JAIME LUIS. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 115 de lasociedad el nombramiento de don Jaime Luis Ense帽at Benlliure como Secretario No Consejero de la misma. Datos registrales. T31877 , F 224, S 8, H M 26060, I/A 115 ( 4.08.21).

11 de Agosto de 2021
Revocaciones. Apoderado: MOSCOSO DEL PRADO JAIME. Nombramientos. Apoderado: CAMPOS PITA MANUEL.Reelecciones. Consejero: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO;GUELFO SCIALDONE SAVERIO;SAENZ ESPINOSAJOSE ANTONIO. Con.Ind.: PALACIOS PEREZ JOSE. Consejero: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Presidente: DIAVERICO MARIADE SANTIS FRANCESCO. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los art铆culos 19 BIS, 26 y 27 de los Estatutos Sociales.Datos registrales. T 31877 , F 224, S 8, H M 26060, I/A 115 ( 4.08.21).

20 de Abril de 2021
Revocaciones. Apoderado: DELGADO ALONSO ALEJANDRO. Nombramientos. Apoderado: ACEBRON FERNANDEZALVARO;CAROLA ROSES SANTIAGO;PRESEDO HUETE JAVIER;URSO KATIA;NARDI ANTONIO. Datos registrales. T 31877 , F224, S 8, H M 26060, I/A 114 (13.04.21).

22 de Diciembre de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: UCERO GIL ADRIANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Apo.Sol.:FERNANDEZ MILLAN JAIME. Apo.Manc.: CAROLA ROSES SANTIAGO. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 30de los Estatutos sociales. Datos registrales. T 31877 , F 223, S 8, H M 26060, I/A 113 (15.12.20).

15 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31877 , F 223, S 8, H M 26060, I/A112 ( 7.10.20).

30 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: UCERO GIL ADRIANA. Apo.Sol.: D`ANTUONO MARGHERITA. Reelecciones. Consejero:DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO;GUELFO SCIALDONE SAVERIO;SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO. Con.Ind.:PALACIOS PEREZ JOSE. Consejero: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Presidente: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO.SecreNoConsj: ENSE脩AT BENLLIURE JAIME LUIS. Ampliacion del objeto social. La prestaci贸n de servicios de asesoramiento yde actividades de coordinaci贸n y apoyo en favor de otras antidades participadas, vinculadas o pertenecientes a su mismo grupoempresarial.- Datos registrales. T 31877 , F 222, S 8, H M 26060, I/A 111 (23.09.20).

27 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: WILLSON DENNIS FREDERIK. Datos registrales. T 31877 , F 221, S 8, H M 26060, I/A 110(20.07.20).

22 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: DOMENECH CIANCAS JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 31877 , F 221, S 8, H M 26060, I/A 109(15.11.19).

25 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Consejero: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO;GUELFO SCIALDONE SAVERIO;SAENZ ESPINOSAJOSE ANTONIO. Con.Ind.: PALACIOS PEREZ JOSE;WILLSON DENNIS FREDERIK. Consejero: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO.Presidente: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. SecreNoConsj: ENSE脩AT BENLLIURE JAIME LUIS. Datos registrales.T 31877 , F 220, S 8, H M 26060, I/A 107 (18.09.19).

Nombramientos. Apoderado: PRESEDO HUETE JAVIER;RODRIGUEZ BELTRAN TERESA. Datos registrales. T 31877 , F 220, S8, H M 26060, I/A 108 (18.09.19).

03 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31877 , F 219, S 8, H M 26060, I/A106 (27.08.19).

25 de Julio de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: FRAILE GOMEZ CRISTINA;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER. Datosregistrales. T 31877 , F 219, S 8, H M 26060, I/A 105 (18.07.19).

13 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA MARIN JOSE. Apoderado: RODRIGUEZ BELTRAN TERESA;RODRIGUEZ FLORES JOSE.Apo.Sol.: ORTIZ CA脩AVATE MARIA LUISA;ALCANTARA CANO PILAR. Apo.Man.Soli: SAENZ ESPINOSA JOSEANTONIO;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;NIETO MAGRO CONCEPCION. Apoderado: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO.Apo.Sol.: DELGADO ALONSO ALEJANDRO. Nombramientos. Apoderado: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETEJAVIER;RODRIGUEZ BELTRAN TERESA;NIETO MAGRO CONCEPCION;MAS GARCIA ENCARNACION;GARCIA MARINJOSE;ZAMORANO SANCHEZ MARIA ALICIA;ALEMAN TAISMA JOSE;MOSCOSO DEL PRADO JAIME;AGUILERA GIMENEZ JOSEMANUEL;CAROLA ROSES SANTIAGO;DELGADO ALONSO ALEJANDRO. Datos registrales. T 31877 , F 216, S 8, H M 26060, I/A104 ( 6.05.19).

22 de Abril de 2019
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 30 DE LOS ESTATUTO SOCIALES. Datos registrales. T 31877 , F215, S 8, H M 26060, I/A 103 (11.04.19).

12 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Dir. General: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Datos registrales. T 31877 , F 215, S 8, H M 26060, I/A 102 (5.04.19).

27 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Nombramientos. Apo.Sol.: DIAVERICO MARIA DESANTIS FRANCESCO. Datos registrales. T 31877 , F 214, S 8, H M 26060, I/A 101 (20.02.19).

28 de Enero de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: DELGADO ALONSO ALEJANDRO. Datos registrales. T 31877 , F 214, S 8, H M 26060, I/A 100(21.01.19).

24 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Reelecciones. Consejero: DIAVERICO MARIADE SANTIS FRANCESCO;GUELFO SCIALDONE SAVERIO;SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO. Con.Ind.: PALACIOS PEREZJOSE;WILLSON DENNIS FREDERIK. Consejero: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. SecreNoConsj: ENSE脩AT BENLLIURE JAIMELUIS. Presidente: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 30 de losestatutos sociales y eliminado el art铆culo 30Bis.. Datos registrales. T 31877 , F 213, S 8, H M 26060, I/A 99 (17.10.18).

27 de Septiembre de 2018
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 96陋 EL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJEROS DE WILLSONDENNIS FREDERIK Y PALACIOS PEREZ JOSE, SIENDO LO CORRECTO CONSEJEROS INDEPENDIENTES. Datos registrales. T31877 , F 210, S 8, H M 26060, I/A 96 (15.09.17).

17 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: DE ENTRAMBASAGUAS ARCONES OLGA MARIA. Datos registrales. T 31877 , F 212, S 8, H M26060, I/A 98 ( 9.07.18).

28 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: GUELFO SCIALDONE SAVERIO. Revocaciones. Apoderado: SCIALDONE SAVERIO GUELFO.Datos registrales. T 31877 , F 212, S 8, H M 26060, I/A 97 (21.02.18).

26 de Septiembre de 2017
Reelecciones. SecreNoConsj: ENSE脩AT BENLLIURE JAIME LUIS. Presidente: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO.Consejero: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO;GUELFO SCIALDONE SAVERIO;SAENZ ESPINOSA JOSEANTONIO;PALACIOS PEREZ JOSE;WILLSON DENNIS FREDERIK;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Cons.Del.Sol: GUELFOSCIALDONE SAVERIO;DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Datos registrales. T 31877 , F 210, S 8, H M 26060, I/A 96(15.09.17).

11 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ CAMPILLO RAQUEL;DOMENECH CIANCAS JOSE MIGUEL;FERNANDEZ ESCRIBANOFERNANDEZ JOAQUIN IGNACIO. Datos registrales. T 31877 , F 209, S 8, H M 26060, I/A 94 ( 2.01.17).

Revocaciones. Apoderado: PUIG-DURAN FRESCO RAFAEL. Datos registrales. T 31877 , F 210, S 8, H M 26060, I/A 95 ( 3.01.17).

29 de Diciembre de 2016
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: BARALLOBRE GORDON CARLOS. Reelecciones. SecreNoConsj:ENSE脩AT BENLLIURE JAIME LUIS. Presidente: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Cons.Del.Sol: GUELFOSCIALDONE SAVERIO;DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Consejero: DIAVERICO MARIA DE SANTISFRANCESCO;GUELFO SCIALDONE SAVERIO;SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;PALACIOS PEREZ JOSE;WILLSON DENNISFREDERIK;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Datos registrales. T 31877 , F 207, S 8, H M 26060, I/A 93 (20.12.16).

03 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31877 , F 207, S 8, H M 26060,I/A 92 (25.10.16).

16 de Octubre de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31877 , F 207, S 8, H M 26060, I/A 91 ( 8.10.15).

06 de Octubre de 2015
Modificaciones estatutarias. 30. El cargo de Consejero es retribuido.-. Se incorpora un nuevo articulo a los Estatutos Sociales, elarticulo 30 Bis.--. Datos registrales. T 31877 , F 206, S 8, H M 26060, I/A 90 (28.09.15).

18 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Consejero: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO;GUELFO SCIALDONE SAVERIO;SAENZ ESPINOSAJOSE ANTONIO;PALACIOS PEREZ JOSE;WILLSON DENNIS FREDERIK;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Presidente:DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Datos registrales. T 31877 , F 204, S 8, H M 26060, I/A 88 (10.09.15).

Reelecciones. Cons.Del.Sol: GUELFO SCIALDONE SAVERIO;DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Datos registrales. T31877 , F 204, S 8, H M 26060, I/A 89 (10.09.15).

27 de Mayo de 2015
Nombramientos. Consejero: BARALLOBRE GORDON CARLOS. Datos registrales. T 31877 , F 204, S 8, H M 26060, I/A 87(18.05.15).

13 de Enero de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31877 , F 203, S 8, H M 26060, I/A 86 ( 2.01.15).

27 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;SCIALDONE SAVERIO;DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCOMARIA. Presidente: DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCO MARIA. Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO;DIAVERICO DE SANTISFRANCESCO MARIA. Consejero: SANTABARBARA SANCHEZ PEDRO;PALACIOS PEREZ JOSE;WILLSON DENNIS FREDERIK.Nombramientos. Consejero: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO;GUELFO SCIALDONE SAVERIO;SAENZ ESPINOSAJOSE ANTONIO;PALACIOS PEREZ JOSE;WILLSON DENNIS FREDERIK;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Presidente:DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Cons.Del.Sol: GUELFO SCIALDONE SAVERIO. SecreNoConsj: ENSE脩ATBENLLIURE JAIME LUIS. Cons.Del.Sol: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Datos registrales. T 31877 , F 202, S 8, HM 26060, I/A 85 (20.08.14).

08 de Mayo de 2014
Reelecciones. Consejero: WILLSON DENNIS FREDERIK. Datos registrales. T 31877 , F 201, S 8, H M 26060, I/A 84 (28.04.14).

06 de Marzo de 2014
Nombramientos. Apoderado: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Datos registrales. T 27073 , F 225, S 8, H M 26060, I/A 83(24.02.14).

30 de Diciembre de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27073 , F 225, S 8, H M 26060, I/A 82 (20.12.13).

09 de Diciembre de 2013
Reelecciones. Consejero: SANTABARBARA SANCHEZ PEDRO;PALACIOS PEREZ JOSE. Datos registrales. T 27073 , F 225, S 8,H M 26060, I/A 81 (26.11.13).

12 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCO MARIA;SCIALDONE SAVERIO. Nombramientos.Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO;DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCO MARIA. Reelecciones. Consejero: SAENZESPINOSA JOSE ANTONIO;SCIALDONE SAVERIO;DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCO MARIA. Presidente: DIAVERICO DESANTIS FRANCESCO MARIA. Secretario: ENSE脩AT BENLLIURE JAIME LUIS. Datos registrales. T 27073 , F 222, S 8, H M 26060,I/A 79 ( 1.08.13).

Modificaciones estatutarias. 27. Administraci贸n y Representacion.-. Otros conceptos: Se introduce un nuevo art铆culo en losestatutos sociales. -Art铆culo 19.bis- Datos registrales. T 27073 , F 224, S 8, H M 26060, I/A 80 ( 1.08.13).

24 de Mayo de 2013
Nombramientos. Consejero: WILLSON DENNIS FREDERIK. Datos registrales. T 27073 , F 222, S 8, H M 26060, I/A 78 (17.05.13).

27 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Consejero: SANTABARBARA SANCHEZ PEDRO;PALACIOS PEREZ JOSE. Datos registrales. T 27073 , F 222, S8, H M 26060, I/A 77 (18.12.12).

07 de Diciembre de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27073 , F 222, S 8, H M 26060, I/A 76 (27.11.12).

13 de Septiembre de 2012
Segregaci贸n. Beneficiarios de la segregaci贸n: ITF RESEARCH PHARMA SL. Datos registrales. T 27073 , F 220, S 8, H M 26060,I/A 75 (31.08.12).

07 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: PAJANI GIANFRANCO;FOLINO ITALO. Nombramientos. Con.Delegado: DIAVERICO DE SANTISFRANCESCO MARIA;SCIALDONE SAVERIO. Reelecciones. Consejero: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;SCIALDONESAVERIO;DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCO MARIA. Presidente: DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCO MARIA. Datosregistrales. T 27073 , F 218, S 8, H M 26060, I/A 73 (26.07.12).

Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 25 Y 26 DE LOS ESTATUTOS.. Datos registrales. T 27073 , F220, S 8, H M 26060, I/A 74 (26.07.12).

10 de Julio de 2012
Otros conceptos: DEPOSITO DEL PROYECTO DE SEGREGACION DE LA SOCIEDAD DE ESTAHOJA, SIENDO BENEFICIARIADE LA MISMA , LA SOCIEDAD " ITF RESEARCH PHARMA SL " .- Datos registrales. T 1398 , F 101, S 8, H M 26060, I/A 24-M(28.06.12).

23 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27073 , F 218, S 8, H M 26060, I/A 72 (13.12.11).

26 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Cons.Del.Sol: DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCO MARIA. Consejero: SAENZ ESPINOSA JOSEANTONIO;PAJANI GIANFRANCO;SCIALDONE SAVERIO;DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCO MARIA;FOLINO ITALO. Presidente:DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCO MARIA. Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO. Secretario: ENSE脩AT BENLLIURE JAIMELUIS. Datos registrales. T 27073 , F 217, S 8, H M 26060, I/A 71 (14.09.11).

10 de Febrero de 2011
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ SANCHEZ REGINO. Datos registrales. T 27073 , F 217, S 8, H M 26060, I/A 70 ( 1.02.11).

18 de Enero de 2011
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27073 , F 217, S 8, H M 26060, I/A 69 ( 4.01.11).

15 de Diciembre de 2010
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 26.-. Datos registrales. T 27073 , F 214, S 8, H M 26060, I/A 67 ( 1.12.10).

Reelecciones. Cons.Del.Sol: DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCO MARIA. Consejero: SAENZ ESPINOSA JOSEANTONIO;PAJANI GIANFRANCO;SCIALDONE SAVERIO;DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCO MARIA;FOLINO ITALO. Presidente:DIAVERICO DE SANTIS FRANCESCO MARIA. Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO. Secretario: ENSE脩AT BENLLIURE JAIMELUIS. Datos registrales. T 27073 , F 214, S 8, H M 26060, I/A 68 ( 1.12.10).

24 de Marzo de 2010
Revocaciones. Apoderado: BANFI TOSI BEATRIZ. Nombramientos. Apoderado: BANFI TOSI BEATRIZ. Datos registrales. T27073 , F 214, S 8, H M 26060, I/A 66 (11.03.10).

10 de Diciembre de 2009
Modificaciones estatutarias. 30. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 16456 , F 215, S 8, H M 26060, I/A 65

09 de Diciembre de 2009
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 16456 , F 215, S 8, H M 26060, I/A 64 (26.11.09).

29 de Mayo de 2009
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ ALVAREZ MAXIMO. Datos registrales. T 16456 , F 215, S 8, H M 26060, I/A 63 (19.05.09).

13 de Enero de 2009
Nombramientos. Apoderado: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 16456 , F 215, S 8, H M 26060, I/A 62(29.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n