Buscador CIF Logo

Actos BORME Itf Abacus Farma Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Itf Abacus Farma Sa

Actos BORME Itf Abacus Farma Sa - A87440285

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Itf Abacus Farma Sa con CIF A87440285

馃敊 Perfil de Itf Abacus Farma Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Itf Abacus Farma Sa

13 de Junio de 2023
Revocaciones. Apoderado: D`ANTUONO MARGHERITA. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ ZAPATA FRANCISCOJOSE;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER;RODRIGUEZ BELTRAN TERESA;NOMBELA GORDOLEONOR ELENA;GARCIA ESTEBAN VERONICA;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;VILCHEZ QUINO TATIANA ARACELLI. Datosregistrales. T 34190 , F 179, S 8, H M 615050, I/A 18 ( 6.06.23).

21 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: MAS GARCIA ENCARNACION;NIETO MAGRO CONCEPCION;MAS GARCIAENCARNACION;FERNANDEZ MILLAN JAIME. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARJA DE SOROA PALOMA. Apo.Manc.:ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER. Apo.Man.Soli: NOMBELA GORDO LEONOR ELENA;PRESEDOHUETE JAVIER. Apo.Manc.: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;GARCIA MARIN JOSE. Reelecciones. Consejero: ACEBRONFERNANDEZ ALVARO. Presidente: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Datos registrales. T 34190 , F 177, S 8, H M 615050, I/A 17(13.03.23).

11 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ LOPEZ CELIA;NOVA NOVA MIRIAM;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDOHUETE JAVIER. Datos registrales. T 34190 , F 176, S 8, H M 615050, I/A 16 ( 4.05.22).

27 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: MOSCOSO DEL PRADO JAIME. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 19潞 Y27潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 34190 , F 175, S 8, H M 615050, I/A 15 (20.09.21).

26 de Febrero de 2021
Revocaciones. Apoderado: DELGADO ALONSO ALEJANDRO. Nombramientos. Apoderado: D`ANTUONOMARGHERITA;FERNANDEZ MILLAN JAIME. Reelecciones. Consejero: DE SANTIS FRANCESCO. Datos registrales. T 34190 , F174, S 8, H M 615050, I/A 14 (19.02.21).

30 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apoderado: PRESEDO HUETE JAVIER;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;RODRIGUEZ BELTRAN TERESA.Datos registrales. T 34190 , F 174, S 8, H M 615050, I/A 13 (22.10.19).

22 de Mayo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO. Presidente: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO.Revocaciones. Apoderado: GARCIA MARIN JOSE;SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;RODRIGUEZ OREA BEATRIZ;RODRIGUEZBELTRAN TERESA;SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: PRESEDO HUETE JAVIER. Apoderado:ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER;RODRIGUEZ BELTRAN TERESA;GARCIA MARIN JOSE;NIETOMAGRO CONCEPCION;MAS GARCIA ENCARNACION;ALEMAN TAISMA JOSE;MOSCOSO DEL PRADO JAIME;AGUILERAGIMENEZ JOSE MANUEL;CAROLA ROSES SANTIAGO;DELGADO ALONSO ALEJANDRO. Presidente: ACEBRON FERNANDEZALVARO. Datos registrales. T 34190 , F 171, S 8, H M 615050, I/A 12 (14.05.19).

17 de Agosto de 2018
Revocaciones. Apoderado: DE ENTRAMBASAGUAS ARCONES OLGA MARIA;DE ENTRAMBASAGUAS ARCONES OLGA MARIA.Nombramientos. Apoderado: DE EMBRAMBASAGUAS ARCONES OLGA MARIA;RODRIGUEZ BELTRAN TERESA;SAENZESPINOSA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 34190 , F 169, S 8, H M 615050, I/A 11 ( 9.08.18).

02 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO GUELFO.Nombramientos. Consejero: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Datos registrales. T 34190 , F 169, S 8, H M 615050, I/A 10(25.01.18).

26 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apoderado: MORENO SALAVERRI MARTA. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ OREA BEATRIZ. Datosregistrales. T 34190 , F 168, S 8, H M 615050, I/A 9 (18.10.17).

14 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ CAMPILLO RAQUEL;DOMENECH CIANCAS JOSE MIGUEL;FERNANDEZ ESCRIBANOFERNANDEZ JOAQUIN IGNACIO. Datos registrales. T 34190 , F 168, S 8, H M 615050, I/A 8 ( 5.10.16).

02 de Junio de 2016
Cambio de objeto social. La fabricaci贸n, comercializaci贸n, importaci贸n, exportaci贸n, distribuci贸n y venta de toda clase de productosfarmac茅uticos y sus derivados, para farmac茅uticos, cosm茅ticos, diet茅ticos, y de perfumer铆a, a entidades legalmente autorizadas,incluyendo oficinas de farmacia. Datos registrales. T 34190 , F 168, S 8, H M 615050, I/A 7 (26.05.16).

19 de Enero de 2016
Nombramientos. SecreNoConsj: ENSE脩AT BENLLIURE JAIME LUIS. Presidente: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO.Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Datos registrales. T 34190 , F 164, S 8, H M 615050, I/A 2 ( 8.01.16).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA MARIN JOSE;DE ENTRAMBASAGUAS ARCONES OLGA MARIA. Datos registrales. T34190 , F 164, S 8, H M 615050, I/A 3 ( 8.01.16).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA MARIN JOSE;DE ENTRAMBASAGUAS ARCONES OLGA MARIA. Datos registrales. T34190 , F 165, S 8, H M 615050, I/A 4 ( 8.01.16).

Nombramientos. Apoderado: MAS GARCIA ENCARNACION;MORENO SALAVERRI MARTA. Datos registrales. T 34190 , F 166, S8, H M 615050, I/A 5 ( 8.01.16).

Nombramientos. Apoderado: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 34190 , F 166, S 8, H M 615050, I/A 6 (8.01.16).

18 de Enero de 2016
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 11.12.15. Objeto social: La fabricaci贸n, importaci贸n, exportaci贸n, de toda clase de productosfarmac茅uticos y sus derivados, parafarmac茅uticos, cosm茅ticos, diet茅ticos, y de perfumer铆a. C贸digos CNAE 1086, 2042, 2120, 4645 y4646. Domicilio: C/ SAN RAFAEL 3 - POLIGONO INDUSTRIAL DE ALCOBENDA (ALCOBENDAS). Capital suscrito: 60.000,00 Euros.Desembolsado: 60.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ITALFARMACO SA. Nombramientos.Consejero: GUELFO SCIALDONE SAVERIO;DE SANTIS FRANCESCO;SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T34190 , F 160, S 8, H M 615050, I/A 1 ( 8.01.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n