Actos BORME de Ivi Burgos Sl
10 de Agosto de 2023Revocaciones. Apoderado: ENTRECANALES GONZALEZ MARCOS. Nombramientos. Apo.Sol.: MARCOS BERNAL MARIATERESA. Datos registrales. T 779, L 570, F 166, S 8, H BU 16687, I/A 17 ( 4.08.23).
30 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: REMOHI GIMENEZ JOSE ALEJANDRO. Presidente: PELLICER MARTINEZ ANTONIO. Vicepresid.:REMOHI GIMENEZ JOSE ALEJANDRO. Consejero: BLANES GIRONES CARLOS. Nombramientos. Consejero: EQUIPO IVI SL.Presidente: EQUIPO IVI SL. Vicepresid.: PELLICER MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 779, L 570, F 165, S 8, H BU 16687,I/A 16 (24.03.23).
10 de Octubre de 2022Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 13潞 Y 17潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVOS A LAJUNTA GENERAL Y AL CONSEJO DE ADMINISTRACION.. Datos registrales. T 775, L 566, F 38, S 8, H BU 16687, I/A 15 (4.10.22).
20 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MORENO ALBI脩ANA MIGUEL. Nombramientos. SecreNoConsj: PIQUER ALTARRIBA JUAN.Datos registrales. T 775, L 566, F 38, S 8, H BU 16687, I/A 14 (14.05.21).
05 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: SAURAT MARIN LUIS. Nombramientos. Consejero: BLANES GIRONES CARLOS. Datosregistrales. T 775, L 566, F 35, S 8, H BU 16687, I/A 11 (26.03.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: SAURAT MARIN LUIS;SAURAT MARIN LUIS. Datos registrales. T 775, L 566, F 36, S 8, H BU 16687, I/A12 (26.03.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: ENTRECANALES GONZALEZ MARCOS;BLANES GIRONES CARLOS. Datos registrales. T 775, L 566,F 36, S 8, H BU 16687, I/A 13 (26.03.21).
02 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: PELLICER MARTINEZ LUIS;PELLICER MARTINEZ LUIS. Datos registrales. T 720, L 511, F 158, S 8, HBU 16687, I/A 8 (27.08.20).
Revocaciones. Apoderado: DE LA LLAVE LLACER MANUEL JOSE. Datos registrales. T 720, L 511, F 158, S 8, H BU 16687, I/A 9(27.08.20).
Nombramientos. Apoderado: ENTRECANALES GONZALEZ MARCOS. Datos registrales. T 720, L 511, F 158, S 8, H BU 16687,I/A 10 (27.08.20).
23 de Julio de 2019Modificaciones estatutarias. Inclusi贸n del art铆culo 5bis para establecer prestaciones accesorias y nueva redacci贸n del art铆culo 7潞referente al r茅gimen de transmisi贸n de las participaciones sociales.. Datos registrales. T 720, L 511, F 157, S 8, H BU 16687, I/A 7(16.07.19).
01 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: PELLICER MARTINEZ ANTONIO;REMOHI GIMENEZ JOSE ALEJANDRO. Nombramientos.Apo.Sol.: SAURAT MARIN LUIS;PELLICER MARTINEZ LUIS. Cambio de objeto social. Se modifica el objeto social en cuanto a laexplotaci贸n de cl铆nicas ginecol贸gicas. Datos registrales. T 720, L 511, F 156, S 8, H BU 16687, I/A 6 (26.07.18).
09 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: CONTELL GARCIA ANA CRISTINA. Datos registrales. T 720, L 511, F 156, S 8, H BU 16687, I/A 5 (2.02.17).
18 de Octubre de 2016Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 1.06.16. Objeto social: Titularidad y gesti贸n de cl铆nicas ginecol贸gicas y de reproducci贸nhumana asistida y sus unidades m茅dicas asistenciales, prestaci贸n de servicios relacionados con la medicina reproductiva. La sociedadtambi茅n tiene por objeto la realizaci贸n e impartici贸n de docencia y formaci贸n complementaria. Domicilio: AVDA REYES CATOLICOS39 BAJO (BURGOS). Capital: 7.002,00 Euros. Nombramientos. Consejero: PELLICER MARTINEZ ANTONIO;REMOHI GIMENEZJOSE ALEJANDRO;SAURAT MARIN LUIS. Datos registrales. T 720, L 511, F 147, S 8, H BU 16687, I/A 1 (11.10.16).
Nombramientos. SecreNoConsj: MORENO ALBI脩ANA MIGUEL. Presidente: PELLICER MARTINEZ ANTONIO. Vicepresid.:REMOHI GIMENEZ JOSE ALEJANDRO. Cons.Del.Sol: PELLICER MARTINEZ ANTONIO;REMOHI GIMENEZ JOSE ALEJANDRO.Datos registrales. T 720, L 511, F 153, S 8, H BU 16687, I/A 2 (11.10.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: SAURAT MARIN LUIS;PELLICER MARTINEZ LUIS. Datos registrales. T 720, L 511, F 153, S 8, H BU16687, I/A 3 (11.10.16).
Nombramientos. Apoderado: DE LA LLAVE LLACER MANUEL JOSE. Datos registrales. T 720, L 511, F 155, S 8, H BU 16687, I/A4 (11.10.16).