Actos BORME de Ivi Murcia Sl
29 de Agosto de 2023Revocaciones. Apoderado: MARCOS ENTRECANALES GONZALEZ;AGUSTIN BALLESTEROS BOLUDA. Nombramientos.Apo.Sol.: MARIA TERESA MARCOS BERNAL. Datos registrales. T 3518 , F 203, S 8, H MU 31676, I/A 28 (22.08.23).
03 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE ALEJANDRO REMOHI GIMENEZ. Presidente: JOSE ALEJANDRO REMOHI GIMENEZ.Nombramientos. Consejero: EQUIPO IVI SL. Presidente: EQUIPO IVI SL. Datos registrales. T 3518 , F 203, S 8, H MU 31676, I/A27 (27.03.23).
09 de Septiembre de 2022Fe de erratas: Publicada erroneamente como inscripci贸n 6陋, la practicada el 26 de agosto del corriente, siendo la numeraci贸n correctade la inscripci贸n, la 26陋. Datos registrales. T 3518 , F 202, S 8, H MU 31676, I/A 26 (26.08.22).
02 de Septiembre de 2022Otros conceptos: Modificaci贸n de los art铆culos 13陋 y 17潞 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 3518 , F 202, S 8, H MU31676, I/A 6 (26.08.22).
01 de Julio de 2021Otros conceptos: MODIFICAN EL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SE A脩ADE EL ARTICULO 5 BIS A LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3063 , F 165, S 8, H MU 31676, I/A 25 (24.06.21).
24 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Secretario: MIGUEL MORENO ALBI脩ANA. Nombramientos. Secretario: JUAN PIQUER ALTARRIBA. Datosregistrales. T 3063 , F 165, S 8, H MU 31676, I/A 24 (17.05.21).
19 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: JUAN LUIS SAURAT MARIN. Apo.Sol.: JUAN LUIS SAURAT MARIN;JUAN LUIS SAURAT MARIN.Datos registrales. T 3063 , F 164, S 8, H MU 31676, I/A 22 (12.04.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARCOS ENTRECANALES GONZALEZ;CARLOS BLANES GIRONES. Datos registrales. T 3063 , F164, S 8, H MU 31676, I/A 23 (12.04.21).
07 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apoderado: MANUEL JOSE DE LA LLAVE LLACER. Apo.Sol.: MANUEL JOSE DE LA LLAVE LLACER;MANUELJOSE DE LA LLAVE LLACER. Datos registrales. T 3063 , F 163, S 8, H MU 31676, I/A 19 (31.08.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: LUIS PELLICER MARTINEZ;LUIS PELLICER MARTINEZ. Datos registrales. T 3063 , F 163, S 8, H MU31676, I/A 20 (31.08.20).
Nombramientos. Apoderado: MARCOS ENTRECANALES GONZALEZ. Datos registrales. T 3063 , F 163, S 8, H MU 31676, I/A 21(31.08.20).
10 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: JOSE ALEJANDRO REMOHI GIMENEZ;ANTONIO PELLICER MARTINEZ. Nombramientos.Apo.Sol.: JUAN LUIS SAURAT MARIN;LUIS PELLICER MARTINEZ. Cambio de objeto social. "ARTICULO 2 .- OBJETO. - LaSociedad tiene por objeto la titularidad, explotaci贸n y gesti贸n de cl铆nicas ginecol贸gicas y de reproducci贸n humana asistida y susunidades m茅dicas asistenciales, as铆 como la prestaci贸n de los servidos m谩s amplios relacionados con la problem谩tica de la medicinareproductiv. Datos registrales. T 3063 , F 162, S 8, H MU 31676, I/A 18 ( 3.05.18).
11 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3063 , F 162, S 8, H MU 31676, I/A 17 (30.11.17).
26 de Julio de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: JOSE LORENZO LANDERAS GUTIERREZ;MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ. Datosregistrales. T 3063 , F 162, S 8, H MU 31676, I/A 16 (18.07.16).
10 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2195 , F 180, S 8, H MU 31676, I/A 15 ( 2.12.14).
28 de Febrero de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: JOSE LORENZO LANDERAS GUTIERREZ;MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ;SUSANASANCHEZ MARTIN;MANUEL JOSE DE LA LLAVE LLACER. Datos registrales. T 2195 , F 180, S 8, H MU 31676, I/A 14 (22.02.13).
16 de Enero de 2012Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2195 , F 180, S 8, H MU 31676, I/A 13 ( 4.01.12).