Actos BORME de J. Garcia Carrion Energy Sl
10 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: JOSE GARCIA CARRION JORDAN. Revocaciones. Apo.Sol.: MARIA-RAFAELA CORUJODIAZ;LUCIANO JOSE GARCIA CARRION CORUJO;DAVID LOPEZ MEDINA;IGOR ALBIOL GUTIERREZ;LUIS JAVIER PEREZCAMPO. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 3510 , F 97, S 8, H MU 66169, I/A 9( 3.02.23).
16 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: OLIVIER RENE GOMEZ PAUMAR. Datos registrales. T 3510 , F 97, S 8, H MU 66169, I/A 8 (10.12.21).
18 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: OLIVIER RENE GOMEZ PAUMAR. Datos registrales. T 2572 , F 189, S 8, H MU 66169, I/A 5(11.05.21).
Revocaciones. Apoderado: RAMON CALABIA DEL CAMPO. Datos registrales. T 2572 , F 189, S 8, H MU 66169, I/A 6 (11.05.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: JOSE RAMON ROMERO RUIZ-GIMENEZ. Nombramientos. Apo.Sol.: IGOR ALBIOL GUTIERREZ;LUISJAVIER PEREZ CAMPO. Datos registrales. T 2572 , F 189, S 8, H MU 66169, I/A 7 (11.05.21).
11 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: RAMON CALABIA DEL CAMPO. Datos registrales. T 2572 , F 188, S 8, H MU 66169, I/A 4 ( 2.12.19).
15 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apoderado: FELIX VILLAVERDE CARNEVALI. Nombramientos. Apo.Sol.: MARIA-RAFAELA CORUJODIAZ;LUCIANO JOSE GARCIA CARRION CORUJO;DAVID LOPEZ MEDINA;JOSE RAMON ROMERO RUIZ-GIMENEZ. Datosregistrales. T 2572 , F 187, S 8, H MU 66169, I/A 3 ( 8.11.19).
21 de Octubre de 2011Nombramientos. Apoderado: FELIX VILLAVERDE CARNEVALI. Datos registrales. T 2572 , F 187, S 8, H MU 66169, I/A 2(13.10.11).