Actos BORME de Jaume Oro Sl
22 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTIN GARRIGA FRANCISCO JAVIER. Consejero: MARTIN GARRIGA FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Consejero: FERRANDO CUADRADAS JORGE. Presidente: FERRANDO CUADRADAS JORGE. Datosregistrales. T 794 , F 159, S 8, H L 1394, I/A 102 (15.12.23).
30 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: PADULLES CABA JESUS. Apo.Sol.: PADULLES CABA JESUS. Datos registrales. T 794 , F 159, S 8, HL 1394, I/A 100 (20.10.23).
Revocaciones. Apoderado: MARTIN GARRIGA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 794 , F 159, S 8, H L 1394, I/A 101(20.10.23).
26 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Manc.: FERRANDO CUADRADAS JORGE. Datos registrales. T 794 , F 33, S 8, H L 1394, I/A 97 (16.06.23).
09 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE;GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE. Nombramientos. Apoderado:GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE. Datos registrales. T 792 , F 98, S 8, H L 1394, I/A 95 (24.11.22).
Revocaciones. Apoderado: COLIO ABRIL PABLO. Nombramientos. Apoderado: COLIO ABRIL PABLO. Datos registrales. T 794 ,F 30, S 8, H L 1394, I/A 96 (25.11.22).
31 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: PINO VALLADARES ANTONIO MARIA;PINO VALLADARES ANTONIO MARIA. Apo.Sol.: PINOVALLADARES ANTONIO MARIA. Datos registrales. T 792 , F 98, S 8, H L 1394, I/A 94 (16.03.22).
09 de Abril de 2021Reelecciones. Consejero: MARTIN GARRIGA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 792 , F 10, S 8, H L 1394, I/A 93(26.03.21).
08 de Octubre de 2020Revocaciones. Apoderado: MESTRICH CUEVAS MARIA DOLORES. Nombramientos. Apo.Sol.: MESTRICH CUEVAS MARIADOLORES. Apo.Manc.: MESTRICH CUEVAS MARIA DOLORES. Datos registrales. T 792 , F 9, S 8, H L 1394, I/A 92 (23.09.20).
09 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE. Datos registrales. T 792 , F 8, S 8, H L 1394, I/A 91 ( 1.07.20).
16 de Junio de 2020Reelecciones. Consejero: LOPEZ BARRANCO CRISTINA. Datos registrales. T 792 , F 7, S 8, H L 1394, I/A 90 ( 5.06.20).
03 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE. Datos registrales. T 790 , F 206, S 8, H L 1394, I/A 89(25.02.20).
30 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CREMADES RIPOLL MANUEL FRANCISCO. Vicepresid.: CREMADES RIPOLL MANUELFRANCISCO. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ MORAL FRANCISCO ANTONIO. Vicepresid.: FERNANDEZ MORALFRANCISCO ANTONIO. Datos registrales. T 790 , F 206, S 8, H L 1394, I/A 88 (20.08.19).
25 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: CREMADES RIPOLL MANUEL FRANCISCO. Datos registrales. T 790 , F 205, S 8, H L 1394, I/A 87(15.04.19).
15 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: MESTRICH CUEVAS MARIA DOLORES. Datos registrales. T 790 , F 169, S 8, H L 1394, I/A 85 (7.01.19).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MORAL FRANCISCO ANTONIO. Datos registrales. T 790 , F 202, S 8, H L 1394, I/A 86( 7.01.19).
19 de Abril de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: MUÑOZ CRESPO SANTIAGO. Apo.Manc.: MUÑOZ CRESPO SANTIAGO. Datos registrales. T 790 , F169, S 8, H L 1394, I/A 84 (11.04.18).
24 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apoderado: JARQUE URIBE CARLOS MANUEL. Otros conceptos: La modificación del objeto social se realiza enel sentido de constatar el código del CNAE correspondiente a la principal actividad de la sociedad.- Cambio de objeto social. a)Recogida de basuras, mantenimiento y limpieza de contenedores, vertederos, cloacas, desagÕes, sumideros, en vías públicas ycualquier otro servicio relacionado con la limpieza, en general y el mantenimiento de los elementos, en particular los destinados a talesfines, en el área de los servicios. Datos registrales. T 790 , F 168, S 8, H L 1394, I/A 83 (17.11.17).
25 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: COLIO ABRIL PABLO. Datos registrales. T 790 , F 165, S 8, H L 1394, I/A 82 (18.10.17).
09 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: MORENO GALVEZ JOSE MANUEL. Apo.Manc.: MORENO GALVEZ JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 790 , F 117, S 8, H L 1394, I/A 81 ( 2.06.17).
11 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: INGLES MORALES JUAN CARLOS. Datos registrales. T 790 , F 115, S 8, H L 1394, I/A 80 ( 4.04.17).
25 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: MARTIN GARRIGA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 790 , F 10, S 8, H L 1394, I/A 79(18.10.16).
20 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTIN ZAMORA PABLO. Consejero: MARTIN ZAMORA PABLO. Nombramientos. Consejero:MARTIN GARRIGA FRANCISCO JAVIER. Presidente: MARTIN GARRIGA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 788 , F 174, S8, H L 1394, I/A 78 (13.04.16).
04 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: MARTIN ZAMORA PABLO. Datos registrales. T 788 , F 174, S 8, H L 1394, I/A 77 (23.03.16).
09 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apoderado: MIGUEL ESCOT FERNANDO JORGE. Datos registrales. T 788 , F 173, S 8, H L 1394, I/A 75 (1.12.15).
Nombramientos. Apoderado: TEMPRANO PUIG MARIA ESTHER. Datos registrales. T 788 , F 173, S 8, H L 1394, I/A 76 (1.12.15).
20 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apoderado: BEJAR OCHOA JUAN. Datos registrales. T 788 , F 172, S 8, H L 1394, I/A 74 (13.11.15).
21 de Octubre de 2015Nombramientos. Apoderado: JARQUE URIBE CARLOS MANUEL. Datos registrales. T 788 , F 41, S 8, H L 1394, I/A 73 (15.10.15).
01 de Octubre de 2015Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MINGO JORGE LUIS. Apo.Manc.: GOMEZ MINGO JORGE LUIS;GOMEZ MINGO JORGELUIS. Datos registrales. T 788 , F 40, S 8, H L 1394, I/A 72 (24.09.15).
14 de Septiembre de 2015Revocaciones. Apoderado: ALVARADO ORTEGA MANUEL. Datos registrales. T 786 , F 175, S 8, H L 1394, I/A 71 ( 4.09.15).
29 de Mayo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: PINO VALLADARES ANTONIO MARIA. Apo.Manc.: PINO VALLADARES ANTONIO MARIA;PINOVALLADARES ANTONIO MARIA. Datos registrales. T 786 , F 172, S 8, H L 1394, I/A 70 (21.05.15).
30 de Marzo de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: SOMOZA SERRANO JESUS MANUEL. Datos registrales. T 786 , F 172, S 8, H L 1394, I/A 69(20.03.15).
01 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: LIEBANA ALCANTARILLA JOSE. Apo.Manc.: LIEBANA ALCANTARILLA JOSE. Datos registrales. T784 , F 130, S 8, H L 1394, I/A 68 (24.11.14).
17 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apoderado: DONOSO REBUELTA JOSE LUIS. Apo.Manc.: DONOSO REBUELTA JOSE LUIS;DONOSOREBUELTA JOSE LUIS. Datos registrales. T 782 , F 91, S 8, H L 1394, I/A 65 (10.11.14).
Nombramientos. Apoderado: TORRES BADAJOZ ANGEL MARIA. Apo.Manc.: TORRES BADAJOZ ANGEL MARIA. Datosregistrales. T 784 , F 116, S 8, H L 1394, I/A 66 (10.11.14).
Nombramientos. Apoderado: CARRASCO DELGADO JOSE MANUEL. Apo.Manc.: CARRASCO DELGADO JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 784 , F 119, S 8, H L 1394, I/A 67 (10.11.14).
31 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: FCC MEDIO AMBIENTE SA;COMPAÑIA CATALANA DE SERVICIOS SA;SERVICIOS ESPECIALESDE LIMPIEZA SA. Secretario: CORREA ARTES ESTEBAN. VsecrNoConsj: ARGEMI LLAGOSTERA JAIME. Presidente: FCC MEDIOAMBIENTE SA. Nombramientos. Consejero: MARTIN ZAMORA PABLO;CREMADES RIPOLL MANUEL FRANCISCO;LOPEZBARRANCO CRISTINA. Presidente: MARTIN ZAMORA PABLO. Vicepresid.: CREMADES RIPOLL MANUEL FRANCISCO. Secretario:LOPEZ BARRANCO CRISTINA. Datos registrales. T 780 , F 179, S 8, H L 1394, I/A 64 (24.10.14).
26 de Mayo de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: RICOTE GARBAJOSA JUAN. Datos registrales. T 780 , F 179, S 8, H L 1394, I/A 63 (15.05.14).
09 de Mayo de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: ALCAÑIZ HORTA ALBERTO. Datos registrales. T 780 , F 179, S 8, H L 1394, I/A 61 ( 2.05.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: DE LA TORRE SANCHEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 780 , F 179, S 8, H L 1394, I/A 62 ( 2.05.14).
06 de Mayo de 2014Nombramientos. Apoderado: MIGUEL ESCOT FERNANDO JORGE. Datos registrales. T 780 , F 177, S 8, H L 1394, I/A 59(24.04.14).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SALGADO OTONES DIEGO. Datos registrales. T 780 , F 178, S 8, H L 1394, I/A 60 (24.04.14).
22 de Abril de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: PUIGDOMENECH ROMERO ANNA. Apoderado: PUIGDOMENECH ROMERO ANNA. Datosregistrales. T 780 , F 177, S 8, H L 1394, I/A 57 (10.04.14).
Cambio de domicilio social. AVDA DEL BOSC S/N - POLIGON INDUSTRIAL HOSTAL NOU, (BELLPUIG). Datos registrales. T780 , F 177, S 8, H L 1394, I/A 58 (10.04.14).
18 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: MARTIN ZAMORA PABLO. Datos registrales. T 780 , F 130, S 8, H L 1394, I/A 55 (11.02.14).
03 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE. Datos registrales. T 780 , F 112, S 8, H L 1394, I/A 54(26.06.13).
02 de Abril de 2013Revocaciones. Apoderado: FALCONES JAQUOTOT BALDOMERO. Datos registrales. T 778 , F 215, S 8, H L 1394, I/A 52(21.03.13).
Nombramientos. Apoderado: BEJAR OCHOA JUAN. Datos registrales. T 778 , F 215, S 8, H L 1394, I/A 53 (21.03.13).
11 de Enero de 2013Reelecciones. Consejero: FCC MEDIO AMBIENTE SA;COMPAÑIA CATALANA DE SERVICIOS SA;SERVICIOS ESPECIALES DELIMPIEZA SA. Datos registrales. T 778 , F 100, S 8, H L 1394, I/A 51 ( 2.01.13).
30 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: ESCUDERO GILGADO ROSA MARIA. Datos registrales. T 778 , F 100, S 8, H L 1394, I/A 49(16.05.12).
Nombramientos. Apoderado: GALIANA SAURA SANDRA. Datos registrales. T 778 , F 100, S 8, H L 1394, I/A 50 (16.05.12).
09 de Febrero de 2012Revocaciones. Apoderado: CARTON MANCEÑIDO FELIPE. Datos registrales. T 778 , F 100, S 8, H L 1394, I/A 48 (23.01.12).
04 de Febrero de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: QUERO CARRILLO MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: QUERO CARRILLO MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 778 , F 97, S 8, H L 1394, I/A 47 (26.01.11).
03 de Noviembre de 2010Nombramientos. VsecrNoConsj: ARGEMI LLAGOSTERA JAIME. Datos registrales. T 778 , F 97, S 8, H L 1394, I/A 45 (21.10.10).
Ampliacion del objeto social. d) El mantenimiento y conservación de instalaciones de alumbrado público, semafóricas, fuentesornamentales, instalaciones sanitarias, deportivas y de edificios públicos o privados; e) El mantenimiento y conservacion de zonasajardinadas, arbolado, parques y jardines, tanto públicos como privados. Datos registrales. T 778 , F 97, S 8, H L 1394, I/A 46(21.10.10).