Actos BORME de Jesus Aurelio Rubio Terente Sl
04 de Septiembre de 2023Revocaciones. Adm. Unico: ASISTENCIAS CARTER SL. Nombramientos. Liquidador: BACHS LOBO JAIME. Disoluci贸n.Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 4473 , F 120, S 8, H AS 13897, I/A 25 (24.08.23).
22 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: RUBIO TERENTE JESUS AURELIO. Apo.Manc.: RUBIO TERENTE JESUS AURELIO. Datos registrales.T 4473 , F 118, S 8, H AS 13897, I/A 23 (15.11.22).
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN FRANCO SILVIA. Apo.Manc.: MARTIN FRANCO SILVIA;MARTIN FRANCO SILVIA.Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCO JUAREZ PABLO. Apo.Manc.: BLANCO JUAREZ PABLO;BACHS LOBO JAIME;LOPEZ GARCIAALICIA;LEIGH TOSE MICHAEL BERNARD;DEVLIN RORY FRANCIS. Datos registrales. T 4473 , F 118, S 8, H AS 13897, I/A 24
25 de Enero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: MARTOS PRAT RODRIGO;DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI ANDRES;DANEO CERRO JOSEJAVIER;MARTINEZ NIETO LAURA;VARELA-GRANDAL RUIBAL ANA PATRICIA;FERNANDEZ OLIVA ABEL;SANCHEZ BOLUDALUCIA;HERNANDEZ-ANTOLIN CABELLO DE LOS COBOS EUGENIA;LOPEZ GARCIA ALICIA. Apo.Manc.: LOPEZ GARCIA ALICIA.Apo.Sol.: MARTIN FRANCO SILVIA. Apo.Manc.: MARTIN FRANCO SILVIA. Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN FRANCO SILVIA.Apo.Manc.: MARTIN FRANCO SILVIA;ORTEGA CARBALLO JORGE;LOPEZ GARCIA ALICIA;LEIGH TOSE MICHAELBERNARD;DEVLIN RORY FRANCIS. Apo.Sol.: LOPEZ GARCIA ALICIA;VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES;DE LA RUA RUESCAALEJANDRO. Apo.Manc.: DE LA RUA RUESCA ALEJANDRO;ORTEGA CARBALLO JORGE;MARTIN FRANCO SILVIA;LEIGH TOSEMICHAEL BERNARD;DEVLIN RORY FRANCIS. Datos registrales. T 2421 , F 93, S 8, H AS 13897, I/A 20 (14.01.22).
Revocaciones. Apo.Sol.: RUBIO TERENTE JESUS AURELIO. Apo.Manc.: RUBIO TERENTE JESUS AURELIO. Nombramientos.Apo.Sol.: RUBIO TERENTE JESUS AURELIO. Apo.Manc.: RUBIO TERENTE JESUS AURELIO;ORTEGA CARBALLO JORGE.Datos registrales. T 4473 , F 116, S 8, H AS 13897, I/A 21 (14.01.22).
19 de Octubre de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 97.319,00 Euros. Resultante Suscrito: 451.847,78 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 2421 , F 92, S 8, H AS 13897, I/A 19 ( 7.10.21).
09 de Agosto de 2021Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. POLIGINDUSTRIAL DE RIA脩O III (LANGREO). Datos registrales. T 2421 , F 92, S 8, H AS 13897, I/A 18 ( 2.08.21).
22 de Agosto de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: GENER MARTINEZ LAIA. Apo.Manc.: GENER MARTINEZ LAIA;DUDE ALVAREZ ESTEFANIA. Apo.Sol.:GUELL BLASI ALICIA. Apo.Manc.: GUELL BLASI ALICIA. Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN FRANCO SILVIA. Apo.Manc.:MARTIN FRANCO SILVIA;ORTEGA CARBALLO JORGE;PONGRACZ VILMOS;DEVLIN RORY FRANCIS. Datos registrales. T 2421, F 91, S 8, H AS 13897, I/A 17 (13.08.19).
17 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: MARTOS PRAT RODRIGO;DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI ANDRES;DANEO CERRO JOSEJAVIER;MARTINEZ NIETO LAURA;VARELA-GRANDAL RUIBAL ANA PATRICIA;FERNANDEZ OLIVA ABEL;SANCHEZ BOLUDALUCIA;HERNANDEZ-ANTOLIN CABELLO DE LOS COBOS EUGENIA. Datos registrales. T 2421 , F 80, S 8, H AS 13897, I/A 15 (7.12.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUELL BLASI ALICIA;LOPEZ GARCIA ALICIA;GENER MARTINEZ LAIA. Apo.Manc.: GUELL BLASIALICIA;LOPEZ GARCIA ALICIA;GENER MARTINEZ LAIA;ORTEGA CARBALLO JORGE;PONGRACZ VILMOS;DEVLIN RORYFRANCIS. Datos registrales. T 2421 , F 80, S 8, H AS 13897, I/A 16 ( 7.12.18).
01 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RUBIO TERENTE JESUS AURELIO. Nombramientos. Adm. Unico: ASISTENCIAS CARTER SL.Datos registrales. T 2421 , F 78, S 8, H AS 13897, I/A 10 (24.07.18).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ASISTENCIAS CARTER SL. Datos registrales. T 2421 , F 78, S 8, H AS 13897, I/A11 (24.07.18).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ SUAREZ MARIA JULIA. Datos registrales. T 2421 , F 78, S 8, H AS 13897, I/A 12(24.07.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO TERENTE JESUS AURELIO. Apo.Manc.: RUBIO TERENTE JESUS AURELIO;GARRIGA VAZ DECONCICAO PABLO;DUDE ALVAREZ ESTEFANIA Datos registrales. T 2421 , F 78, S 8, H AS 13897, I/A 13 (24.07.18).
28 de Marzo de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 265.445,76 Euros. Resultante Suscrito: 354.528,78 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 2421 , F 77, S 8, H AS 13897, I/A 9 (16.03.18).
31 de Octubre de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.027,50 Euros. Resultante Suscrito: 89.083,02 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: 6. Capital social.-. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Cambio de objeto social. La compra y venta deaccesorios y recambios para vehiculos autom贸viles, tanto para reposicion en vehiculo objeto de reparacion en los propios talleres,como la asistencia en carretera, asi como tambien para venta a terceros. La reparaci贸n y exposici贸n de vehiculos automoviles decualquier marca, su. Datos registrales. T 2421 , F 76, S 8, H AS 13897, I/A 8 (23.10.17).
13 de Julio de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.027,50 Euros. Resultante Suscrito: 74.055,52 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 2421 , F 76, S 8, H AS 13897, I/A 7 ( 6.07.17).
18 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SUAREZ MARIA JULIA. Datos registrales. T 2421 , F 76, S 8, H AS 13897, I/A 6(10.03.16).
15 de Septiembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.989,26 Euros. Resultante Suscrito: 59.028,02 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 2421 , F 76, S 8, H AS 13897, I/A 5 ( 3.09.09).