Actos BORME de Juan De Escama Sa
23 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: ALGUACIL GARRIDO AGUSTIN MANUEL. Datos registrales. T 541 , F 181, S 8, H GR 4960, I/A 11(15.12.20).
04 de Enero de 2016Nombramientos. Apoderado: ALGUACIL PARDO AGUSTIN MANUEL. Datos registrales. T 541 , F 180, S 8, H GR 4960, I/A 9(24.12.15).
27 de Octubre de 2014Nombramientos. Consejero: ALGUACIL GARRIDO AGUSTIN MANUEL;HERRERA JIMENEZ RAFAEL;PARDO MARTINEZTRINIDAD. Con.Delegado: ALGUACIL GARRIDO AGUSTIN MANUEL. Vicepresid.: HERRERA JIMENEZ RAFAEL. Presidente:ALGUACIL GARRIDO AGUSTIN MANUEL. Secretario: PARDO MARTINEZ TRINIDAD. Datos registrales. T 541 , F 180, S 8, H GR4960, I/A 8 (21.10.14).
06 de Agosto de 2014Fe de erratas: Se rectifica el acto Caducidad miembro del 贸rgano de adm. del envio 244 del a帽o 2013, en cuanto al error padecido enla fecha de caducidad siendo la correcta la de 30/06/13, y no la de 13/12/2013 como por error se public贸. Datos registrales. T 541 , F180, S 8, H GR 4960, I/AN.Mar (13.12.13).
24 de Diciembre de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ALGUACIL GARRIDO AGUSTIN MANUEL;GARRIDO MORENO MARIAVICTORIA. Vicepresid.: ALGUACIL GARRIDO AGUSTIN MANUEL. Cons.Del.Sol: ALGUACIL GARRIDO AGUSTIN MANUEL.Presidente: GARRIDO MORENO MARIA VICTORIA. Cons.Del.Sol: GARRIDO MORENO MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 541, F 180, S 8, H GR 4960, I/AN.Mar (13.12.13).
20 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ALGUACIL GARRIDO RAQUEL. Secretario: ALGUACIL GARRIDO RAQUEL. Datos registrales. T541 , F 180, S 8, H GR 4960, I/A 7 (10.05.13).