Buscador CIF Logo

Actos BORME Juan Galindo Sociedad Limitada

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Juan Galindo Sociedad Limitada

Actos BORME Juan Galindo Sociedad Limitada - B04068722

Tenemos registrados 35 Actos BORME del Registro Mercantil de Almeria para Juan Galindo Sociedad Limitada con CIF B04068722

🔙 Perfil de Juan Galindo Sociedad Limitada
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Almeria

Actos BORME de Juan Galindo Sociedad Limitada

08 de Agosto de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1794 , F 24, S 8, H AL 1256, I/A 44(30.07.19).

23 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1794 , F 23, S 8, H AL 1256, I/A 43(11.10.18).

08 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1794 , F 23, S 8, H AL 1256, I/A 42(29.12.17).

19 de Septiembre de 2017
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.- CNAE 4321, 4329. Comprar, vender, suministrar, importar,exportar, comercializar, almacenar, fabricar, manufacturar, producir, elaborar, manejar, permutar, distribuir y, en general, disponer detodo tipo de bienes y productos en los Estados Unidos. Ampliacion del objeto social. Comprar, vender, suministrar, importar,exportar, comercializar, almacenar, fabricar, manufacturar, producir, elaborar, manejar, permutar, distribuir y, en general, disponer detodo tipo de bienes y productos en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero de conformidad con las leyes de Inversi. Datosregistrales. T 1794 , F 23, S 8, H AL 1256, I/A 41 (11.09.17).

17 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ HERNANSAIZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 1794 , F 22, S 8, H AL 1256, I/A40 ( 9.03.17).

03 de Marzo de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ HERNANSAIZ JOSE RAMON;AGUILERA VITON JOSE MARIA;CARPINTERO PEREZ

25 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MARTINA VIRGINIA ANASTASIA;CARPINTERO GRANDE MARIA. Datos registrales. T 1794 ,F 21, S 8, H AL 1256, I/A 38 (17.08.16).

22 de Julio de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CARPINTERO PEREZ FRANCISCO;DOMINGUEZ SIDERA JUAN LUIS;DE LA MADRIZ GALINDOJAVIER;SANCHEZ RUIZ ENRIQUE. Datos registrales. T 52 , F 225, S 8, H AL 1256, I/A 37 (13.07.16).

27 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARPINTERO GRANDE JAVIER. Nombramientos. Consejero: CARPINTERO PEREZFRANCISCO. Datos registrales. T 52 , F 225, S 8, H AL 1256, I/A 36 (19.08.15).

28 de Mayo de 2015
Revocaciones. Apoderado: MIQUEL VALERO JULIO MARIA. Datos registrales. T 52 , F 225, S 8, H AL 1256, I/A 35 (20.05.15).

11 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Auditor: AMB AUDITORES DE ALMERIA SLP. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 52 , F 225, S 8, H AL 1256, I/A 34 ( 4.03.15).

04 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX. Apo.Manc.: HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX. Datosregistrales. T 52 , F 224, S 8, H AL 1256, I/A 32 (17.02.14).

Nombramientos. Apo.Manc.: CARPINTERO GRANDE MARIA;CARPINTERO LOPEZ EMILIO;CARPINTERO PEREZ FRANCISCO.Datos registrales. T 52 , F 225, S 8, H AL 1256, I/A 33 (17.02.14).

03 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: CARPINTERO GRANDE SARA. Datos registrales. T 52 , F 223, S 8, H AL 1256, I/A 31 (26.08.13).

30 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: DE LA TORRE DIAZ GONZALO. Datos registrales. T 52 , F 223, S 8, H AL 1256, I/A 30 (23.05.13).

12 de Abril de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: CARPINTERO GRANDE MARIA;CARPINTERO LOPEZ EMILIO;HERNANDEZ GONZALEZ JUANFELIX. Datos registrales. T 52 , F 222, S 8, H AL 1256, I/A 27 ( 3.04.13).

Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX;AGUILERA VITON JOSE MARIA;FERNANDEZ HERNANSAIZJOSE RAMON;CARPINTERO PEREZ FRANCISCO. Datos registrales. T 52 , F 222, S 8, H AL 1256, I/A 28 ( 3.04.13).

Revocaciones. Apo.Sol.: GALINDO MARTINEZ JUAN;MIQUEL VALERO JULIO MARIA;AGUILERA VITON JOSEMARIA;FERNANDEZ HERNANSAIZ JOSE RAMON. Apo.Manc.: GALINDO MARTINEZ JUAN;CARPINTERO LOPEZEMILIO;CARPINTERO GRANDE MARIA. Apoderado: HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX. Apo.Manc.: HERNANDEZ GONZALEZJUAN FELIX. Datos registrales. T 52 , F 223, S 8, H AL 1256, I/A 29 ( 3.04.13).

23 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Presidente: CARPINTERO GRANDE JAVIER. Con.Delegado: CARPINTERO GRANDE JAVIER.Nombramientos. Consejero: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO. Presidente: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO.Con.Delegado: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 52 , F 221, S 8, H AL 1256, I/A 25 (10.10.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTOS GARCIA JORGE. Nombramientos. Consejero: ARCE ALONSO RAUL. Datosregistrales. T 52 , F 221, S 8, H AL 1256, I/A 26 (10.10.12).

12 de Junio de 2012
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Objeto.- La sociedad tiene como objeto la realización de todo tipo deinstalaciones y montajes, eléctricos, alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos, telecomunicaciones, instalaciones radio -eléctricas, de megafonía y sonido, contra incendio, para riego. Cambio de objeto social. La sociedad tiene como objeto la realizaciónde todo tipo de instalacionesy montajes, eléctricos, alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos, telecomunicaciones,instalaciones radio - eléctricas, de megafonía y sonido, contra incendio, para riego, fontanería, aire acondicionado, seguridad,. Datosregistrales. T 52 , F 221, S 8, H AL 1256, I/A 24 ( 1.06.12).

10 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: HERNANDEZ FERNANDEZ ABELARDO. Nombramientos. SecreNoConsj: DOMINGUEZSIDERA JUAN LUIS. Datos registrales. T 52 , F 221, S 8, H AL 1256, I/A 23 (26.07.11).

29 de Marzo de 2011
Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ SIDERA JUAN LUIS. Datos registrales. T 52 , F 220, S 8, H AL 1256, I/A 22 (15.03.11).

01 de Diciembre de 2010
Otros conceptos: La sociedad "AMB&HUSSON, S.LP" ha cambiado su denominacion por la de "AMB AUDITORES DE ALMERIA,S.LP". Datos registrales. T 52 , F 102, S 8, H AL 1256, I/A 6n (18.11.10).

19 de Julio de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: ORTIZ GONZALEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 52 , F 219, S 8, H AL 1256, I/A 19 ( 2.07.10).

Nombramientos. Apo.Manc.: CARPINTERO LOPEZ EMILIO;CARPINTERO GRANDE MARIA;HERNANDEZ GONZALEZ JUANFELIX. Datos registrales. T 52 , F 220, S 8, H AL 1256, I/A 20 ( 2.07.10).

Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX. Datos registrales. T 52 , F 220, S 8, H AL 1256, I/A 21 (8.07.10).

27 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MIQUEL VALERO JULIO MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj: HERNANDEZ FERNANDEZABELARDO. Datos registrales. T 52 , F 219, S 8, H AL 1256, I/A 18 (14.05.10).

17 de Mayo de 2010
Nombramientos. Apoderado: MIQUEL VALERO JULIO MARIA. Datos registrales. T 52 , F 216, S 8, H AL 1256, I/A 17 ( 5.05.10).

18 de Febrero de 2010
Nombramientos. Apoderado: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 52 , F 104, S 8, H AL 1256, I/A 15 (1.02.10).

Nombramientos. Apo.Manc.: ORTIZ GONZALEZ JOSE IGNACIO;GALINDO MARTINEZ JUAN. Datos registrales. T 52 , F 104, S 8,H AL 1256, I/A 16 ( 1.02.10).

30 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: CARPINTERO LOPEZ ROBERTO. Datos registrales. T 52 , F 102, S 8, H AL 1256, I/A 12 (15.12.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: GALINDO MARTINEZ JUAN;MIQUEL VALERO JULIO MARIA;AGUILERA VITON JOSEMARIA;FERNANDEZ HERNANSAIZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 52 , F 104, S 8, H AL 1256, I/A 13 (15.12.09).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA. Datos registrales.T 52 , F 104, S 8, H AL 1256, I/A 14 (15.12.09).

23 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GALINDO MARTINEZ JUAN. Nombramientos. Consejero: CARPINTERO GRANDEJAVIER;FERNANDEZ HERNANSAIZ JOSE RAMON. SecreNoConsj: MIGUEL VALERO JULIO MARIA. Consejero: CARPINTEROLOPEZ EMILIO;SANTOS GARCIA JORGE. Presidente: CARPINTERO GRANDE JAVIER. Con.Delegado: CARPINTERO GRANDEJAVIER. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración.Datos registrales. T 52 , F 102, S 8, H AL 1256, I/A 11 ( 9.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información