Buscador CIF Logo

Actos BORME Jumasa Parts Sociedad Limitada

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Jumasa Parts Sociedad Limitada

Actos BORME Jumasa Parts Sociedad Limitada - B95177309

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Vizcaya para Jumasa Parts Sociedad Limitada con CIF B95177309

🔙 Perfil de Jumasa Parts Sociedad Limitada
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Vizcaya

Actos BORME de Jumasa Parts Sociedad Limitada

12 de Septiembre de 2023
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: ADAKAR CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 6117 , F 90, S 8, H BI 32416, I/A 41 (23.08.23).

18 de Abril de 2023
Cambio de domicilio social. POLIG BOROA INDUSTRIAL - SECTOR UI-13, PARCELA 2B (AMOREBIETA-ETXANO). Datosregistrales. T 6117 , F 90, S 8, H BI 32416, I/A 40 (11.04.23).

19 de Agosto de 2022
Ceses/Dimisiones. Secretario: JIMENEZ DE ABERASTURI PIQUIN ANDER. Revocaciones. Apo.D.Gral.: AUSINMALLAVIBARRENA AITOR. Apoderado: JIMENEZ DE ABERASTURI PIQUIN ANDER. Nombramientos. SecreNoConsj: SANCHEZGUTIERREZ ALEJANDRO. Apoderado: SANCHEZ GUTIERREZ ALEJANDRO;GOMEZ BUCHO OSCAR;GOYA ZARANDONAIÑAKI;BALSATEGUI LASTRA UNAI. Datos registrales. T 4109 , F 178, S 8, H BI 32416, I/A 39 (11.08.22).

25 de Marzo de 2021
Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 4109 , F 178, S 8, HBI 32416, I/A 38 (12.03.21).

01 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MENDOZA ALDAMA LEIRE. Nombramientos. Secretario: JIMENEZ DE ABERASTURI PIQUINANDER. Datos registrales. T 4109 , F 178, S 8, H BI 32416, I/A 37 (24.07.18).

16 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GOYA ZARANDONA IÑAKI. Consejero: ESTEFANIA ANGULO GONZALO. Presidente: ESTEFANIAANGULO GONZALO. Consejero: AYASTUY GARCIA JON. Nombramientos. Presidente: GOYA ZARANDONA IÑAKI. Datosregistrales. T 4109 , F 176, S 8, H BI 32416, I/A 35 ( 8.11.17).

Revocaciones. Apoderado: ESTEFANIA ANGULO GONZALO;GOYA ZARANDONA IÑAKI. Nombramientos. Apoderado: JIMENEZDE ABERASTURI PIQUIN ANDER;BALSATEGUI LASTRA UNAI. Apo.D.Gral.: AUSIN MALLAVIBARRENA AITOR. Datosregistrales. T 4109 , F 176, S 8, H BI 32416, I/A 36 ( 8.11.17).

22 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Auditor: CONTAX ASESORES Y AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Auditor: PKF ATTESTSERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 4109 , F 176, S 8, H BI 32416, I/A 34 (12.12.16).

13 de Octubre de 2016
Revocaciones. Apoderado: SIMON ZAPATERO ANDRES;MARTINEZ SALES FRANCISCO. Datos registrales. T 4109 , F 176, S 8,H BI 32416, I/A 33 ( 3.10.16).

05 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apoderado: TORRES CASARES ANTONIO. Datos registrales. T 4109 , F 62, S 8, H BI 32416, I/A 32 (23.09.16).

15 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: MENENDEZ MARCOS JUAN CARLOS. Vicepresid.: MENENDEZ MARCOS JUAN CARLOS.Nombramientos. Consejero: GOYA ZARANDONA IÑAKI;BALSATEGUI LASTRA UNAI;AYASTUY GARCIA JON. Vicepresid.: GOYAZARANDONA IÑAKI. Datos registrales. T 4109 , F 60, S 8, H BI 32416, I/A 30 ( 6.06.16).

Revocaciones. Apoderado: ESTEFANIA ANGULO GONZALO;ESTEFANIA ANGULO GONZALO;MENENDEZ MARCOS JUANCARLOS;ESTEFANIA ANGULO GONZALO;MENENDEZ MARCOS JUAN CARLOS. Nombramientos. Apoderado: ESTEFANIAANGULO GONZALO;GOYA ZARANDONA IÑAKI. Datos registrales. T 4109 , F 61, S 8, H BI 32416, I/A 31 ( 6.06.16).

17 de Abril de 2015
Nombramientos. Apoderado: MENENDEZ MARCOS JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4109 , F 59, S 8, H BI 32416, I/A 29 (8.04.15).

09 de Abril de 2015
Nombramientos. Apoderado: ESTEFANIA ANGULO GONZALO. Datos registrales. T 4109 , F 58, S 8, H BI 32416, I/A 28(24.03.15).

02 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Auditor: CONTAX ASESORES Y AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4109 , F 58, S 8, H BI32416, I/A 27 (20.11.14).

11 de Junio de 2014
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MAME INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T4109 , F 58, S 8, H BI 32416, I/A 26 ( 3.06.14).

18 de Enero de 2013
Nombramientos. Vicepresid.: MENENDEZ MARCOS JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4109 , F 49, S 8, H BI 32416, I/A 24 (7.01.13).

Nombramientos. Apoderado: MENENDEZ MARCOS JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4109 , F 57, S 8, H BI 32416, I/A 25 (7.01.13).

30 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: ESTEFANIA ANGULO GONZALO. Datos registrales. T 4109 , F 48, S 8, H BI 32416, I/A 23(20.11.12).

31 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MENENDEZ SETIEN JUAN. Nombramientos. Consejero: ESTEFANIA ANGULO GONZALO.Presidente: ESTEFANIA ANGULO GONZALO. Consejero: MAESO PASCUAL LUIS;MENENDEZ MARCOS JUAN CARLOS.SecreNoConsj: MENDOZA ALDAMA LEIRE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradorúnico a Consejo de administración. Datos registrales. T 4109 , F 48, S 8, H BI 32416, I/A 22 ( 2.08.12).

16 de Febrero de 2012
Reelecciones. Auditor: ATELA BILBAO MANUEL. Aud.Supl.: SANZ BUERBA IÑIGO. Datos registrales. T 4109 , F 48, S 8, H BI32416, I/A 21 ( 2.02.12).

19 de Octubre de 2009
Revocaciones. Apoderado: GIRALDEZ TERUELO ESTHER. Datos registrales. T 4109 , F 48, S 8, H BI 32416, I/A 20 ( 6.10.09).

20 de Marzo de 2009
Reelecciones. Auditor: ATELA BILBAO MANUEL. Aud.Supl.: SANZ BUERBA IÑIGO. Datos registrales. T 4109 , F 47, S 8, H BI32416, I/A 19 ( 9.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información