Actos BORME de Juste Sociedad Anonima Quimico Farmaceutica
13 de Noviembre de 2023Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 14 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 44899 , F 81, S 8, H M79654, I/A 184 ( 3.11.23).
06 de Noviembre de 2023Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 44899 , F81, S 8, H M 79654, I/A 183 (27.10.23).
12 de Junio de 2023Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 413.851,60 Euros. Datos registrales. T 44899 , F 81, S 8, H M 79654, I/A 182( 5.06.23).
29 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 25571 , F40, S 8, H M 79654, I/A 181 (22.11.22).
20 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 25571 , F39, S 8, H M 79654, I/A 179 (13.01.22).
18 de Marzo de 2021Nombramientos. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES MAD SLP. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 161陋 lapublicacion del nombramiento como auditor de cuentas consolidadas de AUREN AUDITORES MAD SLP. Datos registrales. T 25571, F 26, S 8, H M 79654, I/A 161 (26.01.15).
Nombramientos. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 168陋 la publicaci贸ndel nombramiento de auditor de cuentas consolidadas de AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 25571 , F 32, S 8, H M79654, I/A 168 ( 7.08.17).
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Otros conceptos:SUBSANACION DE LAS INSCRIPCIONES 161 Y 168 EN CUANTO AL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR PARA LOS EJERCICIOSCONSOLIDADOS 2014 A 2016 Y DEL 2017 AL 2019. Datos registrales. T 25571 , F 38, S 8, H M 79654, I/A 178 (11.03.21).
29 de Octubre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: JUSTE BELLOSILLO INES;JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS;JUSTE BELLOSILLO LUISGONZAGA. Apo.Sol.: FLORES DELGADO ALVARO. Apoderado: FORCEN DEL NUEVO ELENA. Apo.Sol.: JUSTE BELLOSILLOFRANCISCO DE ASIS. Datos registrales. T 25571 , F 35, S 8, H M 79654, I/A 175 (22.10.20).
Nombramientos. Apoderado: JUSTE BELLOSILLO INES;BELLOSILLO AMUNATEGUI BELEN. Datos registrales. T 25571 , F 36, S8, H M 79654, I/A 176 (22.10.20).
Nombramientos. Apoderado: FLORES DELGADO ALVARO. Datos registrales. T 25571 , F 38, S 8, H M 79654, I/A 177 (22.10.20).
28 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ROQUE ESCUDE MAGDA. Consejero: JUSTE BELLOSILLO LUIS GONZAGA. Vicesecret.:JUSTE BELLOSILLO LUIS GONZAGA. Consejero: JUSTE BELLOSILLO INES;JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS.Vicepresid.: JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS. Presidente: JUSTE BELLOSILLO INES. Consejero: BELLOSILLOAMUNATEGUI BELEN. Nombramientos. Representan: ROQUE ESCUDE MAGDA. Consejero: JUSTE BELLOSILLO INES;JUSTEBELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS;JUSTE BELLOSILLO LUIS GONZAGA;BELLOSILLO AMUNATEGUI BELEN;ARMANDOGIANPAOLO;ROQUE ADVOCATS SLP. Presidente: JUSTE BELLOSILLO INES. Secretario: ROQUE ADVOCATS SLP.Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL REGIMEN DE RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES Y, ENCONSECUENCIA, SE MODIFICA EL ARTICULO 15潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 25571 , F 34, S 8, H M79654, I/A 174 (21.02.20).
24 de Diciembre de 2019Nombramientos. Consejero: BELLOSILLO AMUNATEGUI BELEN. Datos registrales. T 25571 , F 34, S 8, H M 79654, I/A 173(17.12.19).
29 de Julio de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: HARTO SANCHEZ MARCOS. Datos registrales. T 25571 , F 34, S 8, H M 79654, I/A 172 (22.07.19).
08 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS. Datos registrales. T 25571 , F 33, S 8, H M 79654, I/A 171(31.10.18).
09 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: BELLOSILLO AMUNATEGUI BELEN. Datos registrales. T 25571 , F 33, S 8, H M 79654, I/A 169 (1.02.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA LAHIGUERA CAMBRA FERNANDO. Datos registrales. T 25571 , F 33, S 8, H M 79654, I/A170 ( 1.02.18).
14 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 25571 , F 32, S 8, H M 79654, I/A 168 ( 7.08.17).
10 de Marzo de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ CIFUENTES ELISA. Nombramientos. Apoderado: FORCEN DEL NUEVO ELENA.Datos registrales. T 25571 , F 31, S 8, H M 79654, I/A 167 ( 3.03.17).
31 de Enero de 2017Otros conceptos: Se declara que el auditor nombrado ha sido sustituido por "AUREN AUDITORES SP, SLP" como consecuencia dela escritura de fusi贸n y segregaci贸n que caus贸 la inscripci贸n 1陋 de la hoja 624.626. Datos registrales. T 25571 , F 26, S 8, H M79654, I/A 161M (16.01.17).
06 de Octubre de 2016Reelecciones. Consejero: JUSTE BELLOSILLO INES;JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS. Vicepresid.: JUSTEBELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS. Presidente: JUSTE BELLOSILLO INES. Datos registrales. T 25571 , F 31, S 8, H M 79654, I/A166 (28.09.16).
24 de Febrero de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ HERRADA FERNANDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: HARTO SANCHEZ MARCOS.Datos registrales. T 25571 , F 27, S 8, H M 79654, I/A 164 (12.02.16).
03 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: SORIANO AROSA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 25571 , F 27, S 8, H M 79654, I/A 163(23.07.15).
02 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: JUSTE BELLOSILLO INES. Datos registrales. T 25571 , F 26, S 8, H M 79654, I/A 162(25.05.15).
04 de Febrero de 2015Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SL. Datos registrales. T 25571 , F 26, S 8, H M 79654, I/A 161 (26.01.15).
27 de Enero de 2015Nombramientos. Consejero: JUSTE BELLOSILLO LUIS GONZAGA. Datos registrales. T 25571 , F 22, S 8, H M 79654, I/A 158(19.01.15).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JUSTE BELLOSILLO INES;JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS;GONZAGA JUSTEBELLOSILLO LUIS;GARCIA LAHIGUERA CAMBRA FERNANDO;VIDAL MANGLANO LUIS. Apoderado: JUSTE BELLOSILLOINES;JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS;GONZAGA JUSTE BELLOSILLO LUIS;GARCIA LAHIGUERA CAMBRAFERNANDO;FERNANDEZ CIFUENTES ELISA. Datos registrales. T 25571 , F 23, S 8, H M 79654, I/A 159 (19.01.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JUSTE BELLOSILLO INES;JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS;JUSTE BELLOSILLO LUISGONZAGA;GARCIA LAHIGUERA CAMBRA FERNANDO;GONZALEZ HERRADA FERNANDO;FERNANDEZ CIFUENTES ELISA.Apo.Sol.: FLORES DELGADO ALVARO. Datos registrales. T 25571 , F 23, S 8, H M 79654, I/A 160 (19.01.15).
26 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 25571 , F 22, S 8, H M 79654, I/A 157 (18.09.14).
30 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 25571 , F 22, S 8, H M 79654, I/A 156 (22.07.14).
11 de Marzo de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: FRIAS GUTIERREZ RICARDO ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CIFUENTESELISA. Otros conceptos: Se modifican los apartados B.6 y B.3 de las facultades conferidas en virtud de la escritura que motiv贸 lainscripci贸n 149&. Datos registrales. T 25571 , F 21, S 8, H M 79654, I/A 155 ( 3.03.14).
27 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALZUGARAY BEITIA ANA. Otros conceptos: SE SUBSANA LA ESCRITURA OBJETO DE LAINSCRIPCION 149, EN CUANTO A LA FACULTAD 5 DEL APARTADO B.4. Datos registrales. T 25571 , F 21, S 8, H M 79654, I/A154 (18.12.13).
24 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SILES MARTIN LUIS. Nombramientos. VsecrNoConsj: JUSTE BELLOSILLO LUIS GONZAGA.Datos registrales. T 25571 , F 21, S 8, H M 79654, I/A 153 (16.12.13).
22 de Octubre de 2013Cambio de domicilio social. AVDA DE SAN PABLO 27 (COSLADA). Datos registrales. T 25571 , F 21, S 8, H M 79654, I/A 152(15.10.13).
31 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: JUSTE BELLOSILLO INES;JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS;GONZAGA JUSTEBELLOSILLO LUIS;GARCIA LAHIGUERA CAMBRA FERNANDO. Otros conceptos: Quedan ampliados los poderes conferidos a losApoderados del Grupo A en escritura que caus贸 la inscripci贸n 149& de la Hoja Social, subsanado por la 150&.- Datos registrales. T25571 , F 20, S 8, H M 79654, I/A 151 (23.05.13).
17 de Mayo de 2013Otros conceptos: SUBSANACION DE LA FACULTAD SE脩ALADA BAJO EL NUMERO 11 DEL APARTADO B.2 DEL ACUERDOSEGUNDO DE OTORGAMIENTO DE PODERES DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIONELDIA 14 DE DICIEMBRE DE 2012 EN VIRTUD DE ESCRITURA QUE CAUSOLA INSCRIPCION 149& DE LA HOJA SOCIAL. Datosregistrales. T 25571 , F 20, S 8, H M 79654, I/A 150 ( 9.05.13).
29 de Enero de 2013Revocaciones. Apoderado: JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS;DURANTEZ GARCIA MANUEL;JUSTE SESEROSARIO;PEREZ BORDO RAMON;JUSTE BELLOSILLO INES;GONZAGA JUSTE BELLOSILLO LUIS;JUSTE BELLOSILLOFRANCISCO DE ASIS. Apo.Sol.: JUSTE BELLOSILLO INES;JUSTE BELLOSILLO LUIS;JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO.Apo.Man.Soli: JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO;GONZAGA JUSTE BELLOSILLO LUIS. Apoderado: VIDAL MANGLANO LUIS.
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JUSTE BELLOSILLO INES;JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS;GONZAGA JUSTEBELLOSILLO LUIS;GARCIA LAHIGUERA CAMBRA FERNANDO;ALZUGARAY BEITIA ANA;FRIAS GUTIERREZ RICARDOANTONIO;VIDAL MANGLANO LUIS. Datos registrales. T 25571 , F 15, S 8, H M 79654, I/A 149 (21.01.13).
14 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 25571 , F 13, S 8, H M 79654, I/A 147 ( 4.12.12).
31 de Octubre de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: HIDALGO ORTEGA JAVIER. Datos registrales. T 25571 , F 13, S 8, H M 79654, I/A 146 (19.10.12).
12 de Abril de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: JUSTE SESE RAFAEL. Presidente: JUSTE SESE RAFAEL. Con.Delegado: JUSTE SESE RAFAEL.Nombramientos. Presidente: JUSTE BELLOSILLO INES. Datos registrales. T 25571 , F 13, S 8, H M 79654, I/A 145 (29.03.12).
04 de Abril de 2012Nombramientos. Consejero: BELLOSILLO AMUNATEGUI BELEN. Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 15, 21Y 24 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Datos registrales. T 25571 , F 11, S 8, H M 79654, I/A 144 (26.03.12).
01 de Febrero de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 25571 , F 11, S 8, H M 79654, I/A 143 (20.01.12).
05 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BA脩ON BERNAD ANTONIO LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: ROQUE ESCUDEMAGDA. Vicepresid.: JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS. Datos registrales. T 25571 , F 11, S 8, H M 79654, I/A 142(24.03.11).
24 de Noviembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.012.011,88 Euros. Resultante Suscrito: 7.743.211,88 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:551.802,14 Euros. Resultante Suscrito: 8.295.014,02 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 5潞.Capital Social. Datos registrales. T 25571 , F 9, S 8, H M 79654, I/A 141 (12.11.10).
23 de Noviembre de 2010Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25571 , F 9, S 8, H M 79654, I/A 139 (11.11.10).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 25571 , F 9, S 8, H M 79654, I/A 140 (11.11.10).
05 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: JUSTE SESE ROSARIO. Vicesecret.: JUSTE SESE ROSARIO. Consejero: JUSTE SESEROSARIO;JUSTE BELLOSILLO LUIS. Secretario: JUSTE BELLOSILLO LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: BA脩ON BERNADANTONIO LUIS. Consejero: SORIANO AROSA FRANCISCO JAVIER;MARTIN GARCIA ANTONIO. VsecrNoConsj: SILES MARTINLUIS. Reelecciones. Consejero: JUSTE SESE RAFAEL;JUSTE BELLOSILLO INES. Presidente: JUSTE SESE RAFAEL.Con.Delegado: JUSTE SESE RAFAEL. Consejero: JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS. Con.Delegado: JUSTE BELLOSILLOINES. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 15, 19 Y 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 25571 , F 8, S 8, H M 79654, I/A 138 (26.07.10).
19 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTA脩E ORTEGA JOSE MARIA. Datos registrales. T 25571 , F 7, S 8, H M 79654, I/A 137 (9.02.10).
02 de Febrero de 2010Revocaciones. Apoderado: MATEO MARTINEZ MAXIMO. Datos registrales. T 25571 , F 7, S 8, H M 79654, I/A 135 (19.01.10).
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 28潞. Cierre del Ejercicio.. Datos registrales. T 25571 , F 7, S 8, H M79654, I/A 136 (21.01.10).
28 de Enero de 2010Nombramientos. Apoderado: GOMEZ OVALLES ANGEL. Datos registrales. T 25571 , F 7, S 8, H M 79654, I/A 134 (15.01.10).
21 de Agosto de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO;GONZAGA JUSTE BELLOSILLO LUIS;HIDALGO ORTEGAJAVIER. Datos registrales. T 25571 , F 4, S 8, H M 79654, I/A 131 (11.08.09).
Nombramientos. Apoderado: VIDAL MANGLANO LUIS. Datos registrales. T 25571 , F 6, S 8, H M 79654, I/A 132 (11.08.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ HERRADA FERNANDO JOSE;DURANTEZ GARCIA MANUEL. Datos registrales. T25571 , F 6, S 8, H M 79654, I/A 133 (11.08.09).
13 de Agosto de 2009Modificaciones estatutarias. 19. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 25571 , F 4, S 8, H M 79654, I/A 130(31.07.09).
03 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: JUSTE BELLOSILLO INES. Vicesecret.: JUSTE BELLOSILLO LUIS. Secretario: JUSTEBELLOSILLO FRANCISCO DE ASIS. Nombramientos. Secretario: JUSTE BELLOSILLO LUIS. Con.Delegado: JUSTE BELLOSILLOINES. Datos registrales. T 25571 , F 4, S 8, H M 79654, I/A 129 (22.07.09).
22 de Julio de 2009Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/5. Datos registrales. T 25571 , F 4, S 8, H M 79654, I/A 128 (9.07.09).
20 de Julio de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: JUSTE BELLOSILLO INES;JUSTE BELLOSILLO LUIS;JUSTE BELLOSILLO FRANCISCO. Datosregistrales. T 25571 , F 3, S 8, H M 79654, I/A 126 ( 8.07.09).
Revocaciones. Apoderado: NAVARRO ALVAREZ JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 25571 , F 3, S 8, H M 79654, I/A 127 (8.07.09).