Actos BORME de Jwt Delvico Sl
24 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN;DE LA NUEZ MAGARZO JUAN MANUEL;PIERAMARTORELL JOSE MARIA. Presidente: DE LA NUEZ MAGARZO JUAN MANUEL. SecreNoConsj: BARRIL FOLGUERA JORDI.Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO;BOSCH MINGUET FRANCISCO JAVIER;ATIENZA JIMENEZ JARA-ALEJANDRA. Apo.Manc.: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN. Apo.Sol.: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN.Apo.Manc.: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON. Apo.Sol.: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON. Apo.Manc.: DE LA NUEZ MAGARZOJUAN MANUEL. Apo.Sol.: DE LA NUEZ MAGARZO JUAN MANUEL. Apo.Manc.: BARRIL FOLGUERA JORDI. Apo.Sol.: BARRILFOLGUERA JORDI. Apo.Manc.: PIERA MARTORELL JOSE MARIA. Apo.Sol.: PIERA MARTORELL JOSE MARIA. Apo.Manc.:SANCHEZ PALENCIA IRENE. Apo.Sol.: SANCHEZ PALENCIA IRENE. Apo.Manc.: PELAEZ GOMEZ ESTHER. Apo.Sol.: PELAEZGOMEZ ESTHER. Apo.Manc.: ROMO BALSEIRO MAR. Apo.Sol.: ROMO BALSEIRO MAR. Apo.Manc.: TOME GARCIA RAMON.Apo.Sol.: TOME GARCIA RAMON. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 26688 , F 182, S 8, H M 45047, I/A 138(17.02.20).
16 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BARDULLAS FLORES JOSE LUIS;HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN.Nombramientos. Consejero: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN;DE LA NUEZ MAGARZO JUAN MANUEL;PIERAMARTORELL JOSE MARIA. Presidente: DE LA NUEZ MAGARZO JUAN MANUEL. SecreNoConsj: BARRIL FOLGUERA JORDI.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 26688 , F 179, S 8, H M 45047, I/A 136 ( 9.01.19).
Revocaciones. Apoderado: HERAS MARTINEZ ANGEL ALBERTO;TOME GARCIA RAMON. Apo.Man.Soli: CISNEROS CANALSMANUELA. Apoderado: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON;HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN. Apo.Man.Soli: SANCHEZPALENCIA IRENE;BARDULLAS FLORES JOSE LUIS. Apo.Sol.: CISNEROS CANALS MANUELA;TOME GARCIA RAMON.Nombramientos. Apo.Manc.: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN. Apo.Sol.: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN.Apo.Manc.: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON. Apo.Sol.: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON. Apo.Manc.: DE LA NUEZ MAGARZOJUAN MANUEL. Apo.Sol.: DE LA NUEZ MAGARZO JUAN MANUEL. Apo.Manc.: BARRIL FOLGUERA JORDI. Apo.Sol.: BARRILFOLGUERA JORDI. Apo.Manc.: PIERA MARTORELL JOSE MARIA. Apo.Sol.: PIERA MARTORELL JOSE MARIA. Apo.Manc.:SANCHEZ PALENCIA IRENE. Apo.Sol.: SANCHEZ PALENCIA IRENE. Apo.Manc.: PELAEZ GOMEZ ESTHER. Apo.Sol.: PELAEZGOMEZ ESTHER. Apo.Manc.: ROMO BALSEIRO MAR. Apo.Sol.: ROMO BALSEIRO MAR. Apo.Manc.: TOME GARCIA RAMON.Apo.Sol.: TOME GARCIA RAMON. Datos registrales. T 26688 , F 180, S 8, H M 45047, I/A 137 ( 9.01.19).
10 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 179, S 8, H M 45047, I/A 135 ( 3.10.18).
28 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 179, S 8, H M 45047, I/A 134 (19.12.17).
26 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO. Consejero: PALOMAR GIMENO JORDI. Presidente: PALOMARGIMENO JORDI. Consejero: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN;MARTINEZ MORENO ALEJANDRO;BIRD SPENSLEYSALLY SHARON. Nombramientos. Adm. Mancom.: BARDULLAS FLORES JOSE LUIS;HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datosregistrales. T 26688 , F 178, S 8, H M 45047, I/A 132 (18.12.17).
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ MORENO ALEJANDRO;CERIA UGO. Apo.Sol.: EZPONDA DELGADO MARIAISABEL;SERRANO LOPEZ DE LAS HAZAS JOSE CARLOS;ALVAREZ CIENFUEGOS JAVIER. Datos registrales. T 26688 , F 178,S 8, H M 45047, I/A 133 (18.12.17).
08 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: CISNEROS CANALS MANUELA;TOME GARCIA RAMON. Datos registrales. T 26688 , F 178, S 8, H M45047, I/A 131 (25.04.17).
06 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: PALOMAR GIMENO JORDI;BELINCHON GUIJARRO JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Sol.:MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO;ALVAREZ CIENFUEGOS JAVIER;BOSCH MINGUET FRANCISCO JAVIER;ATIENZA JIMENEZJARA-ALEJANDRA. Apo.Man.Soli: BARDULLAS FLORES JOSE LUIS. Datos registrales. T 26688 , F 175, S 8, H M 45047, I/A 130(30.05.16).
28 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: CASERO YNFIESTA ARACELI. Nombramientos. Apo.Sol.: EZPONDA DELGADO MARIA
09 de Marzo de 2015Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 130 (MADRID). Datos registrales. T 26688 , F 174, S 8, H M 45047, I/A
25 de Noviembre de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 174, S 8, H M 45047, I/A 127 (18.11.14).
06 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: RIQUELME ORTIZ MARIA JOSE. Revocaciones. Apoderado: FUENTES MARTIN CARLOSMANUEL;IBA脩EZ SANCHEZ IGNACIO;ROCAMORA GUTIERREZ JUAN;VERGARA SEGURA MIGUEL ANGEL;LLINAS GRAURAFAEL;BERTRAN RASPALL MARIA JESUS;FUENTES MARTIN CARLOS MANUEL;LLINAS GRAU RAFAEL;SEYMOUR PETERA;FUENTES MARTIN CARLOS MANUEL;RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN;CIUDAD IGLESIAS JIMENA.Nombramientos. VsecrNoConsj: CASERO YNFIESTA ARACELI. Datos registrales. T 26688 , F 174, S 8, H M 45047, I/A 126(30.10.14).
30 de Octubre de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 173, S 8, H M 45047, I/A 125 (21.10.14).
06 de Marzo de 2014Revocaciones. Apoderado: CHAMORRO MU脩OZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 26688 , F 173, S 8, H M 45047, I/A 124(27.02.14).
25 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: DIEZ VERGARA MAITANE. VsecrNoConsj: MENDEZ ZORI JOSE MARIA. Revocaciones.Apoderado: APARICIO FERNANDEZ JULIA;APARICIO FERNANDEZ JULIA;MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA. Nombramientos.Secretario: MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO. Vicesecret.: RIQUELME ORTIZ MARIA JOSE. Apo.Man.Soli: SANCHEZ PALENCIAIRENE. Datos registrales. T 26688 , F 171, S 8, H M 45047, I/A 123 (13.03.13).
10 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 171, S 8, H M 45047, I/A 122 (27.09.12).
19 de Septiembre de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 171, S 8, H M 45047, I/A 121 ( 7.09.11).
17 de Febrero de 2011Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: WPP HOLDINGS SPAIN SA. Datos registrales. T 26688 , F 170, S 8, H M 45047,I/A 120 ( 3.02.11).
07 de Diciembre de 2010Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 170, S 8, H M 45047, I/A 119 (24.11.10).
25 de Marzo de 2010Nombramientos. Consejero: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON. Apoderado: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON;HOARECHRISTOPHER HENRY ST JOHN. Datos registrales. T 26688 , F 168, S 8, H M 45047, I/A 118 (12.03.10).
10 de Febrero de 2010Revocaciones. Apoderado: DASCA CAVALLER JORDI. Nombramientos. Apoderado: CERIA UGO;BELINCHON GUIJARRO JOSELUIS. Datos registrales. T 26688 , F 166, S 8, H M 45047, I/A 117 (27.01.10).
08 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: DASCA CAVALLER JORDI. Consejero: DASCA CAVALLER JORDI. Datos registrales. T 26688 , F166, S 8, H M 45047, I/A 116 (27.01.10).
24 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 166, S 8, H M 45047, I/A 115 (11.11.09).
23 de Octubre de 2009Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: DELVICO COMUNICACION SL. Datos registrales. T 26688 , F 165, S 8, H M45047, I/A 114 (13.10.09).
23 de Septiembre de 2009P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 26688 , F 165, S 8, H M 45047, I/A 113 (10.09.09).