Buscador CIF Logo

Actos BORME Jwt Delvico Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Jwt Delvico Sl

Actos BORME Jwt Delvico Sl - B28171148

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Jwt Delvico Sl con CIF B28171148

馃敊 Perfil de Jwt Delvico Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Jwt Delvico Sl

24 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN;DE LA NUEZ MAGARZO JUAN MANUEL;PIERAMARTORELL JOSE MARIA. Presidente: DE LA NUEZ MAGARZO JUAN MANUEL. SecreNoConsj: BARRIL FOLGUERA JORDI.Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO;BOSCH MINGUET FRANCISCO JAVIER;ATIENZA JIMENEZ JARA-ALEJANDRA. Apo.Manc.: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN. Apo.Sol.: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN.Apo.Manc.: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON. Apo.Sol.: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON. Apo.Manc.: DE LA NUEZ MAGARZOJUAN MANUEL. Apo.Sol.: DE LA NUEZ MAGARZO JUAN MANUEL. Apo.Manc.: BARRIL FOLGUERA JORDI. Apo.Sol.: BARRILFOLGUERA JORDI. Apo.Manc.: PIERA MARTORELL JOSE MARIA. Apo.Sol.: PIERA MARTORELL JOSE MARIA. Apo.Manc.:SANCHEZ PALENCIA IRENE. Apo.Sol.: SANCHEZ PALENCIA IRENE. Apo.Manc.: PELAEZ GOMEZ ESTHER. Apo.Sol.: PELAEZGOMEZ ESTHER. Apo.Manc.: ROMO BALSEIRO MAR. Apo.Sol.: ROMO BALSEIRO MAR. Apo.Manc.: TOME GARCIA RAMON.Apo.Sol.: TOME GARCIA RAMON. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 26688 , F 182, S 8, H M 45047, I/A 138(17.02.20).

16 de Enero de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BARDULLAS FLORES JOSE LUIS;HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN.Nombramientos. Consejero: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN;DE LA NUEZ MAGARZO JUAN MANUEL;PIERAMARTORELL JOSE MARIA. Presidente: DE LA NUEZ MAGARZO JUAN MANUEL. SecreNoConsj: BARRIL FOLGUERA JORDI.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 26688 , F 179, S 8, H M 45047, I/A 136 ( 9.01.19).

Revocaciones. Apoderado: HERAS MARTINEZ ANGEL ALBERTO;TOME GARCIA RAMON. Apo.Man.Soli: CISNEROS CANALSMANUELA. Apoderado: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON;HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN. Apo.Man.Soli: SANCHEZPALENCIA IRENE;BARDULLAS FLORES JOSE LUIS. Apo.Sol.: CISNEROS CANALS MANUELA;TOME GARCIA RAMON.Nombramientos. Apo.Manc.: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN. Apo.Sol.: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN.Apo.Manc.: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON. Apo.Sol.: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON. Apo.Manc.: DE LA NUEZ MAGARZOJUAN MANUEL. Apo.Sol.: DE LA NUEZ MAGARZO JUAN MANUEL. Apo.Manc.: BARRIL FOLGUERA JORDI. Apo.Sol.: BARRILFOLGUERA JORDI. Apo.Manc.: PIERA MARTORELL JOSE MARIA. Apo.Sol.: PIERA MARTORELL JOSE MARIA. Apo.Manc.:SANCHEZ PALENCIA IRENE. Apo.Sol.: SANCHEZ PALENCIA IRENE. Apo.Manc.: PELAEZ GOMEZ ESTHER. Apo.Sol.: PELAEZGOMEZ ESTHER. Apo.Manc.: ROMO BALSEIRO MAR. Apo.Sol.: ROMO BALSEIRO MAR. Apo.Manc.: TOME GARCIA RAMON.Apo.Sol.: TOME GARCIA RAMON. Datos registrales. T 26688 , F 180, S 8, H M 45047, I/A 137 ( 9.01.19).

10 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 179, S 8, H M 45047, I/A 135 ( 3.10.18).

28 de Diciembre de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 179, S 8, H M 45047, I/A 134 (19.12.17).

26 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO. Consejero: PALOMAR GIMENO JORDI. Presidente: PALOMARGIMENO JORDI. Consejero: HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN;MARTINEZ MORENO ALEJANDRO;BIRD SPENSLEYSALLY SHARON. Nombramientos. Adm. Mancom.: BARDULLAS FLORES JOSE LUIS;HOARE CHRISTOPHER HENRY ST JOHN.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datosregistrales. T 26688 , F 178, S 8, H M 45047, I/A 132 (18.12.17).

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ MORENO ALEJANDRO;CERIA UGO. Apo.Sol.: EZPONDA DELGADO MARIAISABEL;SERRANO LOPEZ DE LAS HAZAS JOSE CARLOS;ALVAREZ CIENFUEGOS JAVIER. Datos registrales. T 26688 , F 178,S 8, H M 45047, I/A 133 (18.12.17).

08 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: CISNEROS CANALS MANUELA;TOME GARCIA RAMON. Datos registrales. T 26688 , F 178, S 8, H M45047, I/A 131 (25.04.17).

06 de Junio de 2016
Revocaciones. Apoderado: PALOMAR GIMENO JORDI;BELINCHON GUIJARRO JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Sol.:MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO;ALVAREZ CIENFUEGOS JAVIER;BOSCH MINGUET FRANCISCO JAVIER;ATIENZA JIMENEZJARA-ALEJANDRA. Apo.Man.Soli: BARDULLAS FLORES JOSE LUIS. Datos registrales. T 26688 , F 175, S 8, H M 45047, I/A 130(30.05.16).

28 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: CASERO YNFIESTA ARACELI. Nombramientos. Apo.Sol.: EZPONDA DELGADO MARIA

09 de Marzo de 2015
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 130 (MADRID). Datos registrales. T 26688 , F 174, S 8, H M 45047, I/A

25 de Noviembre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 174, S 8, H M 45047, I/A 127 (18.11.14).

06 de Noviembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: RIQUELME ORTIZ MARIA JOSE. Revocaciones. Apoderado: FUENTES MARTIN CARLOSMANUEL;IBA脩EZ SANCHEZ IGNACIO;ROCAMORA GUTIERREZ JUAN;VERGARA SEGURA MIGUEL ANGEL;LLINAS GRAURAFAEL;BERTRAN RASPALL MARIA JESUS;FUENTES MARTIN CARLOS MANUEL;LLINAS GRAU RAFAEL;SEYMOUR PETERA;FUENTES MARTIN CARLOS MANUEL;RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN;CIUDAD IGLESIAS JIMENA.Nombramientos. VsecrNoConsj: CASERO YNFIESTA ARACELI. Datos registrales. T 26688 , F 174, S 8, H M 45047, I/A 126(30.10.14).

30 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 173, S 8, H M 45047, I/A 125 (21.10.14).

06 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: CHAMORRO MU脩OZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 26688 , F 173, S 8, H M 45047, I/A 124(27.02.14).

25 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: DIEZ VERGARA MAITANE. VsecrNoConsj: MENDEZ ZORI JOSE MARIA. Revocaciones.Apoderado: APARICIO FERNANDEZ JULIA;APARICIO FERNANDEZ JULIA;MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA. Nombramientos.Secretario: MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO. Vicesecret.: RIQUELME ORTIZ MARIA JOSE. Apo.Man.Soli: SANCHEZ PALENCIAIRENE. Datos registrales. T 26688 , F 171, S 8, H M 45047, I/A 123 (13.03.13).

10 de Octubre de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 171, S 8, H M 45047, I/A 122 (27.09.12).

19 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 171, S 8, H M 45047, I/A 121 ( 7.09.11).

17 de Febrero de 2011
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: WPP HOLDINGS SPAIN SA. Datos registrales. T 26688 , F 170, S 8, H M 45047,I/A 120 ( 3.02.11).

07 de Diciembre de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 170, S 8, H M 45047, I/A 119 (24.11.10).

25 de Marzo de 2010
Nombramientos. Consejero: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON. Apoderado: BIRD SPENSLEY SALLY SHARON;HOARECHRISTOPHER HENRY ST JOHN. Datos registrales. T 26688 , F 168, S 8, H M 45047, I/A 118 (12.03.10).

10 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apoderado: DASCA CAVALLER JORDI. Nombramientos. Apoderado: CERIA UGO;BELINCHON GUIJARRO JOSELUIS. Datos registrales. T 26688 , F 166, S 8, H M 45047, I/A 117 (27.01.10).

08 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: DASCA CAVALLER JORDI. Consejero: DASCA CAVALLER JORDI. Datos registrales. T 26688 , F166, S 8, H M 45047, I/A 116 (27.01.10).

24 de Noviembre de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26688 , F 166, S 8, H M 45047, I/A 115 (11.11.09).

23 de Octubre de 2009
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: DELVICO COMUNICACION SL. Datos registrales. T 26688 , F 165, S 8, H M45047, I/A 114 (13.10.09).

23 de Septiembre de 2009
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 26688 , F 165, S 8, H M 45047, I/A 113 (10.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n