Actos BORME de Kalfrisa Sa
21 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: CLAVER MONZON JOSE MARIA;SAMPER BLASCO NURIA. Presidente: CLAVER MONZON JOSEMARIA. Con.Delegado: CLAVER MONZON JOSE MARIA. Consejero: IZUZQUIZA RUEDA JOSE MARIA. Secretario: IZUZQUIZARUEDA JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: IZUZQUIZA ABRIL ANDRES. Presidente: IZUZQUIZA ABRIL ANDRES.Consejero: CLAVER MONZON JOSE MARIA. Secretario: CLAVER MONZON JOSE MARIA. Consejero: SAMPER BLASCO NURIA.Con.Delegado: CLAVER MONZON JOSE MARIA. Datos registrales. T 3421 , F 176, S 8, H Z 8260, I/A 54 (10.08.23).
19 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: BELTRAN DOMINGUEZ SONIA. Datos registrales. T 3421 , F 176, S 8, H Z 8260, I/A 53 (12.11.21).
11 de Octubre de 2021Nombramientos. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3421 , F 176, S 8, H Z 8260, I/A 52 ( 4.10.21).
05 de Agosto de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: VERA POLO ANTONIO;LABORDA CARDON MARIA-ANGEL. Datos registrales. T 3421 , F 175, S 8, HZ 8260, I/A 51 (29.07.21).
28 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: IZUZQUIZA ABRIL GUILLERMO. Secretario: IZUZQUIZA ABRIL GUILLERMO. Nombramientos.Consejero: IZUZQUIZA RUEDA JOSE MARIA. Secretario: IZUZQUIZA RUEDA JOSE MARIA. Reelecciones. Consejero: CLAVERMONZON JOSE MARIA;SAMPER BLASCO NURIA. Presidente: CLAVER MONZON JOSE MARIA. Con.Delegado: CLAVER MONZONJOSE MARIA. Datos registrales. T 3421 , F 175, S 8, H Z 8260, I/A 50 (16.12.20).
31 de Diciembre de 2019Cambio de domicilio social. C/ D 65 - POLIGONO INDUSTRIAL MALPICA (ZARAGOZA). Datos registrales. T 3421 , F 175, S 8, HZ 8260, I/A 49 (20.12.19).
11 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3421 , F 175, S 8, H Z 8260, I/A 48 ( 4.02.19).
09 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: IZUZQUIZA ABRIL ANDRES. Datos registrales. T 3421 , F 174, S 8, H Z 8260, I/A 47 ( 2.02.16).
15 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: CLAVER MONZON JOSE MARIA;SAMPER BLASCO CASILDA;IZUZQUIZA ABRIL ANDRES.Presidente: IZUZQUIZA ABRIL ANDRES. Cons.Del.Sol: IZUZQUIZA ABRIL ANDRES. Vicepresid.: SAMPER BLASCO CASILDA.Secretario: CLAVER MONZON JOSE MARIA. Cons.Del.Sol: CLAVER MONZON JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero:CLAVER MONZON JOSE MARIA;SAMPER BLASCO NURIA;IZUZQUIZA ABRIL GUILLERMO. Presidente: CLAVER MONZON JOSEMARIA. Secretario: IZUZQUIZA ABRIL GUILLERMO. Con.Delegado: CLAVER MONZON JOSE MARIA. Datos registrales. T 3421 , F174, S 8, H Z 8260, I/A 46 ( 5.01.16).
11 de Diciembre de 2015Nombramientos. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3421 , F 173, S 8, H Z 8260, I/A 45 ( 2.12.15).
28 de Febrero de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: LABORDA CARDON MARIA-ANGEL. Datos registrales. T 3421 , F 173, S 8, H Z 8260, I/A 44(21.02.14).
18 de Febrero de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: SIESO ESCOLANO RAIMUNDO. Datos registrales. T 3421 , F 173, S 8, H Z 8260, I/A 43 (11.02.14).
30 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apoderado: IZUZQUIZA LATRE GREGORIO;IZUZQUIZA LATRE GREGORIO;CLAVER DOMINGUEZ JOSE MARIA.Datos registrales. T 3421 , F 173, S 8, H Z 8260, I/A 42 (18.12.13).
03 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: GIMENEZ MEDEL IGNACIO;SIESO ESCOLANO RAIMUNDO. Apoderado: FERNANDEZ GONZALEZFELIX;FERNANDEZ GONZALEZ FELIX;MARQUES INSA JOSE LUIS;IZUZQUIZA RUEDA JOSE MARIA ENRIQUE. Apo.Manc.:GABAS APARICIO JOSE LUIS ANGEL. Apoderado: PEREZ LLANTADA GUTIERREZ JAIME;IZUZQUIZA LATREANDRES;IZUZQUIZA LATRE ANDRES;GRACIA LUENGO RAMIRO;GIMENEZ MEDEL IGNACIO;SIESO ESCOLANORAIMUNDO;CLAVER PROS JOSE;CEBOLLADA GIMENEZ SANTIAGO;FERNANDEZ GONZALEZ FELIX. Apo.Manc.: ABENIAESCARTIN RICARDO. Apoderado: CEBOLLADA GIMENEZ SANTIAGO;FERNANDEZ GONZALEZ FELIX;GABAS APARICIO JOSELUIS ANGEL. Apo.Manc.: GIMENEZ MEDEL IGNACIO;SIESO ESCOLANO RAIMUNDO. Datos registrales. T 3421 , F 173, S 8, H Z8260, I/A 41 (21.05.13).
25 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3421 , F 173, S 8, H Z 8260, I/A 40 (15.01.13).
31 de Julio de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: FRANCO MAISONAVE ENRIQUE. Datos registrales. T 3421 , F 172, S 8, H Z 8260, I/A 39 (19.07.12).
07 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: MONTAÑES LATORRE IGNACIO. Datos registrales. T 3421 , F 172, S 8, H Z 8260, I/A 38 (24.11.11).
24 de Marzo de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: ABENIA ESCARTIN RICARDO. Nombramientos. Apo.Manc.: VERA POLO ANTONIO. Datosregistrales. T 3421 , F 172, S 8, H Z 8260, I/A 37 (14.03.11).
15 de Noviembre de 2010Reelecciones. Consejero: IZUZQUIZA ABRIL ANDRES;SAMPER BLASCO CASILDA;CLAVER MONZON JOSE MARIA. Presidente:IZUZQUIZA ABRIL ANDRES. Secretario: CLAVER MONZON JOSE MARIA. Vicepresid.: SAMPER BLASCO CASILDA. Cons.Del.Sol:IZUZQUIZA ABRIL ANDRES;CLAVER MONZON JOSE MARIA. Datos registrales. T 3421 , F 172, S 8, H Z 8260, I/A 36 ( 3.11.10).
12 de Agosto de 2010Modificaciones estatutarias. ARTICULO 27.- El Consejo de Administración percibirá en concepto de dietas la cantidad anual que fijela Junta General, que no podrá exceder del dos por mil del capital social, la cual se distribuirá entre sus miembros en la forma que elpropio Consejo determine.. ARTICULO 32.- El Consejo de Administración será retribuidocon una cantidad fija que anualmente seráfijada por la Junta General. Dicha retribución podrá ser repartida en forma desigual entre los miembros del Consejo.. Datosregistrales. T 3421 , F 172, S 8, H Z 8260, I/A 35 ( 3.08.10).
11 de Enero de 2010Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3421 , F 172, S 8, H Z 8260, I/A 34 (29.12.09).
12 de Agosto de 2009Revocaciones. Apo.Manc.: GIMENEZ MEDEL IGNACIO. Datos registrales. T 3421 , F 172, S 8, H Z 8260, I/A 33 ( 3.08.09).