Actos BORME de Kalon Mantenimiento Industrial Sa
02 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: DEL BOSQUE CASTAÑO JOSE LUIS. Datos registrales. T 41651 , F 222, S 8, H M 35540, I/A 97(25.11.21).
22 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: CENTENO REY ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: CENTENO REY ANTONIO. Datosregistrales. T 41651 , F 221, S 8, H M 35540, I/A 96 (15.11.21).
04 de Octubre de 2021Nombramientos. Auditor: BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS SL. Datos registrales. T 41651 , F 221, S 8, H M 35540, I/A 95(27.09.21).
17 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: HEREDIA HERNANDEZ CLARA. Datos registrales. T 41651 , F 220, S 8, H M 35540, I/A 94(10.05.21).
14 de Mayo de 2021Declaración de unipersonalidad. Socio único: PROLUTEC SA. Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GIL DE BIEDMA RODRIGUEZSALMONES MARTA. Consejero: MORENO MEDINA LUIS;BENJUMEA DIEZ JOSE IGNACIO;GARCIA MENDOZA KLAIBERCARLOS. Presidente: BENJUMEA DIEZ JOSE IGNACIO. Con.Delegado: MORENO MEDINA LUIS. Modificaciones estatutarias.17.-. . 18.-.. 19.-. . 20.-. . 21.-.. 22.-. . 23..-. 24º.-. 25.-.Sin contenido. 26.-.-.Sin contenido. 27.-. Sin contenido. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 27248 , F 197, S 8, HM 35540, I/A 90 ( 7.05.21).
Nombramientos. Adm. Unico: LOPEZ HURTADO JUAN. Datos registrales. T 27248 , F 198, S 8, H M 35540, I/A 91 ( 7.05.21).
Nombramientos. Apoderado: ESCOBAR SIMARRO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 27248 , F 198, S 8, H M 35540, I/A 92( 7.05.21).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ TRIQUELL BORJA. Datos registrales. T 27248 , F 199, S 8, H M 35540, I/A 93 ( 7.05.21).
06 de Octubre de 2020Modificaciones estatutarias. Se modifica el artículo 15 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 27248 , F 197, S 8, H M35540, I/A 89 (29.09.20).
13 de Febrero de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: LAZCOZ CISNEROS FRANSCISCO JAVIER. Datos registrales. T 27248 , F 195, S 8, H M 35540, I/A 88( 6.02.19).
04 de Septiembre de 2018Reelecciones. Consejero: MORENO MEDINA LUIS;BENJUMEA DIEZ JOSE IGNACIO;GARCIA MENDOZA KLAIBER CARLOS.Datos registrales. T 27248 , F 194, S 8, H M 35540, I/A 85 (27.08.18).
Nombramientos. Auditor: FGH AUDITORES SL. Datos registrales. T 27248 , F 195, S 8, H M 35540, I/A 86 (27.08.18).
Reelecciones. Presidente: BENJUMEA DIEZ JOSE IGNACIO. Con.Delegado: MORENO MEDINA LUIS. Datos registrales. T 27248, F 195, S 8, H M 35540, I/A 87 (27.08.18).
26 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.D.Gral.: CASADO RASERO ALBERTO. Datos registrales. T 27248 , F 194, S 8, H M 35540, I/A 84 (18.06.18).
22 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.D.Gral.: CASADO RASERO ALBERTO. Datos registrales. T 27248 , F 193, S 8, H M 35540, I/A 83 ( 7.03.17).
24 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: VALVERDE ESPEJO FRANCISCO. Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ DE HEREDIA JUANMARIA. Datos registrales. T 27248 , F 192, S 8, H M 35540, I/A 82 (15.11.16).
03 de Febrero de 2016Nombramientos. Auditor: FGH AUDITORES SL. Datos registrales. T 27248 , F 192, S 8, H M 35540, I/A 81 (26.01.16).
27 de Abril de 2015Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 27248 ,F 191, S 8, H M 35540, I/A 79 (16.04.15).
24 de Abril de 2015Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 27248 , F 192, S 8, H M 35540, I/A 80 (16.04.15).
24 de Junio de 2014Revocaciones. Apoderado: CENTENO REY ANTONIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CENTENO REY ANTONIO. Datosregistrales. T 27248 , F 190, S 8, H M 35540, I/A 77 (13.06.14).
Revocaciones. Apoderado: DEL BOSQUE CASTAÑO JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL BOSQUE CASTAÑOJOSE LUIS. Datos registrales. T 27248 , F 190, S 8, H M 35540, I/A 78 (13.06.14).
28 de Abril de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA MENDOZA MOLINA JUAN MANUEL. Apo.Manc.: DEL BOSQUE CASTAÑO JOSELUIS;VALVERDE ESPEJO FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: DEL BOSQUE CASTAÑO JOSE LUIS;VALVERDE ESPEJOFRANCISCO;CENTENO REY ANTONIO. Datos registrales. T 27248 , F 189, S 8, H M 35540, I/A 76 (16.04.14).