Actos BORME de Kauman Sa
01 de Junio de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: REY FERRAN ALBERTO;NU脩EZ ABELENDA PEDRO;REY FERNANDEZ JUAN;REY VARELAALBERTO;REY FERNANDEZ JAIME. Presidente: REY FERRAN ALBERTO. Vicepresid.: NU脩EZ ABELENDA PEDRO. SecreNoConsj:CORNEJO MOLINS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Consejero: REYBA INVERSIONES SL;NU脩EZABELENDA PEDRO ANTONIO;REY FERNANDEZ JAIME;REY VARELA ALBERTO;REY FERNANDEZ JUAN. Presidente: REYBAINVERSIONES SL. Con.Delegado: REYBA INVERSIONES SL. Vicepresid.: NU脩EZ ABELENDA PEDRO ANTONIO. Secretario: REYFERNANDEZ JAIME. Otros conceptos: El socio 煤nico decide la modificaci贸n del art铆culo 21潞 de los estatutos sociales. Datosregistrales. T 4037, L 4037, F 23, S 8, H PO 8636, I/A 46 (22.05.23).
12 de Abril de 2023Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: REYBA INVERSIONES SL. Datos registrales. T 4037, L 4037, F 23, S 8, H PO8636, I/A 45 (31.03.23).
23 de Junio de 2022Reelecciones. Auditor: K4 IBERICA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 4037, L 4037, F 23,S 8, H PO 8636, I/A 44 (15.06.22).
22 de Junio de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: GAINZARAIN GONZALEZ JOSE LUIS;GARCIA MOSQUERA SONIA MARTA;REY FERNANDEZJUAN;REY VARELA ALBERTO. Datos registrales. T 4037, L 4037, F 23, S 8, H PO 8636, I/A 43 (12.06.20).
08 de Junio de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA MOLINS FLORENCIO;GARCIA MOSQUERA SONIA;REY FERNANDEZ JUAN;REY VARELAALBERTO;REY FERNANDEZ JAIME. Datos registrales. T 4037, L 4037, F 22, S 8, H PO 8636, I/A 42 (29.05.20).
06 de Noviembre de 2019Nombramientos. Auditor: K4 IBERICA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 4037, L 4037, F22, S 8, H PO 8636, I/A 41 (25.10.19).
10 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: AUDITA 2 PRADILLA SLP. Datos registrales. T 4037, L4037, F 22, S 8, H PO 8636, I/A 40 (28.12.18).
19 de Enero de 2018Cancelaciones de oficio de nombramientos. Aud.Supl.: FERNANDEZ DE LA PRADILLA MEIJIDE PATRICIA. Nombramientos.Aud.Supl.: AUDITA 2 PRADILLA SLP. Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Datos registrales. T 4037, L4037, F 21, S 8, H PO 8636, I/A 39 (11.01.18).
16 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: GAINZARAIN GONZALEZ JOSE LUIS;GARCIA MOSQUERA SONIA MARTA;REY FERNANDEZJUAN;REY VARELA ALBERTO. Datos registrales. T 4037, L 4037, F 21, S 8, H PO 8636, I/A 38 ( 6.10.17).
26 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: REY FERRAN JUAN JOSE;CORNEJO MOLINS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN;REY FERRANALBERTOPresidente: REY FERRAN JUAN JOSE. Con.Delegado: REY FERRAN JUAN JOSE. Secretario: CORNEJO MOLINSGONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ TILVE EUDORO. Nombramientos. SecreNoConsj:CORNEJO MOLINS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Consejero: REY FERRAN ALBERTO;NU脩EZ ABELENDA PEDRO;REYFERNANDEZ JUAN;REY VARELA ALBERTO;REY FERNANDEZ JAIME. Presidente: REY FERRAN ALBERTO. Vicepresid.: NU脩EZABELENDA PEDRO. Datos registrales. T 4037, L 4037, F 20, S 8, H PO 8636, I/A 37 (19.09.17).
11 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: GAINZARAIN GONZALEZ JOSE LUIS;GARCIA MOSQUERZ SONIA;REY FERNANDEZ JUAN;REYVARELA ALBERTO. Datos registrales. T 4037, L 4037, F 20, S 8, H PO 8636, I/A 36 ( 3.08.17).
09 de Enero de 2017Revocaciones. Aud.Supl.: GODOY VAZQUEZ MARTA. Nombramientos. Aud.Supl.: FERNANDEZ DE LA PRADILLA MEIJIDEPATRICIA. Datos registrales. T 4037, L 4037, F 20, S 8, H PO 8636, I/A 35 (30.12.16).
19 de Mayo de 2015Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: GODOY VAZQUEZ MARTA. Datos registrales. T 1259, L1259, F 99, S 8, H PO 8636, I/A 34 ( 6.05.15).
30 de Marzo de 2015P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INVERSIONES CUYAMEL SL. Datosregistrales. T 1259, L 1259, F 99, S 8, H PO 8636, I/A 33 (19.03.15).
08 de Octubre de 2014Nombramientos. Con.Delegado: REY FERRAN JUAN JOSE. Datos registrales. T 1259, L 1259, F 98, S 8, H PO 8636, I/A 31(29.09.14).
Reelecciones. Consejero: CORNEJO MOLINS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Secretario: CORNEJO MOLINS GONZALEZMARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 1259, L 1259, F 98, S 8, H PO 8636, I/A 32 (29.09.14).
24 de Enero de 2013Reelecciones. Presidente: REY FERRAN JUAN JOSE. Consejero: REY FERRAN JUAN JOSE;REY FERRAN ALBERTO. Datosregistrales. T 1259, L 1259, F 98, S 8, H PO 8636, I/A 30 (16.01.13).
23 de Marzo de 2012Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: GODOY VAZQUEZ MARTA. Datos registrales. T 1259, L1259, F 98, S 8, H PO 8636, I/A 29 (12.03.12).
01 de Abril de 2011Revocaciones. Apoderado: ROMERO BANDEIRA MIGUEL. Datos registrales. T 1259, L 1259, F 97, S 8, H PO 8636, I/A 27(21.03.11).
Nombramientos. Apoderado: CORNEJO-MOLINS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 1259, L 1259, F 97, S 8,H PO 8636, I/A 28 (21.03.11).
04 de Noviembre de 2009Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: INVERSIONES CUYAMEL SL. Datos registrales. T 1259, L 1259, F 96, S 8, H PO8636, I/A 25 (21.10.09).
Nombramientos. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: GODOY VAZQUEZ MARTA. Datos registrales. T 1259,L 1259, F 97, S 8, H PO 8636, I/A 26 (21.10.09).
29 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Secretario: CORNEJO-MOLINS GONZALEZ JESUS. Consejero: CORNEJO-MOLINS GONZALEZ JESUS.Nombramientos. Consejero: CORNEJO MOLINS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Secretario: CORNEJO MOLINS GONZALEZMARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 1259, L 1259, F 96, S 8, H PO 8636, I/A 24 (17.09.09).