Actos BORME de Kazesp Sl
29 de Agosto de 2023Nombramientos. APODERAD.SOL: GARCIA PRADOS CARLES. Datos registrales. T 33688 , F 219, S 8, H B 234312, I/A 11(22.08.23).
04 de Noviembre de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 57.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 54.600,00 Euros. Datos registrales. T 33688 , F218, S 8, H B 234312, I/A 10 (27.10.22).
21 de Abril de 2022Nombramientos. APODERAD.SOL: GARCIA PRADOS CARLES. Datos registrales. T 33688 , F 218, S 8, H B 234312, I/A 9(12.04.22).
07 de Febrero de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 8.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 111.600,00 Euros. Datos registrales. T 33688 , F218, S 8, H B 234312, I/A 8 (31.01.22).
22 de Mayo de 2018Revocaciones. ADMINISTR.: MATA MIER AQUILINO. Nombramientos. ADM.UNICO: MATA SAGARRA FERRAN. Datosregistrales. T 33688 , F 218, S 8, H B 234312, I/A 7 (15.05.18).
18 de Abril de 2018Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 28 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 33688 , F 217, S 8, H B 234312, I/A 6 ( 6.04.18).
02 de Noviembre de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: MATA SAGARRA FERRAN. Datos registrales. T 33688 , F 216, S 8, H B 234312, I/A 5(24.10.17).
23 de Noviembre de 2016Cambio de domicilio social. CL QUIMICA, NUM.23 POL.IND. DE CAN SUNYER (SANT ANDREU DE LA BARCA). Datosregistrales. T 33688 , F 216, S 8, H B 234312, I/A 4 (15.11.16).