Buscador CIF Logo

Actos BORME Keylab Medical Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Keylab Medical Sl

Actos BORME Keylab Medical Sl - B61053922

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Keylab Medical Sl con CIF B61053922

馃敊 Perfil de Keylab Medical Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Keylab Medical Sl

13 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BRDENK JEAN CLAUDE. Nombramientos. Adm. Unico: JOURDANNEY OLIVIER. Datosregistrales. T 30759 , F 125, S 8, H M 553504, I/A 19 ( 5.10.23).

24 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Datos registrales. T 30759 , F 125, S 8, H M 553504, I/A 18(17.02.23).

03 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOURDANNEY OLIVIER;CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Presidente: CAMPOS MARTINEZMANUEL. Consejero: BASTIDE VICENT PIERRE. SecreNoConsj: OLIVA VILA MARC. Nombramientos. Adm. Unico: BRDENKJEAN CLAUDE. Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejode administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 30759 , F 124, S 8, H M 553504, I/A 17 (27.01.23).

13 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: OLIVA VILA MARC. Datos registrales. T 30759 , F 124, S 8, H M 553504, I/A 16 ( 2.12.22).

31 de Octubre de 2022
Modificaciones estatutarias. 19. Ejercicio social.-. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Datos registrales. T 30759 , F 124, S 8, H M553504, I/A 15 (24.10.22).

30 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: BARAMBIO DOMENECH SUSANA. Datos registrales. T 30759 , F 123, S 8, H M 553504, I/A 14(23.08.22).

09 de Junio de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: JOURDANNEY OLIVIER. Apo.Man.Soli: REINOSO VESGA MARC;OLIVA VILA MARC. Datosregistrales. T 30759 , F 122, S 8, H M 553504, I/A 13 ( 2.06.22).

06 de Junio de 2022
Cambio de domicilio social. C/ DOMENICO SCARLATTI 3 - LOCAL 18 B (MADRID). Datos registrales. T 30759 , F 122, S 8, H M553504, I/A 12 (30.05.22).

28 de Diciembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: FAYOLLE ARNAUD. Nombramientos. Consejero: BASTIDE VICENT PIERRE. Datos registrales.T 30759 , F 121, S 8, H M 553504, I/A 11 (21.12.21).

01 de Diciembre de 2021
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BASTIDE LE CONFORT MEDICAL. Datos registrales. T 30759 , F 121, S 8, H M553504, I/A 10 (24.11.21).

21 de Julio de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: OLIVA VILA MARC;CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Apo.Manc.: JOURDANNEY OLIVIER. Datosregistrales. T 30759 , F 120, S 8, H M 553504, I/A 9 (14.07.21).

09 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: REINOSO VESGA MARC. Secretario: REINOSO VESGA MARC. Nombramientos. SecreNoConsj:OLIVA VILA MARC. Datos registrales. T 30759 , F 120, S 8, H M 553504, I/A 8 ( 2.07.21).

27 de Mayo de 2021
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30759 , F 119, S 8, H M 553504, I/A 7 (20.05.21).

20 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO;CAMPOS MARTINEZ MANUEL;CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS.Presidente: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Secretario: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Con.Delegado: CAMPOS MARTINEZMANUEL. D. Gerente: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: FAYOLLE ARNAUD;JOURDANNEYOLIVIER;REINOSO VESGA MARC;CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Secretario: REINOSO VESGA MARC. Presidente: CAMPOSMARTINEZ MANUEL. Datos registrales. T 30759 , F 118, S 8, H M 553504, I/A 6 (13.10.20).

20 de Julio de 2020
Nombramientos. Apoderado: REINOSO VESGA MARC. Datos registrales. T 30759 , F 117, S 8, H M 553504, I/A 5 (10.07.20).

02 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: REINOSO VESGA MARC. Datos registrales. T 30759 , F 116, S 8, H M 553504, I/A 4 (24.02.20).

17 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Presidente: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Consejero: GUILLOPECOS ANA MARIA. Secretario: GUILLO PECOS ANA MARIA. Consejero: RODRIGUEZ MARTINEZ TERESA. Nombramientos.Consejero: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO;CAMPOS MARTINEZ MANUEL;CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Presidente:CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Secretario: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Con.Delegado: CAMPOS MARTINEZ MANUEL.Ampliaci贸n de capital. Capital: 54.006,94 Euros. Resultante Suscrito: 60.017,06 Euros. Modificaciones estatutarias. 7. Datosregistrales. T 30759 , F 115, S 8, H M 553504, I/A 3 (10.04.18).

25 de Abril de 2013
Cambio de domicilio social. C/ SANCHO DAVILA 21 (MADRID). Datos registrales. T 30759 , F 115, S 8, H M 553504, I/A 2(16.04.13).

21 de Marzo de 2013
Revocaciones. ADM.UNICO: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Nombramientos. CONSEJERO: CAMPOS MARTINEZSANTIAGO. PRESIDENTE: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. CONSEJERO: GUILLO PECOS ANA MARIA. SECRETARIO: GUILLO

19 de Octubre de 2011
Revocaciones. ADM.UNICO: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Nombramientos. ADM.UNICO: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS.Datos registrales. T 28934 , F 113, S 8, H B 143567, I/A 4 ( 7.10.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n