Actos BORME de Keylab Medical Sl
13 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BRDENK JEAN CLAUDE. Nombramientos. Adm. Unico: JOURDANNEY OLIVIER. Datosregistrales. T 30759 , F 125, S 8, H M 553504, I/A 19 ( 5.10.23).
24 de Febrero de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Datos registrales. T 30759 , F 125, S 8, H M 553504, I/A 18(17.02.23).
03 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: JOURDANNEY OLIVIER;CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Presidente: CAMPOS MARTINEZMANUEL. Consejero: BASTIDE VICENT PIERRE. SecreNoConsj: OLIVA VILA MARC. Nombramientos. Adm. Unico: BRDENKJEAN CLAUDE. Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejode administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 30759 , F 124, S 8, H M 553504, I/A 17 (27.01.23).
13 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: OLIVA VILA MARC. Datos registrales. T 30759 , F 124, S 8, H M 553504, I/A 16 ( 2.12.22).
31 de Octubre de 2022Modificaciones estatutarias. 19. Ejercicio social.-. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Datos registrales. T 30759 , F 124, S 8, H M553504, I/A 15 (24.10.22).
30 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: BARAMBIO DOMENECH SUSANA. Datos registrales. T 30759 , F 123, S 8, H M 553504, I/A 14(23.08.22).
09 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: JOURDANNEY OLIVIER. Apo.Man.Soli: REINOSO VESGA MARC;OLIVA VILA MARC. Datosregistrales. T 30759 , F 122, S 8, H M 553504, I/A 13 ( 2.06.22).
06 de Junio de 2022Cambio de domicilio social. C/ DOMENICO SCARLATTI 3 - LOCAL 18 B (MADRID). Datos registrales. T 30759 , F 122, S 8, H M553504, I/A 12 (30.05.22).
28 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: FAYOLLE ARNAUD. Nombramientos. Consejero: BASTIDE VICENT PIERRE. Datos registrales.T 30759 , F 121, S 8, H M 553504, I/A 11 (21.12.21).
01 de Diciembre de 2021Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BASTIDE LE CONFORT MEDICAL. Datos registrales. T 30759 , F 121, S 8, H M553504, I/A 10 (24.11.21).
21 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: OLIVA VILA MARC;CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Apo.Manc.: JOURDANNEY OLIVIER. Datosregistrales. T 30759 , F 120, S 8, H M 553504, I/A 9 (14.07.21).
09 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: REINOSO VESGA MARC. Secretario: REINOSO VESGA MARC. Nombramientos. SecreNoConsj:OLIVA VILA MARC. Datos registrales. T 30759 , F 120, S 8, H M 553504, I/A 8 ( 2.07.21).
27 de Mayo de 2021Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30759 , F 119, S 8, H M 553504, I/A 7 (20.05.21).
20 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO;CAMPOS MARTINEZ MANUEL;CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS.Presidente: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Secretario: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Con.Delegado: CAMPOS MARTINEZMANUEL. D. Gerente: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: FAYOLLE ARNAUD;JOURDANNEYOLIVIER;REINOSO VESGA MARC;CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Secretario: REINOSO VESGA MARC. Presidente: CAMPOSMARTINEZ MANUEL. Datos registrales. T 30759 , F 118, S 8, H M 553504, I/A 6 (13.10.20).
20 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: REINOSO VESGA MARC. Datos registrales. T 30759 , F 117, S 8, H M 553504, I/A 5 (10.07.20).
02 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: REINOSO VESGA MARC. Datos registrales. T 30759 , F 116, S 8, H M 553504, I/A 4 (24.02.20).
17 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Presidente: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Consejero: GUILLOPECOS ANA MARIA. Secretario: GUILLO PECOS ANA MARIA. Consejero: RODRIGUEZ MARTINEZ TERESA. Nombramientos.Consejero: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO;CAMPOS MARTINEZ MANUEL;CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Presidente:CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Secretario: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Con.Delegado: CAMPOS MARTINEZ MANUEL.Ampliaci贸n de capital. Capital: 54.006,94 Euros. Resultante Suscrito: 60.017,06 Euros. Modificaciones estatutarias. 7. Datosregistrales. T 30759 , F 115, S 8, H M 553504, I/A 3 (10.04.18).
25 de Abril de 2013Cambio de domicilio social. C/ SANCHO DAVILA 21 (MADRID). Datos registrales. T 30759 , F 115, S 8, H M 553504, I/A 2(16.04.13).
21 de Marzo de 2013Revocaciones. ADM.UNICO: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Nombramientos. CONSEJERO: CAMPOS MARTINEZSANTIAGO. PRESIDENTE: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. CONSEJERO: GUILLO PECOS ANA MARIA. SECRETARIO: GUILLO
19 de Octubre de 2011Revocaciones. ADM.UNICO: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Nombramientos. ADM.UNICO: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS.Datos registrales. T 28934 , F 113, S 8, H B 143567, I/A 4 ( 7.10.11).