Actos BORME de Kiluva Sa
04 de Diciembre de 2023Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31156 , F 108, S 8, H M 560711, I/A 23 (27.11.23).
26 de Abril de 2022Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31156 , F 107, S 8, H M 560711, I/A 22 (19.04.22).
24 de Enero de 2022Reelecciones. Adm. Unico: REVUELTA FERNANDEZ FELIX. Datos registrales. T 31156 , F 107, S 8, H M 560711, I/A 21(17.01.22).
22 de Diciembre de 2021Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31156 , F 107, S 8, H M 560711, I/A 20 (15.12.21).
15 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: CASTRO PEREZ MANUEL. Datos registrales. T 31156 , F 106, S 8, H M 560711, I/A 19 ( 8.04.21).
30 de Octubre de 2020Revocaciones. Apoderado: CAMPILLO PINAZO HUGO;CAMPILLO PINAZO HUGO;CAMPILLO PINAZO HUGO. Apo.Sol.:CAMPILLO PINAZO HUGO. Datos registrales. T 31156 , F 106, S 8, H M 560711, I/A 18 (23.10.20).
20 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: CASTRO PEREZ MANUEL. Datos registrales. T 31156 , F 105, S 8, H M 560711, I/A 16 (13.10.20).
Nombramientos. Apoderado: CASTRO PEREZ MANUEL. Datos registrales. T 31156 , F 106, S 8, H M 560711, I/A 17 (13.10.20).
02 de Junio de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 58.701,20 Euros. Resultante Suscrito: 1.941.298,80 Euros. Datos registrales. T 31156 , F101, S 8, H M 560711, I/A 14 (26.05.20).
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: LUAIR AIRLINES SL. Datos registrales. T 31156 , F 102, S 8, H M 560711, I/A 15(26.05.20).
27 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPILLO PINAZO HUGO. Datos registrales. T 31156 , F 101, S 8, H M 560711, I/A 13 (19.09.19).
21 de Agosto de 2019Otros conceptos: Pr贸rroga t谩cita del nombramiento como auditor de BDO AUDITORES, SLP para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.Datos registrales. T 31156 , F 100, S 8, H M 560711, I/A 12 (13.08.19).
24 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: VARGAS ISASI MERCEDES. Datos registrales. T 31156 , F 100, S 8, H M 560711, I/A 11 (12.05.17).
13 de Mayo de 2016Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 5 y 7 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 31156 , F 99, S 8, H M560711, I/A 10 ( 5.05.16).
03 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO BARQUERO RAFAEL. Secretario: MORENO BARQUERO RAFAEL. Consejero:REVUELTA FERNANDEZ FELIX. Presidente: REVUELTA FERNANDEZ FELIX. Con.Delegado: REVUELTA FERNANDEZ FELIX.Consejero: REVUELTA RODRIGUEZ KILIAN;REVUELTA RODRIGUEZ VANESA. Nombramientos. Adm. Unico: REVUELTAFERNANDEZ FELIX. Otros conceptos: Art铆culo de los estatutos: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 11潞 Y 14潞 DE LOS ESTATUTOSPOR CAMBIO DE LA FORMA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD.. Datos registrales. T 31156 , F 99, S 8, H M 560711, I/A 9(20.04.16).
08 de Abril de 2016Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31156 , F 99, S 8, H M 560711, I/A 8 (31.03.16).
24 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apoderado: GARCIA SANCHEZ MARIA BEATRIZ. Datos registrales. T 31156 , F 98, S 8, H M 560711, I/A 6(17.11.14).
Revocaciones. Apoderado: REVUELTA FERNANDEZ JOSE AMANDO. Datos registrales. T 31156 , F 98, S 8, H M 560711, I/A 7(17.11.14).
27 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: TOCINO BISCAROLASAGA ISABEL. Datos registrales. T 31156 , F 98, S 8, H M 560711, I/A 5(17.10.14).
23 de Julio de 2014Revocaciones. Apoderado: BELMONTE MALLO FERNANDO. Datos registrales. T 31156 , F 98, S 8, H M 560711, I/A 4 (15.07.14).
29 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: CAMPILLO PINAZO HUGO. Datos registrales. T 31156 , F 97, S 8, H M 560711, I/A 3 (21.04.14).
31 de Julio de 2013Cambio de domicilio social. C/ CLAUDIO COELLO 91 4潞 (MADRID). Datos registrales. T 31156 , F 97, S 8, H M 560711, I/A 2(18.07.13).
12 de Abril de 2013Nombramientos. AUDT.CTS.CON: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 42961 , F 113, S 8, H B 95768, I/A 33 (2.04.13).
20 de Marzo de 2013Revocaciones. CONSEJERO: REVUELTA FERNANDEZ FELIX. PRESIDENTE: REVUELTA FERNANDEZ FELIX. CONS. DELEG.:REVUELTA FERNANDEZ FELIX. CONSEJERO: REVUELTA RODRIGUEZ VANESA;REVUELTA RODRIGUEZ KILIAN;MORENOBARQUERO RAFAEL. SECRETARIO: MORENO BARQUERO RAFAEL. Nombramientos. CONSEJERO: REVUELTA FERNANDEZFELIX. PRESIDENTE: REVUELTA FERNANDEZ FELIX. CONS. DELEG.: REVUELTA FERNANDEZ FELIX. CONSEJERO:REVUELTA RODRIGUEZ VANESA;REVUELTA RODRIGUEZ KILIAN;MORENO BARQUERO RAFAEL. SECRETARIO: MORENOBARQUERO RAFAEL. Datos registrales. T 42961 , F 113, S 8, H B 95768, I/A 32 ( 8.03.13).
28 de Marzo de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 616.963,40 Euros. Desembolsado: 616.963,40 Euros. Resultante Suscrito: 2.000.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 42961 , F 111, S 8, H B 95768, I/A 31 (16.03.12).
21 de Noviembre de 2011Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 42961 , F 111, S 8, H B 95768, I/A 30 (8.11.11).
10 de Noviembre de 2011Nombramientos. APODERADO: CAMPILLO PINAZO HUGO;BELMONTE MALLO FERNANDO. Datos registrales. T 42961 , F 111,S 8, H B 95768, I/A 29 (28.10.11).
18 de Octubre de 2011Nombramientos. APODERADO: CAMPILLO PINAZO HUGO. Datos registrales. T 25833 , F 78, S 8, H B 95768, I/A 28 ( 5.10.11).
13 de Enero de 2010Nombramientos. AUDT.CTS.CON: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 25833 , F 78, S 8, H B 95768, I/A 27(30.12.09).
16 de Noviembre de 2009Nombramientos. AUDT.CTS.CON: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 25833 , F 77, S 8, H B 95768, I/A 26(30.10.09).
26 de Agosto de 2009Cambio de domicilio social. PJ PEDRO RODRIGUEZ, NUM.4-6 (BARCELONA). Datos registrales. T 25833 , F 77, S 8, H B95768, I/A 25 (13.08.09).
02 de Junio de 2009Revocaciones. CONSEJERO: CASTELLANO RIOS JOSE MARIA. Nombramientos. CONSEJERO: TOCINO BISCAROLASAGAISABEL. Datos registrales. T 25833 , F 77, S 8, H B 95768, I/A 24 (21.05.09).