Buscador CIF Logo

Actos BORME Kingspan Holdings Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Kingspan Holdings Spain Sl

Actos BORME Kingspan Holdings Spain Sl - B83537373

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Kingspan Holdings Spain Sl con CIF B83537373

馃敊 Perfil de Kingspan Holdings Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Kingspan Holdings Spain Sl

03 de Marzo de 2020
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: PARSUM ITG SL. Datos registrales. T 18500 , F 211, S 8, H M 321427, I/A 20 (7.02.20).

13 de Febrero de 2020
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INDUSTRIAL CASSA SA. Datos registrales. T 18500 , F 210, S 8, H M 321427, I/A19 ( 6.02.20).

12 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: INTERTRUST (SPAIN) SL. Representan: FREIRE VILLANOVA ANA. Consejero: MURTAGHGENE MICHAEL. Presidente: MURTAGH GENE MICHAEL. Consejero: CHRISTOPHER ALLON PAUL;DOHERTY GEOFFREYPATRICK. Nombramientos. Adm. Solid.: DOHERTY GEOFFREY PATRICK;MURTAGH GENE MICHAEL. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 18500 , F 209, S8, H M 321427, I/A 18 ( 2.11.18).

06 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;FREIRE VILLANOVA ANA;DIEZ ARRANZ BEATRIZ;MARTINEZGARCIA AITOR;GIL MESINO MIGUEL;MERINO JIMENEZ NATALIA;UTRILLA FERNANDEZ- BERMEJO CRISTINA;INTERTRUST(SPAIN) SL. Datos registrales. T 18500 , F 36, S 8, H M 321427, I/A 17 (29.08.18).

18 de Enero de 2018
Ceses/Dimisiones. Secretario: LOPEZ-IBOR ALI脩O ALFONSO. Nombramientos. SecreNoConsj: INTERTRUST (SPAIN) SL.Apoderado: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. Representan: FREIRE VILLANOVA ANA. Datos registrales. T 18500 , F 36, S 8, H M321427, I/A 16 (11.01.18).

07 de Diciembre de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.984.819,74 Euros. Resultante Suscrito: 6.284.544,00 Euros. Datos registrales. T 18500 , F 36, S8, H M 321427, I/A 15 (28.11.17).

29 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apoderado: ALONSO VILA MARIA;VIVAS MIJAN LAURA;GOMEZ LOPEZ MARTA;BENJELLOUN RADIA;GRANTTHORNTON ASESORES SLP. Datos registrales. T 18500 , F 35, S 8, H M 321427, I/A 14 (19.05.17).

19 de Diciembre de 2012
Otros conceptos: AMPLIADO EL CAPITAL SOCIAL EN LA CANTIDAD DE 1.296.717,89 EUROS, SIENDO EL CAPITAL SUSCRITORESULTANTE: 1.299.724,26 EUROS Y EL CAPITAL DESEMBOLSADO RESULTANTE: 1.299.724, 26 EUROS. Datos registrales. T18500 , F 35, S 8, H M 321427, I/A 13 (11.12.12).

02 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Consejero: DOHERTY GEOFFREY PATRICK. Cambio de domicilio social. C/ LOPEZ DE HOYOS 35 - 3&PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 18500 , F 34, S 8, H M 321427, I/A 11 (18.10.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MULVIHILL DERMOT. Datos registrales. T 18500 , F 35, S 8, H M 321427, I/A 12 (18.10.11).

02 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: CRIMMINS MARK. Nombramientos. Consejero: CHRISTOPHER ALLON PAUL. Datos registrales.T 18500 , F 34, S 8, H M 321427, I/A 10 (24.01.11).

10 de Enero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: MURTAGH EUGENE;LAWLOR PATRICK ALAN. Presidente: MURTAGH EUGENE.Nombramientos. Consejero: MURTAGH GENE MICHAEL. Presidente: MURTAGH GENE MICHAEL. Cambio de domicilio social.

Ceses/Dimisiones. Consejero: MURTAGH BRENDAN. Datos registrales. T 18500 , F 34, S 8, H M 321427, I/A 9 (29.12.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n