Actos BORME de Kitur Sevilla Sociedad De Responsabilidad Limitada
25 de Mayo de 2023Reelecciones. Auditor: AUNA MG AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6573 , F 44, S 8, H SE 56961, I/A 28 (16.05.23).
30 de Noviembre de 2022Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 4º.- Domicilio Social. Cambio de domicilio social. AVDAFERNANDEZ MURUBE 6 - CP 41007 (SEVILLA). Datos registrales. T 6573 , F 44, S 8, H SE 56961, I/A 27 (22.11.22).
02 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: SAN ROMAN GARCIA JULIO FERNANDO;VERGARA FIGUEROA HERIBERTO;LAMOTHEFERNANDEZ JORGE. Nombramientos. Apo.Manc.: LAMOTHE FERNANDEZ JORGE FRANCISCO;DURAN VAZQUEZENRIQUE;MONTERO PEREZ DANIEL JOSE;CHIARA CARBAJO ANTONIO. Datos registrales. T 6573 , F 42, S 8, H SE 56961, I/A26 (24.11.21).
26 de Agosto de 2021Nombramientos. Auditor: AUNA MG AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6573 , F 42, S 8, H SE 56961, I/A 25 (17.08.21).
05 de Julio de 2019Nombramientos. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6573 , F 41, S 8, H SE 56961, I/A 24 (27.06.19).
18 de Junio de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6573 , F 41, S 8, H SE 56961, I/A 23 (11.06.19).
10 de Julio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: ACOSTA PUERTAS SERGIO;LAMOTHE GARCIA JORGE FRANCISCO;DURAN VAZQUEZENRIQUE;GARCIA FACIABEN JORGE. Nombramientos. Apo.Manc.: SAN ROMAN GARCIA JULIO FERNANDO;VERGARAFIGUEROA HERIBERTO;LAMOTHE FERNANDEZ JORGE;DURAN VAZQUEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 3909 , F 225, S 8, HSE 56961, I/A 22 ( 3.07.18).
14 de Mayo de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3909 , F 224, S 8, H SE 56961, I/A 21 ( 3.05.18).
07 de Marzo de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3909 , F 224, S 8, H SE 56961, I/A 20 (24.02.17).
21 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: ACOSTA PUERTAS SERGIO MIGUEL. Datos registrales. T 3909 , F 224, S 8, H SE 56961, I/A 19 (7.02.17).
02 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: DURAN VAZQUEZ ENRIQUE;FERNANDEZ TEJADA NICOLAS;YANES LUQUE FRANCISCO.Nombramientos. Apo.Sol.: ACOSTA PUERTAS SERGIO;LAMOTHE GARCIA JORGE FRANCISCO;DURAN VAZQUEZENRIQUE;GARCIA FACIABEN JORGE. Datos registrales. T 3909 , F 223, S 8, H SE 56961, I/A 18 (24.11.16).
12 de Septiembre de 2016Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3909 , F 222, S 8, H SE 56961, I/A 17 (23.08.16).
24 de Julio de 2015Reelecciones. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 3909 , F 222, S 8, H SE 56961, I/A 16 (15.07.15).
02 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 3909 , F 222, S 8, H SE 56961, I/A 15 (21.08.14).
14 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MMC CENTRO AUTOMOCION SEVILLA SA. Nombramientos. Adm. Unico: CONQUERO IC SL.Datos registrales. T 3909 , F 221, S 8, H SE 56961, I/A 14 ( 2.04.14).
20 de Agosto de 2013Reelecciones. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 3909 , F 221, S 8, H SE 56961, I/A 13 ( 8.08.13).
14 de Septiembre de 2012Reelecciones. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 3909 , F 220, S 8, H SE 56961, I/A 12 ( 4.09.12).
06 de Septiembre de 2011Reelecciones. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 3909 , F 220, S 8, H SE 56961, I/A 11 (22.08.11).
30 de Mayo de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: CONQUERO IC SL. Datos registrales. T 3909 , F 220, S 8, H SE56961, I/A 10 (17.05.11).
01 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: RANGEL PEREZ JOSE. Nombramientos. Apo.Manc.: DURAN VAZQUEZ ENRIQUE;FERNANDEZTEJADA NICOLAS;YANES LUQUE FRANCISCO. Datos registrales. T 3909 , F 219, S 8, H SE 56961, I/A 9 (19.11.10).
18 de Marzo de 2009Reelecciones. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 3909 , F 219, S 8, H SE 56961, I/A 8 (26.02.09).