Buscador CIF Logo

Actos BORME Koipe Corporacion Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Koipe Corporacion Sl

Actos BORME Koipe Corporacion Sl - B20392734

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Koipe Corporacion Sl con CIF B20392734

馃敊 Perfil de Koipe Corporacion Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Koipe Corporacion Sl

11 de Octubre de 2011
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 28089 , F 190, S 8, H M 506157, I/A 6 (29.09.11).

28 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: CARBO FERNANDEZJAIME. Datos registrales. T 28089 , F 190, S 8, H M 506157, I/A 5 (14.04.11).

24 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: QUEROL SANCHO JOSE. Secretario: QUEROL SANCHO JOSE. Consejero: MURIEL JIMENEZJOSE MANUEL. Presidente: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Consejero: REDONDO SANCHEZ DE RON CARLOS.Con.Delegado: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: MURIEL JIMENEZ JOSEMANUEL;LANDAZURI PALACIOS JUAN JOSE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores mancomunados. Otros conceptos: POR ACUERDO DE LA JUNTA DEL 5 DE NOVIEMBRE DE2010, SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 13潞, 19潞, 20潞, 22潞, 23潞, 24潞 Y 25潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T28089 , F 189, S 8, H M 506157, I/A 4 (15.12.10).

08 de Noviembre de 2010
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: OLIVARES DE AFRODITA SL. OLIVARES DE APOLO SL. OLIVARES DEARTEMISA SL. OLIVARES DE ATENEA SL. OLIVARES DE CRONOS SL. OLIVARES DE HADES SL. OLIVARES DE HEFESTO SL.OLIVARES DE HERA SL. OLIVARES DE HERMES SL. OLIVARES DE PERSEFONE SL. OLIVARES DE POSEIDON SL. OLIVARESDE ZEUS SL. TIERRAS DE ANDROMEDA SL. TIERRAS DE AQUARIUS SL. TIERRAS DE CASIOPEA SL. TIERRAS DE CENTAUROSL. TIERRAS DE HERCULES SL. TIERRAS DE JUPITER SL. TIERRAS DE LIBRA SL. TIERRAS DE MERCURIO SL. TIERRAS DENEPTUNO SL. TIERRAS DE ORION SL. TIERRAS DE PEGASO SL. TIERRAS DE PLUTON SL. TIERRAS DE SATURNO SL.TIERRAS DE URANO SL. TIERRAS DE VENUS SL. Datos registrales. T 28089 , F 182, S 8, H M 506157, I/A 3 (26.10.10).

14 de Octubre de 2010
Cambio de domicilio social. C/ MARIE CURIE 7 - EDIFICIO BETA, PARQUE EMPRESARI (RIVAS-VACIAMADRID). Datosregistrales. T 28089 , F 182, S 8, H M 506157, I/A 2 ( 1.10.10).

17 de Junio de 2010
Revocaciones. Apoderado: FABO ILLARRAMENDI ANA. Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ DEL CAMPO FERNANDO. Datosregistrales. T 2067 , F 191, S 8, H SS 2371, I/A 45 ( 7.06.10).

Revocaciones. Apo.Sol.: MICHELENA MICHELENA JAVIER. Apoderado: MICHELENA MICHELENA JAVIER. Datos registrales. T2067 , F 191, S 8, H SS 2371, I/A 46 ( 7.06.10).

16 de Junio de 2010
Revocaciones. Apoderado: MUNGUIA ARSUAGA JAVIER. Nombramientos. Apoderado: MUNGUIA ARSUAGA JAVIER. Datosregistrales. T 2067 , F 191, S 8, H SS 2371, I/A 42 ( 7.06.10).

25 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: REDONDO SANCHEZ DE RON CARLOS;PUEBLA PASCUAL JOSE JAVIER. Datos registrales. T 2067, F 190, S 8, H SS 2371, I/A 42 (16.02.10).

Nombramientos. Apo.Manc.: MOLINA PRADO JERONIMO;PUEBLA PASCUAL JOSE JAVIER. Datos registrales. T 2067 , F 190, S8, H SS 2371, I/A 43 (16.02.10).

24 de Febrero de 2010
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SALGADO SOCIEDAD ANONIMA UNION COMERCIAL ACEITERA. MEDEOLSERVICES SL. KOPINVER SA. PLATAFORMA PROYECTO TIERRA SL. Datos registrales. T 2067 , F 188, S 8, H SS 2371, I/A 41(15.02.10).

18 de Diciembre de 2009
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SOS CORPORACION ALIMENTARIA SA. Datos registrales. T 2067 , F 188, S 8, HSS 2371, I/A 40 ( 9.12.09).

03 de Diciembre de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: MORILLO CACERES ANTONIO;MORILLO CACERES ANTONIO;ROJO GOMEZ MONEDEROEUGENIO. Datos registrales. T 2067 , F 188, S 8, H SS 2371, I/A 39 (24.11.09).

23 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LANDAZURI PALACIOS JUAN JOSE. Datos registrales. T 2067 , F 188, S 8, H SS 2371, I/A 37 (9.11.09).

18 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Con.Delegado: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2067 , F 186, S 8, H SS 2371, I/A 35 (9.11.09).

Nombramientos. Apoderado: REDONDO SANCHEZ DE RON CARLOS. Datos registrales. T 2067 , F 187, S 8, H SS 2371, I/A 36 (9.11.09).

Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ AGUIRRE ENDIKA. Datos registrales. T 2067 , F 188, S 8, H SS 2371, I/A 37 ( 9.11.09).

16 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2067 , F 185, S 8, H SS 2371, I/A 34 ( 4.11.09).

13 de Noviembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: SANCHEZ AGUIRRE ENDIKA. Datos registrales. T 2067 , F 185, S 8, H SS 2371, I/A 33 ( 3.11.09).

01 de Octubre de 2009
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: SALAZAR BELLO JESUS IGNACIO. Presidente: SALAZAR BELLO JESUS IGNACIO. Consejero:SALAZAR BELLO JESUS IGNACIO. Cons.Del.Sol: SALAZAR BELLO RAUL JAIME. Consejero: SALAZAR BELLO RAUL JAIME.Nombramientos. Consejero: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Presidente: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Consejero:REDONDO SANCHEZ DE RON CARLOS. Datos registrales. T 2067 , F 184, S 8, H SS 2371, I/A 31 (21.09.09).

Nombramientos. Apo.Manc.: REDONDO SANCHEZ DE RON CARLOS. Datos registrales. T 2067 , F 185, S 8, H SS 2371, I/A 32(21.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n