Actos BORME de Korta Sociedad Anonima
31 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ MOLINA VICENTE. Datos registrales. T 2333 , F 99, S 8, H SS 2448, I/A 30 (19.12.19).
09 de Agosto de 2018Revocaciones. Apoderado: AZCUE ARRASTOA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 2333 , F 99, S 8, H SS 2448, I/A 29 (30.07.18).
26 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: KORTA ZEARRETA ANDOITZ;KORTA ESNAL MIKEL;CORTA CENDOYA ALEXANDER;CORTAURANGA JOSE JAVIER. Secretario: KORTA ZEARRETA ANDOITZ. Con.Delegado: KORTA ZEARRETA ANDOITZ. Presidente:CORTA URANGA JOSE JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: KORTA INVERSIONES SL. Otros conceptos: Cambio del Organode Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Modificaci贸n de los art铆culos 11潞 y 20潞 de los Estatutos sociales,referentes al Oragno de Administraci贸n. Datos registrales. T 1112 , F 77, S 8, H SS 2448, I/A 28 (19.04.18).
14 de Diciembre de 2017Reelecciones. Consejero: KORTA ZEARRETA ANDOITZ. Secretario: KORTA ZEARRETA ANDOITZ. Con.Delegado: KORTAZEARRETA ANDOITZ. Datos registrales. T 1112 , F 77, S 8, H SS 2448, I/A 27 (22.11.17).
11 de Octubre de 2017Nombramientos. Auditor: CAZENAVE ZARANDONA AMADEO. Aud.Supl.: ARRUABARRENA ECHAVE PEDRO-JOSE. Datosregistrales. T 1112 , F 77, S 8, H SS 2448, I/A 26 ( 2.10.17).
14 de Julio de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: KORTA INVERSIONES SL. Datos registrales. T 1112 , F 77, S 8, H SS 2448, I/A25 ( 3.07.17).
13 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: CORTA URANGA NARCISO;CORTA URANGA CANDIDO. Presidente: CORTA URANGA CANDIDO.Nombramientos. Consejero: CORTA CENDOYA ALEXANDER;KORTA ESNAL MIKEL. Presidente: CORTA URANGA JOSE JAVIER.Datos registrales. T 1112 , F 76, S 8, H SS 2448, I/A 24 ( 3.02.17).
06 de Abril de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 115.710,53 Euros. Resultante Suscrito: 136.727,50 Euros. Datos registrales. T 1112 , F76, S 8, H SS 2448, I/A 23 (23.03.15).
16 de Diciembre de 2014Nombramientos. Auditor: CAZENAVE ZARANDONA AMADEO. Aud.Supl.: ARRUABARRENA ECHAVE PEDRO-JOSE. Datosregistrales. T 1112 , F 76, S 8, H SS 2448, I/A 22 ( 3.12.14).
21 de Noviembre de 2014Nombramientos. Consejero: CORTA URANGA JOSE JAVIER. Datos registrales. T 1112 , F 76, S 8, H SS 2448, I/A 21 (14.11.14).
04 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: AZCUE ARRASTOA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 1112 , F 75, S 8, H SS 2448, I/A 20 (19.08.14).
28 de Mayo de 2013Reelecciones. Auditor: CAZENAVE ZARANDONA AMADEO. Aud.Supl.: ARRUABARRENA ECHAVE PEDRO-JOSE. Datosregistrales. T 1112 , F 75, S 8, H SS 2448, I/A 19 (21.05.13).
03 de Mayo de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: CORTA CENDOYA ALEXANDER. Datos registrales. T 1112 , F 74, S 8, H SS 2448, I/A 18 (23.04.13).
26 de Abril de 2013Reelecciones. Consejero: KORTA ZEARRETA ANDOITZ;CORTA URANGA CANDIDO;CORTA URANGA NARCISO. Presidente:CORTA URANGA CANDIDO. Secretario: KORTA ZEARRETA ANDOITZ. Con.Delegado: KORTA ZEARRETA ANDOITZ. Datos
10 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: CORTA URANGA CANDIDO. Datos registrales. T 1112 , F 74, S 8, H SS 2448, I/A 15(29.12.10).
Nombramientos. Apoderado: KORTA ZEARRETA IBAI. Datos registrales. T 1112 , F 74, S 8, H SS 2448, I/A 16 (29.12.10).
23 de Junio de 2010Nombramientos. Auditor: CAZENAVE ZARANDONA AMADEO. Aud.Supl.: ARRUABARRENA ECHAVE PEDRO-JOSE. Datosregistrales. T 1112 , F 74, S 8, H SS 2448, I/A 14 (15.06.10).