Actos BORME de Kostova Systems Sl
07 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: ALEJANDRO BALET SUSANA. Secretario: ALEJANDRO BALET SUSANA. Consejero: ALEJANDROBALET ANGEL RAMON. Presidente: ALEJANDRO BALET ANGEL RAMON. Consejero: GASCON MU脩IO PEDRO-JOSE;BERNIOLABENITA FERNANDO EUDALDO. Revocaciones. Apo.Sol.: GASCON MU脩IO PEDRO-JOSE;FRANCA GARCES MARIA PILAR;TILAISA JOSE RAMON;CARDONA MALFEY CRISTINA;RIVERA FORCEN JOSE-MARIA;ALEJANDRO BALET SUSANA;GASCONMU脩IO PEDRO-JOSE;MANCHOLAS LORENTE CARLOS;BALET SIERRA MARIO;BALET SALA CARMEN. Apo.Manc.: ALEJANDROBALET SUSANA;GASCON MU脩IO PEDRO-JOSE;MANCHOLAS LORENTE CARLOS;BALET SIERRA MARIO;BALET SALACARMEN. Apo.Sol.: BERNIOLA BENITA FERNANDO EUDALDO. Apo.Manc.: ASIN MILLERA RAFAEL;BERNIOLA BENITAFERNANDO EUDALDO;SAUVAGE TORRENS LIONEL;BENITO PEREZ YOLANDA. Apo.Sol.: BALET SALA CARMEN;RIVERAFORCEN JOSE-MARIA;ASIN MILLERA RAFAEL. Apoderado: VICENTE PLOU ELENA. Apo.Sol.: BENITO PEREZYOLANDA;SAUVAGE TORRENS LIONEL. Apo.Manc.: ALEJANDRO BALET SUSANA;BENITO PEREZ YOLANDA;GASCON MU脩IOPEDRO-JOSE;MANCHOLAS LORENTE CARLOS;SAUVAGE TORRENS LIONEL. Apoderado: GOMEZ ZAVALA JOSEIGNACIO;GARCIA CASANOVA RAQUEL. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 4221 , F 58, S 8, H Z 41502, I/A 30(30.10.17).
19 de Abril de 2017Revocaciones. Apoderado: NAVARRO ZAMORA EDUARDO. Datos registrales. T 4221 , F 58, S 8, H Z 41502, I/A 29 (10.04.17).
21 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: ASIN MILLERA RAFAEL. Datos registrales. T 4221 , F 58, S 8, H Z 41502, I/A 28 (13.02.17).
16 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: GOMEZ ZAVALA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 4051 , F 224, S 8, H Z 41502, I/A 26 (7.12.16).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA CASANOVA RAQUEL. Datos registrales. T 4051 , F 225, S 8, H Z 41502, I/A 27 ( 7.12.16).
13 de Julio de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: BENITO PEREZ YOLANDA;SAUVAGE TORRENS LIONEL. Apo.Manc.: ALEJANDRO BALETSUSANA;BENITO PEREZ YOLANDA;GASCON MU脩IO PEDRO-JOSE;MANCHOLAS LORENTE CARLOS;SAUVAGE TORRENSLIONEL. Datos registrales. T 4051 , F 222, S 8, H Z 41502, I/A 25 ( 1.07.16).
02 de Junio de 2016Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 6 - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES. A) Transmisiones voluntarias poractos inter vivos.- Ser谩 libre toda transmisi贸n de participaciones sociales realizadas por actos inter vivos, tanto a t铆tulo oneroso comogratuito, a favor de otros socios de la Sociedad o a favor de sociedades. Datos registrales. T 4051 , F 221, S 8, H Z 41502, I/A 24(24.05.16).
14 de Septiembre de 2015Nombramientos. Consejero: BERNIOLA BENITA FERNANDO EUDALDO. Datos registrales. T 3814 , F 221, S 8, H Z 41502, I/A 22( 4.09.15).
Nombramientos. Apoderado: VICENTE PLOU ELENA. Datos registrales. T 3814 , F 221, S 8, H Z 41502, I/A 23 ( 4.09.15).
01 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ CAMPOS ALBERTO. Presidente: GONZALEZ CAMPOS ALBERTO. Consejero:RECOVERY ESPA脩OLA 21 SL. Vicepresid.: RECOVERY ESPA脩OLA 21 SL. Consejero: SHERPA DESARROLLO SL. Secretario:SHERPA DESARROLLO SL. Con.Delegado: SHERPA DESARROLLO SL. Nombramientos. Consejero: ALEJANDRO BALETSUSANA. Secretario: ALEJANDRO BALET SUSANA. Consejero: ALEJANDRO BALET ANGEL RAMON. Presidente: ALEJANDROBALET ANGEL RAMON. Consejero: GASCON MU脩IO PEDRO-JOSE. Datos registrales. T 3814 , F 220, S 8, H Z 41502, I/A 14(20.08.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: ASIN MILLERA RAFAEL. Apoderado: GONZALEZ CAMPOS ALBERTO. Apo.Manc.: BERNIOLA BENITOFERNANDO-EDUALDO;VICENTE PLOU ELENA. Datos registrales. T 3814 , F 220, S 8, H Z 41502, I/A 15 (20.08.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALEJANDRO BALET SUSANA;GASCON MU脩IO PEDRO-JOSE;MANCHOLAS LORENTECARLOS;BALET SIERRA MARIO;BALET SALA CARMEN. Apo.Manc.: ALEJANDRO BALET SUSANA;GASCON MU脩IO PEDRO-JOSE;MANCHOLAS LORENTE CARLOS;BALET SIERRA MARIO;BALET SALA CARMEN. Datos registrales. T 3814 , F 220, S 8, HZ 41502, I/A 16 (20.08.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: ASIN MILLERA RAFAEL;BERNIOLA BENITA FERNANDO EUDALDO. Apo.Manc.: ASIN MILLERARAFAEL;BERNIOLA BENITA FERNANDO EUDALDO;SAUVAGE TORRENS LIONEL;BENITO PEREZ YOLANDA. Datos registrales.T 3814 , F 222, S 8, H Z 41502, I/A 17 (20.08.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: GASCON MU脩IO PEDRO-JOSE;FRANCA GARCES MARIA PILAR. Datos registrales. T 3814 , F 224,S 8, H Z 41502, I/A 18 (20.08.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: TIL AISA JOSE RAMON. Datos registrales. T 3814 , F 224, S 8, H Z 41502, I/A 19 (20.08.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: CARDONA MALFEY CRISTINA;RIVERA FORCEN JOSE-MARIA. Datos registrales. T 3814 , F 225, S8, H Z 41502, I/A 20 (20.08.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: BALET SALA CARMEN;RIVERA FORCEN JOSE-MARIA;ASIN MILLERA RAFAEL. Datos registrales. T3814 , F 225, S 8, H Z 41502, I/A 21 (20.08.15).
05 de Noviembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 100.004,24 Euros. Resultante Suscrito: 152.528,74 Euros. Datos registrales. T 3814 , F 220, S 8, HZ 41502, I/A 13 (27.10.14).
12 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: NAVARRO ZAMORA EDUARDO;BRU TABERNERO ALFREDO. Vicepresid.: NAVARRO ZAMORAEDUARDO. Secretario: BRU TABERNERO ALFREDO. Cons.Del.Sol: BRU TABERNERO ALFREDO. Nombramientos. Consejero:RECOVERY ESPA脩OLA 21 SL. Vicepresid.: RECOVERY ESPA脩OLA 21 SL. Consejero: SHERPA DESARROLLO SL. Secretario:SHERPA DESARROLLO SL. Con.Delegado: SHERPA DESARROLLO SL. Modificaciones estatutarias. "Art铆culo 11潞.- El cargo deAdministrador no ser谩 retribuido. No obstante, si alguno de los administradores prestase a la sociedad servicios por cargos para losque hubiere sido nombrado o por trabajos profesionales o de cualquier otra 铆ndole que en la misma realice, la remuneraci贸n que poreste. Datos registrales. T 3814 , F 219, S 8, H Z 41502, I/A 12 ( 4.04.13).
01 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: NAVARRO ZAMORA EDUARDO. Datos registrales. T 3404 , F 78, S 8, H Z 41502, I/A 11 (21.05.12).
08 de Marzo de 2012Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL MALPICA, CALLE E, PARCELA 68 (ZARAGOZA). Datos registrales. T 3404 , F78, S 8, H Z 41502, I/A 10 (27.02.12).
21 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ CAMPOS ALBERTO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ CAMPOS ALBERTO.Presidente: GONZALEZ CAMPOS ALBERTO. Consejero: NAVARRO ZAMORA EDUARDO. Vicepresid.: NAVARRO ZAMORAEDUARDO. Consejero: BRU TABERNERO ALFREDO. Secretario: BRU TABERNERO ALFREDO. Cons.Del.Sol: BRU TABERNEROALFREDO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n.Datos registrales. T 3404 , F 77, S 8, H Z 41502, I/A 7 ( 9.03.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: ASIN MILLERA RAFAEL;BERNIOLA BENITO FERNANDO-EDUALDO;VICENTE PLOU ELENA. Datosregistrales. T 3404 , F 77, S 8, H Z 41502, I/A 8 ( 9.03.11).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CAMPOS ALBERTO. Datos registrales. T 3404 , F 78, S 8, H Z 41502, I/A 9 ( 9.03.11).
31 de Diciembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 31.514,70 Euros. Resultante Suscrito: 52.524,50 Euros. Modificaciones estatutarias. "ARTICULO8潞. CONVOCATRIA DE LAS JUNTAS. La Junta General decidir谩, por la mayor铆a estatutariamente establecida, en los asuntos propiode su competencia. Dicha competencia, as铆a como la forma y contenido de la convocatoria, lugar de celebraci贸n, especialidad de laJunta Universal, asistencia y. Datos registrales. T 3404 , F 76, S 8, H Z 41502, I/A 6 (20.12.10).